CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED

CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02595181
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED?

    • fabbricazione di altri prodotti in plastica (22290) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Cedo
    Halesfield 11
    TF7 4LZ Telford
    Shropshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    P L HOLDINGS LIMITED23 lug 199123 lug 1991
    ADVISER (185) LIMITED25 mar 199125 mar 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Helen Catherine Allum come amministratore in data 03 ott 2019

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 dic 2019 al 30 dic 2019

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 apr 2019 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 07 nov 2018

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account. 06/11/2018
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 05 nov 2018

    • Capitale: GBP 6,582,757
    3 pagineSH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 apr 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Helen Catherine Allum il 20 nov 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrzej Rafal Ostrowski il 12 dic 2017

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Mrs Helen Catherine Allum come amministratore in data 03 ott 2016

    2 pagineAP01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 apr 2016

    Stato del capitale al 01 apr 2016

    • Capitale: GBP 6,051,757
    SH01

    Cessazione della carica di David James Pearce come amministratore in data 19 feb 2016

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    13 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 gen 2016

    Stato del capitale al 12 gen 2016

    • Capitale: GBP 6,051,757
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    17 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OSTROWSKI, Andrzej Rafal
    Halesfield 11
    TF7 4LZ Telford
    Cedo
    Shropshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Halesfield 11
    TF7 4LZ Telford
    Cedo
    Shropshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish195252290003
    FERGUSON, Donald Alexander Hall
    54 Greenway
    Southgate
    N14 6NS London
    Segretario
    54 Greenway
    Southgate
    N14 6NS London
    British65742890001
    MURRAY, Sylvia Joan
    45 Newlands Road
    IG8 0RS Woodford Green
    Essex
    Segretario
    45 Newlands Road
    IG8 0RS Woodford Green
    Essex
    British58353930001
    OSTROWSKI, Andrzej Rafal
    Halesfield 11
    Telford
    TF7 4LZ Shropshire
    Segretario
    Halesfield 11
    Telford
    TF7 4LZ Shropshire
    Polish130241980001
    MBC SECRETARIES LIMITED
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    Segretario nominato
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    900000700001
    TSD NOMINEES LIMITED
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    Segretario nominato
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    900007440001
    ALLUM, Helen Catherine
    Halesfield 11
    TF7 4LZ Telford
    Cedo
    Shropshire
    Amministratore
    Halesfield 11
    TF7 4LZ Telford
    Cedo
    Shropshire
    United KingdomBritish80472920003
    BURLEY, Jeremiah
    Maryfield High Street
    Taplow
    SL6 0EX Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Maryfield High Street
    Taplow
    SL6 0EX Maidenhead
    Berkshire
    British29315500001
    BUTT, Stephen Andrew
    Lacon Crest Lacon Street
    Prees
    SY13 2EP Whitchurch
    Shropshire
    Amministratore
    Lacon Crest Lacon Street
    Prees
    SY13 2EP Whitchurch
    Shropshire
    British24813290002
    CASWELL, Christopher John
    4 The Dovecotes
    B75 5DN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    4 The Dovecotes
    B75 5DN Sutton Coldfield
    West Midlands
    British85349980001
    CLAUSEN-BRUUN, Soren
    8 Deards End Lane
    SG3 6NL Knebworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    8 Deards End Lane
    SG3 6NL Knebworth
    Hertfordshire
    United KingdomDanish24813300004
    FERGUSON, Donald Alexander Hall
    67 New Road
    AL6 0AL Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    67 New Road
    AL6 0AL Welwyn
    Hertfordshire
    EnglandBritish65742890002
    FERGUSON, Donald Alexander Hall
    54 Greenway
    Southgate
    N14 6NS London
    Amministratore
    54 Greenway
    Southgate
    N14 6NS London
    British65742890001
    GOESEKE, Christian, Dr
    Bregenzer Str 3
    FOREIGN Berlin
    10707
    Germany
    Amministratore
    Bregenzer Str 3
    FOREIGN Berlin
    10707
    Germany
    GermanyGerman277601760001
    HOEM, Bjorn Arild
    Kraden Puhl 68
    Leichlingen
    D42799
    Amministratore
    Kraden Puhl 68
    Leichlingen
    D42799
    German94300520001
    HOEM, Bjorn Arild
    30 Upland Drive
    Brookmans Park
    AL9 6PT Hatfield
    Hertfordshire
    Amministratore
    30 Upland Drive
    Brookmans Park
    AL9 6PT Hatfield
    Hertfordshire
    German13653590002
    HOHMANN, Helmut Wilhelm Oswald, Dr
    Elmstein
    Helmbach 16
    Helmbach 16
    Germany
    Amministratore
    Elmstein
    Helmbach 16
    Helmbach 16
    Germany
    German71899360001
    HUMPHREYS, Peter
    Chestnut House
    Mawsons Mead
    CF5 6SX St Nicholas
    Vale Of Glamorgan
    Amministratore
    Chestnut House
    Mawsons Mead
    CF5 6SX St Nicholas
    Vale Of Glamorgan
    WalesBritish159765430001
    JAKEMAN, Arthur Leslie
    Garnhill Sandford Avenue
    SY6 7AE Church Stretton
    Salop
    Amministratore
    Garnhill Sandford Avenue
    SY6 7AE Church Stretton
    Salop
    British6844230001
    JAMIESON, Alan Rae Dalziel
    Halesfield 11
    Telford
    TF7 4LZ Shropshire
    Amministratore
    Halesfield 11
    Telford
    TF7 4LZ Shropshire
    EnglandBritish31138330004
    LANGAN, James Anthony
    Halesfield 11
    Telford
    TF7 4LZ Shropshire
    Amministratore
    Halesfield 11
    Telford
    TF7 4LZ Shropshire
    United KingdomBritish161934440001
    MCCOMASKY, James Anthony
    Halesfield 11
    Telford
    TF7 4LZ Shropshire
    Amministratore
    Halesfield 11
    Telford
    TF7 4LZ Shropshire
    EnglandBritish148271070001
    MORGAN, Jonathan Windsor
    51 Castelnau
    Barnes
    SW13 9RT London
    Amministratore
    51 Castelnau
    Barnes
    SW13 9RT London
    British10387190002
    NAKHLA, Karim Paul
    Swan Hill Court House
    Swan Hill
    SY1 1NP Shrewsbury
    Amministratore
    Swan Hill Court House
    Swan Hill
    SY1 1NP Shrewsbury
    EnglandBritish6844240002
    OSTROWSKI, Andrzej Rafal
    Kyffhauserstrasse
    Monchengladbach
    27/2
    Amministratore
    Kyffhauserstrasse
    Monchengladbach
    27/2
    GermanyPolish130241980001
    PEARCE, David James
    Halesfield 11
    TF7 4LZ Telford
    Cedo
    Shropshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Halesfield 11
    TF7 4LZ Telford
    Cedo
    Shropshire
    United Kingdom
    Great BritainBritish146723580001
    TROMEL, Frank, Dr
    Gunther-Quandt-Haus
    Seedamnweg 55
    61352 Bad Homburg
    Germany
    Amministratore
    Gunther-Quandt-Haus
    Seedamnweg 55
    61352 Bad Homburg
    Germany
    German48305810001
    TURNER, Matthew Charles
    Springfield Hall
    Star Lane Knowl Hill
    RG10 9UR Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Springfield Hall
    Star Lane Knowl Hill
    RG10 9UR Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish115927000001
    WAGNER, Antonius Hugo, Dr
    Pater Dietrich Ring 34
    46286 Dorsten Rhade
    Germany
    Amministratore
    Pater Dietrich Ring 34
    46286 Dorsten Rhade
    Germany
    German82010470001
    WILKENS, Michael Diederich
    Am Amburger Berg 4
    D61350 Bad Homburg
    Germany
    Amministratore
    Am Amburger Berg 4
    D61350 Bad Homburg
    Germany
    German48455880001
    WINTER, Berndt Michael
    Mariannenweg 12
    D-61348 Bad Homburg Vdh
    FOREIGN Germany
    Amministratore
    Mariannenweg 12
    D-61348 Bad Homburg Vdh
    FOREIGN Germany
    German64461820001
    WOOD, William Brian
    5 Bowood Drive
    Tettehall
    WV6 9AW Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    5 Bowood Drive
    Tettehall
    WV6 9AW Wolverhampton
    West Midlands
    British79645330001
    ZAPKA-VOLKMANN, Heike-Anja
    Martinstrasse 14
    Wiesbaden
    65189
    Germany
    Amministratore
    Martinstrasse 14
    Wiesbaden
    65189
    Germany
    German93015070001
    MBC NOMINEES LIMITED
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    Amministratore delegato nominato
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    900000690001
    TSD NOMINEES LIMITED
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    Amministratore delegato nominato
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    900007440001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    01 apr 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture deed
    Creato il 31 gen 2013
    Consegnato il 05 feb 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 feb 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 28 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Non-receivables accession deed
    Creato il 16 set 2009
    Consegnato il 24 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its property assets and undertaking on the terms set out in clauses 3 (grant of security), 4 (fixed security) and 5 (floating charge) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited (The Security Agent)
    Transazioni
    • 24 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 24 giu 1991
    Consegnato il 27 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 27 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 01 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of off set
    Creato il 14 giu 1991
    Consegnato il 20 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in the name of advisor (185) limited.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 01 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 giu 1991
    Consegnato il 19 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 21 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0