FIBROWATT LIMITED
Panoramica
| Nome della società | FIBROWATT LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02595814 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di FIBROWATT LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova FIBROWATT LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 6th Floor 33 Holborn EC1N 2HT London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di FIBROWATT LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per FIBROWATT LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 025958140017 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 apr 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Octopus Company Secretarial Services Limited come segretario in data 15 nov 2018 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sharna Ludlow come segretario in data 15 nov 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Stephen Latham il 07 set 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 025958140017, creata il 23 lug 2018 | 54 pagine | MR01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 apr 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Kamalika Ria Banerjee come segretario in data 19 feb 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Kamalika Ria Banerjee come segretario in data 30 ott 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr Paul Stephen Latham come amministratore in data 15 ago 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Matthew George Setchell il 20 feb 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Tim James Senior come amministratore in data 06 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata 6th Floor 33 Holborn London England EC1N 2HT | 2 pagine | AD04 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Sharna Ludlow il 31 mag 2016 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Nomina di Sharna Ludlow come segretario in data 06 mag 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Karen Ward come segretario in data 06 mag 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 26 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 6 Deben Mill Business Centre Old Maltings Approach Woodbridge Suffolk IP12 1BL a 6th Floor 33 Holborn London England EC1N 2HT in data 01 apr 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di FIBROWATT LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTOPUS COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | Holborn EC1N 2HT London 33 England England |
| 253893850001 | ||||||||||
| LATHAM, Paul Stephen | Amministratore | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England | United Kingdom | British | 146527710002 | |||||||||
| SETCHELL, Matthew George | Amministratore | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England | England | British | 157021230004 | |||||||||
| WILKINSON, Edwin John | Amministratore | Deben Mill Business Centre Old Maltings Approach IP12 1BL Woodbridge 6 Suffolk United Kingdom | England | British | 86926370001 | |||||||||
| BANERJEE, Kamalika Ria | Segretario | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | 239579580001 | |||||||||||
| DAVISON, James Edward | Segretario | 20a Spratt Hall Road E11 2RQ London | British | 74915120001 | ||||||||||
| FRASER, Archibald Ian Charles | Segretario | 70 St Dionis Road SW6 4TU London | British | 54887300001 | ||||||||||
| FRASER, Rupert James | Segretario | 98 Clarendon Drive SW15 1AH London | British | 25747380001 | ||||||||||
| HELPS, Annabelle Penney | Segretario | 112 Cromwell Tower Barbican EC2Y 8DD London | Australian | 81687520005 | ||||||||||
| LUDLOW, Sharna | Segretario | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | 208085010001 | |||||||||||
| PICTON TURBERVILL, David | Segretario | 8 Kingswood Rise Four Marks GU34 5BD Alton Hampshire | British | 87719670002 | ||||||||||
| WARD, Karen | Segretario | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | 204126870001 | |||||||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Segretario | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 60471940015 | |||||||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Segretario | Central Square South Orchard Street NE1 3XX Newcastle Upon Tyne | 60471940007 | |||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| ANTHONY, Paul | Amministratore | Wentworth House St Leonards Hill SL4 4AT Windsor Berkshire | British | 81406540001 | ||||||||||
| APPS, Paul Gordon | Amministratore | 1 Pointers Close Chieveley RG20 8UJ Newbury Berkshire | British | 88199170001 | ||||||||||
| BOVATI, Paolo | Amministratore | Piazza 5 Agostino 5 FOREIGN Milan 20153 Italy | Italian | 74743800001 | ||||||||||
| CHILTON, Malcolm David | Amministratore | 20 Prosper Meadow DY6 8BA Kingswinford West Midlands | United Kingdom | British | 145829100001 | |||||||||
| COLOMBO, Achille | Amministratore | Via Cortivo 41 Castagnola Ticino 6976 Switzerland | Swiss | 85487490001 | ||||||||||
| COLOMBO, Mario Carlo | Amministratore | Via Solferino 23 Brescia Brescia 25122 Italy | Italian | 81675680001 | ||||||||||
| CONSTANT, Richard Ashley Meyricke | Amministratore | Park Lodge Aislaby YO1 1SW Whitby Yorkshire | British | 19600420001 | ||||||||||
| EVERARD, Ian Douglas | Amministratore | 50 Shoreswood BL1 7DD Bolton Lancashire | British | 28193080001 | ||||||||||
| FRASER, Elspeth Jane | Amministratore | 38 Clarendon Road W11 3AD London | British | 11543170001 | ||||||||||
| FRASER, Elspeth Jane | Amministratore | 38 Clarendon Road W11 3AD London | British | 11543170001 | ||||||||||
| FRASER, Perdita Rachel Josephine | Amministratore | 4 Alexander Street W2 5NT London | England | British | 179346590001 | |||||||||
| FRASER, Rupert James | Amministratore | 98 Clarendon Drive SW15 1AH London | England | British | 25747380001 | |||||||||
| FRASER, Simon Joseph | Amministratore | 38 Clarendon Road W11 3AD London | United Kingdom | British | 15057410001 | |||||||||
| GIACOBELLI, Fabrizio | Amministratore | Via Piave 17 Rescaldina 20027 Milano Italia | Italian | 54917260001 | ||||||||||
| GULLIVER, Peter Leslie | Amministratore | 1 Warren Road Woodley RG5 3AP Reading Berkshire | British | 38491630001 | ||||||||||
| GULLIVER, Peter Leslie | Amministratore | 1 Warren Road Woodley RG5 3AP Reading Berkshire | British | 38491630001 | ||||||||||
| HOLDSWORTH, John Clifford | Amministratore | 9 The Grange Shepherds Lane Caversham RG4 7HZ Reading Berkshire | British | 59930780001 | ||||||||||
| HOLT, Nicholas Christopher | Amministratore | 5 High Park Road TW9 4BL Richmond Upon Thames Surrey | British | 10758310002 | ||||||||||
| KAY, Ian Andrew | Amministratore | 17 Jenner Street Seaforth New South Wales 2092 Australia | British | 102259090001 | ||||||||||
| KING, William John | Amministratore | The Old Laundry Little Horwood MK17 0PG Milton Keynes Buckinghamshire | England | British | 74570800001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di FIBROWATT LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Power Resources Limited | 06 apr 2016 | 33 Holborn EC1N 2HT London 6th Floor England England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
FIBROWATT LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 23 lug 2018 Consegnato il 30 lug 2018 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione None. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 30 set 2005 Consegnato il 19 ott 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the counterparty to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 30 set 2005 Consegnato il 07 ott 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the borrower and the company to the chargee whether for its own account or as trustee for the secured parties or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Creato il 28 set 2000 Consegnato il 06 ott 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Barclays bank PLC re fibrowatt limited business premisum account number 90106941. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assignment | Creato il 17 lug 1997 Consegnato il 21 lug 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with a share purchase agreement dated 19TH april 1996, as amended by a supplemental agreement dated 12TH august 1996 and by a second supplemental agreement dated 10TH may 1997 | |
Brevi particolari All the company's property in and right to receive all or any sums of money that may be or become payable to the company under or in consequence of the terms of a commissioning fee agreement dated 14TH august 1996 up to a maximum aggregate amount of 8,000,000. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge over securities | Creato il 17 giu 1997 Consegnato il 19 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement dated 16TH march 1992 or pursuant to the debenture (as defined in the deed) | |
Brevi particolari First fixed charge the shares inclusing all dividends interest or other distributions and all allotments accretions offers rights benefits and advantages whatsoever. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge over securities | Creato il 17 giu 1997 Consegnato il 19 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the termsof the facility agreement dated 30TH november 1990 or pursuant to the debenture (as defined in the deed) | |
Brevi particolari First fixed charge over the shares together with any substituted securities inclusive of all dividends interest and other distributions and all allotments accretions offers rights benefits and advantages. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 19 mag 1997 Consegnato il 04 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on the due date therefor and otherwise in accordance with the terms of the relevant loan agreements (as therein defined) and the deed | |
Brevi particolari Fixed charge all "securities" being: all shares in the capital of any subsidiary of the company including all dividends benefits property rights etc, floating charge other than the excluded property (as defined on the M395). Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Third party account charge | Creato il 08 mag 1997 Consegnato il 13 mag 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from fibrowatt thetford limited to the chargee under the marubeni loan agreement dated 8TH may 1997 | |
Brevi particolari Fixed charge over the cash collateral, the account and the debt.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge | Creato il 08 mag 1997 Consegnato il 13 mag 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from fibrowatt thetford limited to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined in the junior loan agreement dated 8TH may 1997) | |
Brevi particolari All right title and interest in shareholding in fibromass limited and fibrowatt thetford limited.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assignment | Creato il 08 mag 1997 Consegnato il 13 mag 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from fibrowatt thetford limited to the chargee pursuant to the finance documents (as defined in the junior loan agreement dated 8TH may 1997) | |
Brevi particolari All right, title and interest in and to the second portion of the commissioning fee( as defined in the deed, and the commissioning fee contract dated 12 august 1996). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Account charge | Creato il 21 ago 1996 Consegnato il 10 set 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the deed of guarantee and indemnity of even date and/or pursuant to clauses 9.1 and 9.2 of the share purchase agreement dated 18TH april 1996 which in either case become due and payable as a result of a failure on the part of fibro holdings limited to pay sums due and payable in accordance with clauses 3.2 (ii) , 3.3 or 3.4 of the share purchase agreement, subject to a maximum amount secured of £500,000 | |
Brevi particolari The deposit referred to in clause 2 (I) of the account charge and any sum or sums (up to a maximum amount of £500,000) which are from time to time deposited in the bank account in the name of fibrowatt with the royal bank of scotland PLC. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assignment | Creato il 21 ago 1996 Consegnato il 10 set 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the deed of guarantee and indemnity of even date and/or pursuant to clauses 9.1 and 9.2 of the share purchase agreement dated 18TH april 1996 which in either case become due and payable as a result of a failure on the part of fibro holdings limited to pay sums due and payable in accordance with clauses 3.2 (ii) , 3.3 or 3.4 of the share purchase agreement, subject to a maximum amount secured of £500,000 | |
Brevi particolari All or any sums of money that may be or become payable to fibrowatt under or in consequence of the terms of the administration services agreement dated 19TH august 1996. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge over securities | Creato il 12 ago 1996 Consegnato il 29 ago 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from fibrowatt thetford limited to the chargee in accordance with the provisions of the finance documents (as defined) | |
Brevi particolari The shares. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Account charge | Creato il 12 ago 1996 Consegnato il 27 ago 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All obligations and liabilities of the company and fibro holdings limited to the chargee under an option agreement dated 12TH august 1996 | |
Brevi particolari The sum of £1 and any other sum or sums which are from time to time deposited in an account with the bank of scotland under account no.0044010. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of floating charge | Creato il 21 mag 1996 Consegnato il 05 giu 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility agreement dated 21ST may 1996 | |
Brevi particolari The undertaking and all other property assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 28 mar 1994 Consegnato il 06 apr 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement dated 28TH march 1994 being that part of the respective liabilities described above which exceeds the principal amount of £500,000 | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0