FIBROWATT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFIBROWATT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02595814
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FIBROWATT LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova FIBROWATT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    6th Floor 33 Holborn
    EC1N 2HT London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di FIBROWATT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per FIBROWATT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 025958140017 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 apr 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Octopus Company Secretarial Services Limited come segretario in data 15 nov 2018

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Sharna Ludlow come segretario in data 15 nov 2018

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018

    4 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Stephen Latham il 07 set 2018

    2 pagineCH01

    Iscrizione dell'ipoteca 025958140017, creata il 23 lug 2018

    54 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 apr 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Kamalika Ria Banerjee come segretario in data 19 feb 2018

    1 pagineTM02

    Nomina di Kamalika Ria Banerjee come segretario in data 30 ott 2017

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Paul Stephen Latham come amministratore in data 15 ago 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Matthew George Setchell il 20 feb 2017

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Tim James Senior come amministratore in data 06 ott 2016

    1 pagineTM01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata 6th Floor 33 Holborn London England EC1N 2HT

    2 pagineAD04

    Dettagli del segretario cambiati per Sharna Ludlow il 31 mag 2016

    1 pagineCH03

    Nomina di Sharna Ludlow come segretario in data 06 mag 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Karen Ward come segretario in data 06 mag 2016

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 26 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 apr 2016

    Stato del capitale al 25 apr 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 6 Deben Mill Business Centre Old Maltings Approach Woodbridge Suffolk IP12 1BL a 6th Floor 33 Holborn London England EC1N 2HT in data 01 apr 2016

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di FIBROWATT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OCTOPUS COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    England
    England
    Segretario
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    England
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione11677818
    253893850001
    LATHAM, Paul Stephen
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    Amministratore
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    United KingdomBritish146527710002
    SETCHELL, Matthew George
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    Amministratore
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    EnglandBritish157021230004
    WILKINSON, Edwin John
    Deben Mill Business Centre
    Old Maltings Approach
    IP12 1BL Woodbridge
    6
    Suffolk
    United Kingdom
    Amministratore
    Deben Mill Business Centre
    Old Maltings Approach
    IP12 1BL Woodbridge
    6
    Suffolk
    United Kingdom
    EnglandBritish86926370001
    BANERJEE, Kamalika Ria
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    Segretario
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    239579580001
    DAVISON, James Edward
    20a Spratt Hall Road
    E11 2RQ London
    Segretario
    20a Spratt Hall Road
    E11 2RQ London
    British74915120001
    FRASER, Archibald Ian Charles
    70 St Dionis Road
    SW6 4TU London
    Segretario
    70 St Dionis Road
    SW6 4TU London
    British54887300001
    FRASER, Rupert James
    98 Clarendon Drive
    SW15 1AH London
    Segretario
    98 Clarendon Drive
    SW15 1AH London
    British25747380001
    HELPS, Annabelle Penney
    112 Cromwell Tower
    Barbican
    EC2Y 8DD London
    Segretario
    112 Cromwell Tower
    Barbican
    EC2Y 8DD London
    Australian81687520005
    LUDLOW, Sharna
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    Segretario
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    208085010001
    PICTON TURBERVILL, David
    8 Kingswood Rise
    Four Marks
    GU34 5BD Alton
    Hampshire
    Segretario
    8 Kingswood Rise
    Four Marks
    GU34 5BD Alton
    Hampshire
    British87719670002
    WARD, Karen
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    Segretario
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    204126870001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Segretario
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    EVERSECRETARY LIMITED
    Central Square South
    Orchard Street
    NE1 3XX Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    Central Square South
    Orchard Street
    NE1 3XX Newcastle Upon Tyne
    60471940007
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANTHONY, Paul
    Wentworth House
    St Leonards Hill
    SL4 4AT Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    Wentworth House
    St Leonards Hill
    SL4 4AT Windsor
    Berkshire
    British81406540001
    APPS, Paul Gordon
    1 Pointers Close
    Chieveley
    RG20 8UJ Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    1 Pointers Close
    Chieveley
    RG20 8UJ Newbury
    Berkshire
    British88199170001
    BOVATI, Paolo
    Piazza 5 Agostino 5
    FOREIGN Milan
    20153
    Italy
    Amministratore
    Piazza 5 Agostino 5
    FOREIGN Milan
    20153
    Italy
    Italian74743800001
    CHILTON, Malcolm David
    20 Prosper Meadow
    DY6 8BA Kingswinford
    West Midlands
    Amministratore
    20 Prosper Meadow
    DY6 8BA Kingswinford
    West Midlands
    United KingdomBritish145829100001
    COLOMBO, Achille
    Via Cortivo 41
    Castagnola
    Ticino 6976
    Switzerland
    Amministratore
    Via Cortivo 41
    Castagnola
    Ticino 6976
    Switzerland
    Swiss85487490001
    COLOMBO, Mario Carlo
    Via Solferino
    23 Brescia
    Brescia
    25122
    Italy
    Amministratore
    Via Solferino
    23 Brescia
    Brescia
    25122
    Italy
    Italian81675680001
    CONSTANT, Richard Ashley Meyricke
    Park Lodge
    Aislaby
    YO1 1SW Whitby
    Yorkshire
    Amministratore
    Park Lodge
    Aislaby
    YO1 1SW Whitby
    Yorkshire
    British19600420001
    EVERARD, Ian Douglas
    50 Shoreswood
    BL1 7DD Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    50 Shoreswood
    BL1 7DD Bolton
    Lancashire
    British28193080001
    FRASER, Elspeth Jane
    38 Clarendon Road
    W11 3AD London
    Amministratore
    38 Clarendon Road
    W11 3AD London
    British11543170001
    FRASER, Elspeth Jane
    38 Clarendon Road
    W11 3AD London
    Amministratore
    38 Clarendon Road
    W11 3AD London
    British11543170001
    FRASER, Perdita Rachel Josephine
    4 Alexander Street
    W2 5NT London
    Amministratore
    4 Alexander Street
    W2 5NT London
    EnglandBritish179346590001
    FRASER, Rupert James
    98 Clarendon Drive
    SW15 1AH London
    Amministratore
    98 Clarendon Drive
    SW15 1AH London
    EnglandBritish25747380001
    FRASER, Simon Joseph
    38 Clarendon Road
    W11 3AD London
    Amministratore
    38 Clarendon Road
    W11 3AD London
    United KingdomBritish15057410001
    GIACOBELLI, Fabrizio
    Via Piave 17
    Rescaldina 20027
    Milano
    Italia
    Amministratore
    Via Piave 17
    Rescaldina 20027
    Milano
    Italia
    Italian54917260001
    GULLIVER, Peter Leslie
    1 Warren Road
    Woodley
    RG5 3AP Reading
    Berkshire
    Amministratore
    1 Warren Road
    Woodley
    RG5 3AP Reading
    Berkshire
    British38491630001
    GULLIVER, Peter Leslie
    1 Warren Road
    Woodley
    RG5 3AP Reading
    Berkshire
    Amministratore
    1 Warren Road
    Woodley
    RG5 3AP Reading
    Berkshire
    British38491630001
    HOLDSWORTH, John Clifford
    9 The Grange
    Shepherds Lane Caversham
    RG4 7HZ Reading
    Berkshire
    Amministratore
    9 The Grange
    Shepherds Lane Caversham
    RG4 7HZ Reading
    Berkshire
    British59930780001
    HOLT, Nicholas Christopher
    5 High Park Road
    TW9 4BL Richmond Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    5 High Park Road
    TW9 4BL Richmond Upon Thames
    Surrey
    British10758310002
    KAY, Ian Andrew
    17 Jenner Street
    Seaforth
    New South Wales 2092
    Australia
    Amministratore
    17 Jenner Street
    Seaforth
    New South Wales 2092
    Australia
    British102259090001
    KING, William John
    The Old Laundry
    Little Horwood
    MK17 0PG Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Old Laundry
    Little Horwood
    MK17 0PG Milton Keynes
    Buckinghamshire
    EnglandBritish74570800001

    Chi sono le persone con controllo significativo di FIBROWATT LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    06 apr 2016
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03302734
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    FIBROWATT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 23 lug 2018
    Consegnato il 30 lug 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    None.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 lug 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 19 ott 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 set 2005
    Consegnato il 19 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the counterparty to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • British Gas Trading Limited
    Transazioni
    • 19 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 set 2005
    Consegnato il 07 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower and the company to the chargee whether for its own account or as trustee for the secured parties or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Canada Europe Limited (Security Trustee)
    Transazioni
    • 07 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 28 set 2000
    Consegnato il 06 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclays bank PLC re fibrowatt limited business premisum account number 90106941. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assignment
    Creato il 17 lug 1997
    Consegnato il 21 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with a share purchase agreement dated 19TH april 1996, as amended by a supplemental agreement dated 12TH august 1996 and by a second supplemental agreement dated 10TH may 1997
    Brevi particolari
    All the company's property in and right to receive all or any sums of money that may be or become payable to the company under or in consequence of the terms of a commissioning fee agreement dated 14TH august 1996 up to a maximum aggregate amount of 8,000,000.
    Persone aventi diritto
    • Eastern Generation Limited
    Transazioni
    • 21 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over securities
    Creato il 17 giu 1997
    Consegnato il 19 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement dated 16TH march 1992 or pursuant to the debenture (as defined in the deed)
    Brevi particolari
    First fixed charge the shares inclusing all dividends interest or other distributions and all allotments accretions offers rights benefits and advantages whatsoever. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of Tokyo-Mitsubishi,LTD.,
    Transazioni
    • 19 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over securities
    Creato il 17 giu 1997
    Consegnato il 19 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the termsof the facility agreement dated 30TH november 1990 or pursuant to the debenture (as defined in the deed)
    Brevi particolari
    First fixed charge over the shares together with any substituted securities inclusive of all dividends interest and other distributions and all allotments accretions offers rights benefits and advantages. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of Tokyo-Mitsubishi, LTD.,
    Transazioni
    • 19 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 19 mag 1997
    Consegnato il 04 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on the due date therefor and otherwise in accordance with the terms of the relevant loan agreements (as therein defined) and the deed
    Brevi particolari
    Fixed charge all "securities" being: all shares in the capital of any subsidiary of the company including all dividends benefits property rights etc, floating charge other than the excluded property (as defined on the M395). Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Finstahl S.A.
    • Foster Wheeler Energy Limited
    • Societa Nordelettrica S.P.a Sondel(As Agent and Security Trustee for the Lenders (as Therein Defined) or Any of Them
    Transazioni
    • 04 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Third party account charge
    Creato il 08 mag 1997
    Consegnato il 13 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from fibrowatt thetford limited to the chargee under the marubeni loan agreement dated 8TH may 1997
    Brevi particolari
    Fixed charge over the cash collateral, the account and the debt.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Marubeni UK PLC
    Transazioni
    • 13 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 26 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge
    Creato il 08 mag 1997
    Consegnato il 13 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from fibrowatt thetford limited to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined in the junior loan agreement dated 8TH may 1997)
    Brevi particolari
    All right title and interest in shareholding in fibromass limited and fibrowatt thetford limited.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Marubeni UK PLC
    Transazioni
    • 13 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 26 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assignment
    Creato il 08 mag 1997
    Consegnato il 13 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from fibrowatt thetford limited to the chargee pursuant to the finance documents (as defined in the junior loan agreement dated 8TH may 1997)
    Brevi particolari
    All right, title and interest in and to the second portion of the commissioning fee( as defined in the deed, and the commissioning fee contract dated 12 august 1996).
    Persone aventi diritto
    • Marubeni UK PLC
    Transazioni
    • 13 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 26 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Account charge
    Creato il 21 ago 1996
    Consegnato il 10 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the deed of guarantee and indemnity of even date and/or pursuant to clauses 9.1 and 9.2 of the share purchase agreement dated 18TH april 1996 which in either case become due and payable as a result of a failure on the part of fibro holdings limited to pay sums due and payable in accordance with clauses 3.2 (ii) , 3.3 or 3.4 of the share purchase agreement, subject to a maximum amount secured of £500,000
    Brevi particolari
    The deposit referred to in clause 2 (I) of the account charge and any sum or sums (up to a maximum amount of £500,000) which are from time to time deposited in the bank account in the name of fibrowatt with the royal bank of scotland PLC. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eastern Generation Limited
    Transazioni
    • 10 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 21 ago 1996
    Consegnato il 10 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the deed of guarantee and indemnity of even date and/or pursuant to clauses 9.1 and 9.2 of the share purchase agreement dated 18TH april 1996 which in either case become due and payable as a result of a failure on the part of fibro holdings limited to pay sums due and payable in accordance with clauses 3.2 (ii) , 3.3 or 3.4 of the share purchase agreement, subject to a maximum amount secured of £500,000
    Brevi particolari
    All or any sums of money that may be or become payable to fibrowatt under or in consequence of the terms of the administration services agreement dated 19TH august 1996. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eastern Generation Limited
    Transazioni
    • 10 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over securities
    Creato il 12 ago 1996
    Consegnato il 29 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from fibrowatt thetford limited to the chargee in accordance with the provisions of the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    The shares. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, in Its Capacity as Trustee for Each of Thelenders
    Transazioni
    • 29 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Account charge
    Creato il 12 ago 1996
    Consegnato il 27 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities of the company and fibro holdings limited to the chargee under an option agreement dated 12TH august 1996
    Brevi particolari
    The sum of £1 and any other sum or sums which are from time to time deposited in an account with the bank of scotland under account no.0044010. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandand Westdeutsche Landesbank Girozentrale
    Transazioni
    • 27 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 26 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of floating charge
    Creato il 21 mag 1996
    Consegnato il 05 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility agreement dated 21ST may 1996
    Brevi particolari
    The undertaking and all other property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Catamount Thetford Corporation
    Transazioni
    • 05 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 28 mar 1994
    Consegnato il 06 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement dated 28TH march 1994 being that part of the respective liabilities described above which exceeds the principal amount of £500,000
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Foster Wheeler Energy Limited
    Transazioni
    • 06 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0