EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02595962 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?
- Altre industrie manifatturiere n.c.a. (32990) / Industrie manifatturiere
Dove si trova EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Unit Bt 95/2 Tanfield Lea Industrial Estate DH9 9NX North, Stanley County Durham |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CHROMEX (NORTH EAST) LIMITED | 30 apr 1991 | 30 apr 1991 |
| KEEPJOINT LIMITED | 27 mar 1991 | 27 mar 1991 |
Quali sono gli ultimi bilanci di EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 mar 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2010 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 mar 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2009 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2008 | 24 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 mar 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mark David Hutchinson il 30 mar 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2007 | 24 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2006 | 25 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 403a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2005 | 30 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 363a | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKS, Charles David | Segretario | Planetrees Wall NE46 4EQ Hexham Northumberland | British | 78876890002 | ||||||
| BROOKS, Charles David | Amministratore | Planetrees Wall NE46 4EQ Hexham Northumberland | England | British | 78876890002 | |||||
| HUTCHINSON, Mark David | Amministratore | 15 Larkspur Close TS26 0WD Bishop Cuthbert Hartlepool | United Kingdom | British | 66723660002 | |||||
| STANLEY, Roy Robert Edward | Amministratore | 16 Graham Park Road Gosforth NE3 4BH Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | 8609980002 | |||||
| BORRELL, Arthur James Peter | Segretario | Pinedale Wallace Avenue NE16 4SX Whickham County Durham | British | 47328860003 | ||||||
| HARRISON, Irene Lesley | Segretario | Fy Mwthin 22 Merthyr Road Tongwynlais CF15 7LH Cardiff | British | 39878290001 | ||||||
| ROBINSON, Timothy Philip | Segretario | Stanegates Leazes Lane NE46 3BA Hexham | British | 18158790003 | ||||||
| THOMPSON, Christopher Scott | Segretario | Highfield House Woodhill Farm NE20 0JA Ponteland Newcastle Upon Tyne | British | 42840520001 | ||||||
| WARD, David | Segretario | 69 Langdale Way The Pastures NE36 0UF East Boldon Tyne & Wear | British | 79459910001 | ||||||
| YOUNG, Ronald Desmond | Segretario | 42 Commissioners Wharf NE29 6DN North Shields Tyne & Wear | British | 67962880001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| CLARK, Andrew Philip | Amministratore | 4 West Farm North Road NE36 0DQ East Boldon Tyne & Wear | British | 73633070001 | ||||||
| GORDON, Jennifer | Amministratore | The Old School Church Lane NE44 6DS Riding Mill Northumberland | British | 72057320004 | ||||||
| ROBINSON, Timothy Philip | Amministratore | Stanegates Leazes Lane NE46 3BA Hexham | United Kingdom | British | 18158790003 | |||||
| THOMPSON, Christopher Scott | Amministratore | Highfield House Woodhill Farm NE20 0JA Ponteland Newcastle Upon Tyne | British | 42840520001 | ||||||
| THOMPSON, Christopher Scott | Amministratore | Highfield House Woodhill Farm NE20 0JA Ponteland Newcastle Upon Tyne | British | 42840520001 | ||||||
| THOMPSON, Keith Fulton Scott | Amministratore | 22 Linden Way Ponteland NE20 9DP Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 11845980001 | ||||||
| WARD, David | Amministratore | 69 Langdale Way The Pastures NE36 0UF East Boldon Tyne & Wear | British | 79459910001 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| All assets debenture (including qualifying floating charge) | Creato il 19 mag 2005 Consegnato il 28 mag 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattel mortgage | Creato il 20 nov 2002 Consegnato il 25 nov 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Yamazaki mazak horizontal machining centre H500-5ON, 126734 - 336,043 - 204,006, (for details of further chattels charged please refer to form 395), the full benefit of any guarantee warranty or other obligation, the full benefit of all agreements, the intellectual property rights, the full benefit of the companys rights and interests in and to all insurance effected by the company or by any person of the mortgaged chattels or the use thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed charge | Creato il 29 ott 2001 Consegnato il 31 ott 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £419,703 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the charge | |
Brevi particolari 1 x used tooling package comprising pentium computer & accessories multiplex 625 126873 multiplex 625 126876 quick turn 30. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 25 giu 2001 Consegnato il 28 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 28 set 1999 Consegnato il 01 ott 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed charge | Creato il 28 set 1999 Consegnato il 02 ott 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge over the goods listed in schedule. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Single debenture | Creato il 07 ott 1991 Consegnato il 11 ott 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Including all heritable property and assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0