EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED

EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02595962
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?

    • Altre industrie manifatturiere n.c.a. (32990) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit Bt 95/2
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9NX North, Stanley
    County Durham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHROMEX (NORTH EAST) LIMITED30 apr 199130 apr 1991
    KEEPJOINT LIMITED27 mar 199127 mar 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 mag 2012

    Stato del capitale al 30 mag 2012

    • Capitale: GBP 200,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    14 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    24 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mark David Hutchinson il 30 mar 2010

    2 pagineCH01

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    24 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    25 pagineAA

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    30 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BROOKS, Charles David
    Planetrees
    Wall
    NE46 4EQ Hexham
    Northumberland
    Segretario
    Planetrees
    Wall
    NE46 4EQ Hexham
    Northumberland
    British78876890002
    BROOKS, Charles David
    Planetrees
    Wall
    NE46 4EQ Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    Planetrees
    Wall
    NE46 4EQ Hexham
    Northumberland
    EnglandBritish78876890002
    HUTCHINSON, Mark David
    15 Larkspur Close
    TS26 0WD Bishop Cuthbert
    Hartlepool
    Amministratore
    15 Larkspur Close
    TS26 0WD Bishop Cuthbert
    Hartlepool
    United KingdomBritish66723660002
    STANLEY, Roy Robert Edward
    16 Graham Park Road
    Gosforth
    NE3 4BH Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    16 Graham Park Road
    Gosforth
    NE3 4BH Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish8609980002
    BORRELL, Arthur James Peter
    Pinedale
    Wallace Avenue
    NE16 4SX Whickham
    County Durham
    Segretario
    Pinedale
    Wallace Avenue
    NE16 4SX Whickham
    County Durham
    British47328860003
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    Segretario
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    British39878290001
    ROBINSON, Timothy Philip
    Stanegates Leazes Lane
    NE46 3BA Hexham
    Segretario
    Stanegates Leazes Lane
    NE46 3BA Hexham
    British18158790003
    THOMPSON, Christopher Scott
    Highfield House
    Woodhill Farm
    NE20 0JA Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    Highfield House
    Woodhill Farm
    NE20 0JA Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    British42840520001
    WARD, David
    69 Langdale Way
    The Pastures
    NE36 0UF East Boldon
    Tyne & Wear
    Segretario
    69 Langdale Way
    The Pastures
    NE36 0UF East Boldon
    Tyne & Wear
    British79459910001
    YOUNG, Ronald Desmond
    42 Commissioners Wharf
    NE29 6DN North Shields
    Tyne & Wear
    Segretario
    42 Commissioners Wharf
    NE29 6DN North Shields
    Tyne & Wear
    British67962880001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CLARK, Andrew Philip
    4 West Farm
    North Road
    NE36 0DQ East Boldon
    Tyne & Wear
    Amministratore
    4 West Farm
    North Road
    NE36 0DQ East Boldon
    Tyne & Wear
    British73633070001
    GORDON, Jennifer
    The Old School
    Church Lane
    NE44 6DS Riding Mill
    Northumberland
    Amministratore
    The Old School
    Church Lane
    NE44 6DS Riding Mill
    Northumberland
    British72057320004
    ROBINSON, Timothy Philip
    Stanegates Leazes Lane
    NE46 3BA Hexham
    Amministratore
    Stanegates Leazes Lane
    NE46 3BA Hexham
    United KingdomBritish18158790003
    THOMPSON, Christopher Scott
    Highfield House
    Woodhill Farm
    NE20 0JA Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Highfield House
    Woodhill Farm
    NE20 0JA Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    British42840520001
    THOMPSON, Christopher Scott
    Highfield House
    Woodhill Farm
    NE20 0JA Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Highfield House
    Woodhill Farm
    NE20 0JA Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    British42840520001
    THOMPSON, Keith Fulton Scott
    22 Linden Way
    Ponteland
    NE20 9DP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    22 Linden Way
    Ponteland
    NE20 9DP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British11845980001
    WARD, David
    69 Langdale Way
    The Pastures
    NE36 0UF East Boldon
    Tyne & Wear
    Amministratore
    69 Langdale Way
    The Pastures
    NE36 0UF East Boldon
    Tyne & Wear
    British79459910001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    EXPRESS 2 AUTOMOTIVE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    All assets debenture (including qualifying floating charge)
    Creato il 19 mag 2005
    Consegnato il 28 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Five Arrows Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 28 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 20 nov 2002
    Consegnato il 25 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Yamazaki mazak horizontal machining centre H500-5ON, 126734 - 336,043 - 204,006, (for details of further chattels charged please refer to form 395), the full benefit of any guarantee warranty or other obligation, the full benefit of all agreements, the intellectual property rights, the full benefit of the companys rights and interests in and to all insurance effected by the company or by any person of the mortgaged chattels or the use thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 29 ott 2001
    Consegnato il 31 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £419,703 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the charge
    Brevi particolari
    1 x used tooling package comprising pentium computer & accessories multiplex 625 126873 multiplex 625 126876 quick turn 30. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Udt Limited
    Transazioni
    • 31 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 giu 2001
    Consegnato il 28 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 set 1999
    Consegnato il 01 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 28 set 1999
    Consegnato il 02 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over the goods listed in schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Udt Limited
    Transazioni
    • 02 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 07 ott 1991
    Consegnato il 11 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including all heritable property and assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 25 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0