STANNIFER LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTANNIFER LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02597049
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STANNIFER LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova STANNIFER LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    25 Harley Street
    London
    W1G 9BR
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STANNIFER LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SHELFCO (NO. 616) LIMITED02 apr 199102 apr 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di STANNIFER LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per STANNIFER LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 06 ago 2013

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 02 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephane Abraham Joseph Nahum il 28 giu 2011

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    12 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Malcolm Robin Turner il 28 giu 2011

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 02 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    12 pagineAA

    Nomina di Ms Jennifer Grace Draper come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Collins come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Malcolm Robin Turner il 01 gen 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 02 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephane Abraham Joseph Nahum il 01 gen 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Patrick Colin O'driscoll il 01 gen 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Malcolm Robin Turner il 01 gen 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David John Collins il 03 dic 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr James Lane Tuckey il 03 dic 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    12 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di STANNIFER LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    E L SERVICES LIMITED
    25 Harley Street
    W1G 9BR London
    Segretario
    25 Harley Street
    W1G 9BR London
    78638580003
    DRAPER, Jennifer Grace
    Hanover Square
    W1S 1JB London
    23
    United Kingdom
    Amministratore
    Hanover Square
    W1S 1JB London
    23
    United Kingdom
    United KingdomAustralian152638020001
    NAHUM, Stephane Abraham Joseph
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    4th Floor Millbank Tower
    Amministratore
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    4th Floor Millbank Tower
    United KingdomFrench99292580014
    O'DRISCOLL, Patrick Colin
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    4th Floor Millbank Tower
    Amministratore
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    4th Floor Millbank Tower
    EnglandIrish75571770001
    TUCKEY, James Lane
    Hanover Square
    W1S 1JB London
    23
    United Kingdom
    Amministratore
    Hanover Square
    W1S 1JB London
    23
    United Kingdom
    United KingdomBritish35019240001
    TURNER, Malcolm Robin
    Millbank
    SW1P 4QP London
    4th Floor Millbank Tower 21-24
    Amministratore
    Millbank
    SW1P 4QP London
    4th Floor Millbank Tower 21-24
    United KingdomBritish60293070008
    BLAIR, James Don
    9 Rosebank Grove
    EH5 3QN Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    9 Rosebank Grove
    EH5 3QN Edinburgh
    Midlothian
    British85605320001
    HEARN, Paul Leonard
    Fairhaven Featherbed Lane
    CV37 0ER Pathlow
    Warwickshire
    Segretario
    Fairhaven Featherbed Lane
    CV37 0ER Pathlow
    Warwickshire
    British10456600005
    MACLEAN, Robert William
    18 Fulton Gardens
    PA6 7NU Houston
    Renfrewshire
    Segretario
    18 Fulton Gardens
    PA6 7NU Houston
    Renfrewshire
    British89832510001
    E P S SECRETARIES LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    Segretario nominato
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    900004930001
    BARROTT, Ronald Stephen
    Foxborough
    Drovers Hill
    GL55 6UW Chipping Campden
    Gloucestershire
    Amministratore
    Foxborough
    Drovers Hill
    GL55 6UW Chipping Campden
    Gloucestershire
    EnglandBritish9892700002
    BLAIR, James Don
    9 Rosebank Grove
    EH5 3QN Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    9 Rosebank Grove
    EH5 3QN Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish85605320001
    COLLINS, David John
    Hanover Square
    W1S 1JB London
    23
    United Kingdom
    Amministratore
    Hanover Square
    W1S 1JB London
    23
    United Kingdom
    United KingdomAustralian119898430001
    HUDSON, Geoffrey Grant
    La Boutefeve
    Blanches Pierres Lane
    GY4 6SA St Martins
    Guernsey
    Amministratore
    La Boutefeve
    Blanches Pierres Lane
    GY4 6SA St Martins
    Guernsey
    GuernseyBritish87308690001
    MCDIVEN, Ross Arnold
    U 9 38 Bay Street
    NSW 2028 Double Bay
    New South Wales
    Australia
    Amministratore
    U 9 38 Bay Street
    NSW 2028 Double Bay
    New South Wales
    Australia
    Australian108719480001
    MCGIVERN, Jayne Eleanor
    9 Northumberland Place
    W2 5BS London
    Amministratore
    9 Northumberland Place
    W2 5BS London
    British106563070002
    PEDERSEN, Karen Maree
    22a Kentville Avenue
    Annandale
    Nsw 2038
    Amministratore
    22a Kentville Avenue
    Annandale
    Nsw 2038
    Australian109087760001
    SHEARD, Michael John
    The Old Mill House 2 High Street
    Barford
    CV35 8BU Warwick
    Amministratore
    The Old Mill House 2 High Street
    Barford
    CV35 8BU Warwick
    United KingdomBritish10973520002
    C L LIMITED
    16/18 Athol Street
    ISLEMAN Douglas
    Isle Of Man
    Amministratore
    16/18 Athol Street
    ISLEMAN Douglas
    Isle Of Man
    42022230001
    MIKJON LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    Amministratore delegato nominato
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    900004920001

    STANNIFER LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Assignation in security
    Creato il 13 lug 2004
    Consegnato il 20 lug 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The rental account being account number 06005311 held with the lender together with all balances standing to the credit thereof and agreements or intruments entered into in relation to the rental account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of variation re debenture dated 15 december 2000 and
    Creato il 13 lug 2004
    Consegnato il 20 lug 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge all the company's goodwill and uncalled capital, all present and future stocks, shares and other securities, all patents, patent applications and trade marks etc., all present and future book and other debts, all plant and machinery and all bank accounts, cash at bank and credit balances. Floating charge all the assets being the whole of the property and undertaking of the company (including uncalled capital). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of accession relating to a security deed dated 26TH march 2004 between the original chargor and the security agent (the security agreement) and
    Creato il 18 giu 2004
    Consegnato il 30 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Agent)
    Transazioni
    • 30 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 dic 2000
    Consegnato il 22 dic 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 20DECEMBER 2000
    Creato il 29 nov 2000
    Consegnato il 23 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in the terms of personal bond dated 29 november 2000
    Brevi particolari
    Property k/a fife central retail park kirkcaldy.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation of rents
    Creato il 18 lug 2000
    Consegnato il 19 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities whether owed jointly or severally or in any capacity whatsoever by the company and any other obligor to the chargee under each finance document (as defined in the credit agreement dated 16TH january 1998) as the same was supplemented by supplemental agreement dated 6TH september 1999 and supplemental agreement dated 24TH february 2000
    Brevi particolari
    All right title and interest in the rental income (as defined in the credit agreement) in respect of lease between the company and larsen & ross northern limited dated 27/07/00.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 19 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplementary assignation of rents
    Creato il 29 mar 2000
    Consegnato il 01 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company and/or any other obligor (as defined in credit facility agreement dated 16 june 1999 between the company and the bank (wherein they are named bayerische hypotheken-und wechsel bank ag) as supplemental by supplemental agreement dated 6TH september 1999 and supplemental agreement dated 24 february 2000, as the same may have been or may be extended, amended, varied, supplemented, novated, restated, replaced or renewed from time to time ("the credit agreement")) to the chargee under each finance document (as defined in credit agreement)
    Brevi particolari
    The company's right title and interest in and to the rental income (as defined in the credit agreement) in respect of the lease between the company and boots the chemists limited dated 21 and 25 february 2000 relative to unit 11, fife central retail park kirkcaldy.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 01 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation and irrevocable mandate
    Creato il 23 lug 1999
    Consegnato il 11 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The company's whole right title and interest in and its right to rents. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation of performance bond
    Creato il 23 lug 1999
    Consegnato il 11 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The loan due or to become due from the company to the chargee made available to the company
    Brevi particolari
    The company's whole right title and interest in the performance bond dated 1 july 1999.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 4TH august 1999
    Creato il 23 lug 1999
    Consegnato il 10 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of a facility letter dated 13TH july 1999 and accepted by the company on 19TH july 1999
    Brevi particolari
    Development site at drip road stirling.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation of rents
    Creato il 22 set 1998
    Consegnato il 25 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities whatsoever due from the company and/or any obligor (as defined) to the chargee under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    All rights,title and interest in and to all rental income (as defined in the credit agreement) payable in respect of the piece of land to the north of chapel level,kirkcaldy,county of fife; t/no ffe 10316. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag
    Transazioni
    • 25 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 16 gen 1998
    Consegnato il 28 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of the company and each guarantor to the chargee under each finance document except for any obligation which, if it were so included, would result in the charge contravening section 151 of the companies act 1985
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all moneys standing to the credit of the security account; all benefits in respect of the insurances and all claims and returns of premiums in respect of them; the benefit of all licences consents and authorisations (statutory or otherwise) held in connection with its business or the use of any security assets specified in any other sub-paragraph in these short particulars and the right to recover and receive all compensation which may be payable to it in respect of them;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 28 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation of rents
    Creato il 16 gen 1998
    Consegnato il 21 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under each finance document (as therein defined)
    Brevi particolari
    All rental income due under the leases as listed on the schedule to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transazioni
    • 21 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 19 january 1998 and
    Creato il 13 gen 1998
    Consegnato il 24 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or any other obligor (as defined in the credit agreement) to the chargee and its successors and assignees whomsoever on any account whatsoever including without prejudice to the foregoing generality all present and future obligations and liabilities of each obligor to the chargee under or pursuant to a credit agreement executed by the company on 13 january 1998 but dated 16 january 1998 between the company and the chargee and each finance document referred to as such in the credit agreement except for any obligation which if it were so included would result in the standard security contravening section 151 of the companies act 1985
    Brevi particolari
    All and whole the subjects registered under t/n FFE10316 and being that area or piece of ground lying generally on or towards thenorth of chapel level kirkcaldy fife and bounded on all sides by land belonging to the fife council k/a chapel farm chapel level kirkcaldy. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transazioni
    • 24 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 29TH july 1996
    Creato il 29 lug 1996
    Consegnato il 01 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Area or piece of ground lying generally on or towards the north of chapel level kirkcaldy in the county of fife k/a chapel farm chapel level kirkaaldy t/no:-FFE10316. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland International Limited
    Transazioni
    • 01 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of legal charge
    Creato il 13 apr 1992
    Consegnato il 01 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Part of elm court phase ii, arden street, stratfords-upon-avon, warwickshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0