ACCESS PLUS LIMITED

ACCESS PLUS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàACCESS PLUS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02600683
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ACCESS PLUS LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova ACCESS PLUS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    K House Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ACCESS PLUS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ACCESS PLUS PLC18 ott 199618 ott 1996
    ACCESS PLUS HOLDINGS LIMITED25 giu 199625 giu 1996
    ACCESS FORMDESIGN HOLDINGS LIMITED05 giu 199105 giu 1991
    QUAYSHELFCO 360 LIMITED11 apr 199111 apr 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di ACCESS PLUS LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2016
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2017
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per ACCESS PLUS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 25 nov 2016

    • Capitale: GBP 0.10
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    19 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 17 mag 2016

    • Capitale: GBP 1,862,871
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 03/05/2016
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 11 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di Robert Rolph Baldrey come amministratore in data 13 apr 2016

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da K House Sheffield Airport Business Park Europa Link Sheffield S9 1XU England a K House Sheffield Airport Business Park Europa Link Sheffield S9 1XU in data 13 mag 2016

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da St Crispins Duke Street Norwich Norfolk NR3 1PD England a K House Sheffield Airport Business Park Europa Link Sheffield S9 1XU in data 13 mag 2016

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 026006830014 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 026006830015 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 026006830016 in pieno

    4 pagineMR04

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 09 mag 2016

    • Capitale: GBP 1,862,871
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account cancelled 05/05/2016
    RES13

    Soddisfazione dell'onere 026006830012 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di ACCESS PLUS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MENDELSOHN, Lorna
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    Segretario
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    194463580001
    GALE, Andrew Peter
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    Amministratore
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    EnglandBritish155681500001
    HAWORTH, Stephen
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    Amministratore
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    EnglandBritish155690570001
    FOWEN, Yvonne Pauline
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    Segretario
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    British26389070002
    HOLMES, Julian
    28 Tempest Drive
    NP16 5AY Chepstow
    Gwent
    Segretario
    28 Tempest Drive
    NP16 5AY Chepstow
    Gwent
    British110668840001
    POPLE, Christopher John
    8 College Road
    Clifton
    BS8 3JB Bristol
    Avon
    Segretario
    8 College Road
    Clifton
    BS8 3JB Bristol
    Avon
    British10061330001
    RODWELL, Debbie
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    Segretario
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    British103054490001
    SMITH, Angela Clare
    35 Lime Road
    Southville
    BS3 1LS Bristol
    Avon
    Segretario
    35 Lime Road
    Southville
    BS3 1LS Bristol
    Avon
    British100635720001
    NQH (CO SEC) LIMITED
    Narrow Quay House
    Narrow Quay
    BS1 4AH Bristol
    Segretario nominato
    Narrow Quay House
    Narrow Quay
    BS1 4AH Bristol
    900001160001
    AVERY, Stephen Thomas
    Riverside House
    The Orchards Roecliffe
    WF4 2LB Boroughbridge
    North Yorkshire
    Amministratore
    Riverside House
    The Orchards Roecliffe
    WF4 2LB Boroughbridge
    North Yorkshire
    United KingdomBritish52690520004
    BALDREY, Robert Rolph
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    Amministratore
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    EnglandBritish78328360005
    BALDREY, Robert Rolph
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    England
    Amministratore
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    England
    EnglandBritish78328360005
    BRETTELL, Timothy Geoffrey
    Abbots Leigh House
    Abbots Leigh
    BS8 3QP Bristol
    Amministratore
    Abbots Leigh House
    Abbots Leigh
    BS8 3QP Bristol
    British16193990002
    CAWLEY, Hugh Charles Laurence
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    Amministratore
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    United KingdomBritish41820960003
    CROMACK, Jason Charles Edward
    Fairmead Iford Fields
    Lower Westwood
    BA15 2BQ Bradford On Avon
    Wiltshire
    Amministratore
    Fairmead Iford Fields
    Lower Westwood
    BA15 2BQ Bradford On Avon
    Wiltshire
    EnglandBritish148492510001
    CUNNINGHAM, Mark Andrew
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    Amministratore
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    EnglandBritish130923460003
    GALE, Andrew Peter
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    Amministratore
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    EnglandBritish155681500001
    HAIGH, Nicholas Jonathan
    36 Ray Park Avenue
    SL6 8DY Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    36 Ray Park Avenue
    SL6 8DY Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish141774490001
    HODGSON, Richard
    13 Pleydell Avenue
    W6 0XX London
    Amministratore
    13 Pleydell Avenue
    W6 0XX London
    United KingdomBritish96788660005
    HOUSTON, Peter Richard Vivian
    Fair Dawn Packhorse Lane
    Southstoke
    BA2 7DL Bath
    Somerset
    Amministratore
    Fair Dawn Packhorse Lane
    Southstoke
    BA2 7DL Bath
    Somerset
    United KingdomBritish113014870001
    MITCHARD, Anthony Keith
    1 Lansdown Park
    BA1 5TG Bath
    Amministratore
    1 Lansdown Park
    BA1 5TG Bath
    United KingdomBritish9605140001
    MOATE, Simon Richard
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    Amministratore
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins
    Norfolk
    EnglandBritish126182400002
    NICHOLLS, Jill Nicola
    97 Noel Road
    N1 8HD London
    Amministratore
    97 Noel Road
    N1 8HD London
    British8485240002
    POPLE, Christopher John
    4 College Fields
    BS8 3HP Bristol
    Amministratore
    4 College Fields
    BS8 3HP Bristol
    United KingdomBritish10061330005
    ROWLANDS, Christopher John
    Buchan House
    24 Northumberland Road Redland
    BS6 7BB Bristol
    Amministratore
    Buchan House
    24 Northumberland Road Redland
    BS6 7BB Bristol
    United KingdomBritish4524130002
    WONG, Jun Tsiong
    1a Canning Place
    W8 5AD London
    Amministratore
    1a Canning Place
    W8 5AD London
    British72387070003
    NQH LIMITED
    Narrow Quay House
    Narrow Quay
    BS1 4AH Bristol
    Amministratore delegato nominato
    Narrow Quay House
    Narrow Quay
    BS1 4AH Bristol
    900001150001

    ACCESS PLUS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ares Capital Europe Limited in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ares Capital Europe Limited in Its Capacity as Security Agent
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    L/H property k/a 16A crawfordsburn road newtownards county down.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ares Capital Europe Limited in Its Capacity as Security Agent
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 30 apr 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD for Itself and in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 30 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 29 apr 2015
    In corso
    Breve descrizione
    The property known as 8 trench road, hydepark, mallusk, newtownabbey, comprised in folio no AN28700L county antrim and held under indenture of lease dated the 15TH day of march 1991 and made between chessbourne international limited (1) john heath & co limited (2).. the leasehold property situate adjacent to 8 trench road, hydepark industrial estate, mallusk, newtownabbey, comprised in folio no AN30433L county antrim and held under indenture of lease dated the 26TH day of august 1993 and made between chessbourne international limited (1) john heath & co limited (2).. the leasehold property situate at 16A crawfordsburn road, newtownards, county down comprised in and demised by indenture of lease dated the 12TH day of august 1994 and made between northern engineering enterprises limited (1) secretary of state for the environment (2) for the term of twenty-five (25) years from the 20TH day of june 1994 subject as therein (as registered in the registry of deeds on the 6TH day of september 1994, serial number 1994-120-033).
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD for Itself and in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 29 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    In corso
    Breve descrizione
    The freehold land known as "software stationery specialists", wheatfield way, hinckley, LE10 1YG. Title number LT244150.. The leasehold land known as lexicon house, midleton road, guildford, GU2 8XP. Title number SY820787.. The leasehold land known as dorcan 300, murdoch road, dorcan, swindon SN3 5HY. Title number WT307925.. For more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD for Itself and in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 12 nov 2008
    Consegnato il 15 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession in respect of a debenture dated 23 october 2003
    Creato il 26 feb 2004
    Consegnato il 10 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property units 2 and 3 northern perimeter road west hinckley leicestershire t/n LT244150. L/h property unit 1 gildersome spur distribution centre wakefield road leeds. L/h property access house clifton down bristol (part lower ground, first and second floors).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 nov 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 05 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Working capital composite guarantee and debenture
    Creato il 28 nov 2003
    Consegnato il 13 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The freehold property known as units 2 and 3 northern perimeter road west hinckley leicestershire t/n LT244150 the leasehold property known as unit 1 gildersome spur distribution centre wakefield road leeds and the leasehold property known as access house clifton down bristol (part lower ground, ground, first and second floors). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 13 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 nov 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 05 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 apr 1997
    Consegnato il 09 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0