SUNSHARE VACATIONS LIMITED

SUNSHARE VACATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSUNSHARE VACATIONS LIMITED
    Stato della societàConvertita/Chiusa
    Forma giuridicaConvertita o chiusa
    Numero di società 02601069
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SUNSHARE VACATIONS LIMITED?

    • Attività delle agenzie di viaggio (79110) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova SUNSHARE VACATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SUNSHARE VACATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TIMESHARE TRAVEL INTERNATIONAL LIMITED21 mag 199121 mag 1991
    CONNCO 6 LIMITED12 apr 199112 apr 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di SUNSHARE VACATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al11 gen 2015

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SUNSHARE VACATIONS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SUNSHARE VACATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Varie

    Forms b & z convert to rs
    2 pagineMISC

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Convert to rs 06/07/2016
    RES13

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 06 lug 2016

    • Capitale: GBP 100,002
    3 pagineSH01

    Bilancio annuale redatto al 01 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 set 2015

    Stato del capitale al 02 set 2015

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2015

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 set 2014

    Stato del capitale al 01 set 2014

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Cessazione della carica di Patrick Moynihan come amministratore in data 30 giu 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Andrew Paul Lang come amministratore in data 30 giu 2014

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 set 2013

    Stato del capitale al 04 set 2013

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Patrick Moynihan il 01 set 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Cws (No.1) Limited il 01 set 2013

    2 pagineCH02

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2013

    3 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * 1 Angel Square Manchester M60 0AG United Kingdom* in data 03 dic 2012

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da * New Century House Corporation Street Manchester M60 4ES* in data 03 dic 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 01 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2012

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Paul Hemingway come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Cws (No.1) Limited come amministratore

    2 pagineAP02

    Nomina di Mr Patrick Moynihan come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Greenacre come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2011

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Neil Braithwaite come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2010

    3 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SUNSHARE VACATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SELLERS, Caroline Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    BritishAssistant Secretary45801060004
    LANG, Andrew Paul
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant170146830001
    CWS (NO.1) LIMITED
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Amministratore
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione1925625
    130695310001
    CROCKER, John
    16 Hartington Road
    High Lane
    SK6 8BY Stockport
    Cheshire
    Segretario
    16 Hartington Road
    High Lane
    SK6 8BY Stockport
    Cheshire
    BritishChartered Accountant9467540001
    FITZSIMONS, Elizabeth
    24 Everett Road
    Withington
    M20 3DZ Manchester
    Lancashire
    Segretario
    24 Everett Road
    Withington
    M20 3DZ Manchester
    Lancashire
    British11723940001
    TAYLOR, Karen Ann
    18 Covent Garden
    Hillgate
    SK1 3AX Stockport
    Cheshire
    Segretario
    18 Covent Garden
    Hillgate
    SK1 3AX Stockport
    Cheshire
    British82241590001
    WHITTAKER, Katherine Alison
    22 Westfield Drive
    Woodley
    SK6 1LD Stockport
    Cheshire
    Segretario
    22 Westfield Drive
    Woodley
    SK6 1LD Stockport
    Cheshire
    British29899300002
    BRAITHWAITE, Neil
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    Amministratore
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    EnglandBritishChartered Accountant87486660004
    BRAITHWAITE, Neil
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    Amministratore
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    EnglandBritishChartered Accountant87486660004
    BRIERLEY, Lee David
    6 Tower View
    Belthorn
    BB1 2PD Blackburn
    Lancashire
    Amministratore
    6 Tower View
    Belthorn
    BB1 2PD Blackburn
    Lancashire
    BritishSolicitor15056200001
    CROCKER, John
    16 Hartington Road
    High Lane
    SK6 8BY Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    16 Hartington Road
    High Lane
    SK6 8BY Stockport
    Cheshire
    BritishChartered Accountant9467540001
    DAWSON, Peter
    8 Culcheth Hall Farm Barns
    Withington Avenue
    WA3 4AJ Culcheth
    Cheshire
    Amministratore
    8 Culcheth Hall Farm Barns
    Withington Avenue
    WA3 4AJ Culcheth
    Cheshire
    BritishTravel Management94606430002
    FITZSIMONS, Elizabeth
    259 Bunch Road
    West Dodsbury
    N20 8WA Manchester
    Amministratore
    259 Bunch Road
    West Dodsbury
    N20 8WA Manchester
    BritishTrainee Solicitor35525890001
    GREENACRE, Michael David
    57 Springfield Lane
    Eccleston
    WA10 5HB St Helens
    Merseyside
    Amministratore
    57 Springfield Lane
    Eccleston
    WA10 5HB St Helens
    Merseyside
    EnglandBritishGeneral Manager74808750001
    HEMINGWAY, Paul Andrew
    71 Southworth Road
    WA12 0BL Newton Le Willows
    St Helens
    Amministratore
    71 Southworth Road
    WA12 0BL Newton Le Willows
    St Helens
    United KingdomBritishHead Of Tax And Treasury188221460001
    LOCKLEY, Kenneth Morton
    59 Prestwich Hills
    Prestwich
    M25 9PY Manchester
    Amministratore
    59 Prestwich Hills
    Prestwich
    M25 9PY Manchester
    BritishTravel Agent47510860001
    MCPHERSON, Kenneth
    Oaklands Drive
    WA13 0NF Lymm
    1
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Oaklands Drive
    WA13 0NF Lymm
    1
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant224051820001
    MELLING, Christopher Eric
    21 Avonhead Close
    Horwich
    BL6 5QD Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    21 Avonhead Close
    Horwich
    BL6 5QD Bolton
    Lancashire
    EnglandBritishHead Of Finance Travel Care58695390001
    MOYNIHAN, Patrick
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Amministratore
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    United KingdomBritishAccountant87719730001
    NEILD, Peter David
    27 Longwood Close
    Romiley
    SK6 4LR Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    27 Longwood Close
    Romiley
    SK6 4LR Stockport
    Cheshire
    BritishChartered Management Accountan5032890001
    O'MALLEY, Patrick Joseph
    Flat 6 25 Old Lansdowne Road
    West Didsbury
    M20 8BP Manchester
    Amministratore
    Flat 6 25 Old Lansdowne Road
    West Didsbury
    M20 8BP Manchester
    BritishMarketing Consultant19526740001
    PENNINGTON, Kenneth
    198 Buxton Road
    Davenport
    SK2 7AE Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    198 Buxton Road
    Davenport
    SK2 7AE Stockport
    Cheshire
    BritishTravel Consultant18956410001
    PERRIN, Nicholas John
    Westfield
    5 Hough Lane
    SK9 2LG Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    Westfield
    5 Hough Lane
    SK9 2LG Wilmslow
    Cheshire
    BritishGeneral Manager, Corporate Fin80173660001
    SEMP, Malcolm
    33 Park Lane
    Whitefield
    M45 7HL Manchester
    Amministratore
    33 Park Lane
    Whitefield
    M45 7HL Manchester
    EnglandBritishAccountant91218510001
    SMALL, Trevor
    8 Ringley Road West
    Radcliffe
    M26 1DJ Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    8 Ringley Road West
    Radcliffe
    M26 1DJ Manchester
    Lancashire
    EnglandBritishTravel Agent65687500002
    SPEIGHT, Andrew Jonathan
    12 Arcadia Avenue
    BH8 9ER Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    12 Arcadia Avenue
    BH8 9ER Bournemouth
    Dorset
    EnglandBritishTravel Agent105606860001
    WILLIAMS, Amanda Jane
    Watersedge 1 High Grove Road
    Grasscroft
    OL4 4HG Saddleworth
    Amministratore
    Watersedge 1 High Grove Road
    Grasscroft
    OL4 4HG Saddleworth
    BritishGeneral Manager87240350002

    SUNSHARE VACATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over credit balances
    Creato il 15 giu 1998
    Consegnato il 18 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The sum of £20,000.00 together with interest accrued now or to be held by the bank on account numbered 43091636.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 15 ago 1997
    Consegnato il 21 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond dated 8TH august 1997 in favour of the association of british travel agents limited for £7,500
    Brevi particolari
    The sum of £7,5OO together interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 43091636 and earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 17 giu 1997
    Consegnato il 03 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a bond dated 2 september 1996 in favour of the association of british travel agents for £5,400
    Brevi particolari
    £5,400 together with interest accrued now or to be held by the bank on account number 43091636.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 27 ago 1996
    Consegnato il 03 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to three bonds in favour of the association of british travel agents limited for £191,935.00, £5,400.00 and £65,004.00 respectively
    Brevi particolari
    The sum of £262,339 together with interest held by the bank on an account numbered 43091636 and designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 19 lug 1996
    Consegnato il 30 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to 3 bonds in favour of the association of british travel agents for £191,135 £5,000 and £65004
    Brevi particolari
    The sum of £261,939 together with interest accrued now or to be held by the bank on account no:-43091636 and earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 29 nov 1995
    Consegnato il 06 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to two bonds in favour of the association of british travel agents limited for £191,935 and £5,000
    Brevi particolari
    The sum of £196,935 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 43091636 and earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 04 ago 1995
    Consegnato il 10 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to three bonds in favour of the association of british travel agents for £20,000 £156,600 and £10,000 respectively
    Brevi particolari
    The sum of £186,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 43091636.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 09 gen 1995
    Consegnato il 13 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to two bonds in favour of the association of british travel agents limited for £20,000 and £156,600
    Brevi particolari
    The sum of £176,600 together with the interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 43091636 and earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 30 ago 1994
    Consegnato il 14 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to two bonds in favour of the association of british travel agents limited for £20,000 and £70,239
    Brevi particolari
    The sum of £90,239 together with interest accrued now or to be held by nationalwestminster bank PLC on account numbered 43091636 and earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 29 apr 1994
    Consegnato il 13 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond in favour of the association of british travel agents limited for £10,000
    Brevi particolari
    The sum of £10,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an acount numbered 43091636 and earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of cash deposit
    Creato il 13 gen 1994
    Consegnato il 15 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The sum of £40,239 credited to account number/designation 13128663 with the bank together with all sums in the future credited to that account and including all interest accrued or accruing in the future on the account.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0