TEREX LIFTING U.K. LIMITED

TEREX LIFTING U.K. LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTEREX LIFTING U.K. LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02602451
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TEREX LIFTING U.K. LIMITED?

    • fabbricazione di apparecchiature di sollevamento e movimentazione (28220) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova TEREX LIFTING U.K. LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1FE Milton Keynes
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TEREX LIFTING U.K. LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MATBRO LIMITED16 ago 199116 ago 1991
    FORAY 292 LIMITED17 apr 199117 apr 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di TEREX LIFTING U.K. LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per TEREX LIFTING U.K. LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 29 giu 2017

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 23 giu 2017

    • Capitale: GBP 2,500,003
    3 pagineSH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di John Daniel Sheehan come amministratore in data 27 feb 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kevin Patrick Bradley come amministratore in data 27 feb 2017

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 apr 2016

    Stato del capitale al 25 apr 2016

    • Capitale: GBP 2,500,002
    SH01

    Cessazione della carica di Ronald Matthew Defeo come amministratore in data 11 dic 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 apr 2015

    Stato del capitale al 17 apr 2015

    • Capitale: GBP 2,500,002
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 apr 2014

    Stato del capitale al 28 apr 2014

    • Capitale: GBP 2,500,002
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Mr Kevin Patrick Bradley come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Phillip Widman come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ronald Matthew Defeo il 17 apr 2012

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di TEREX LIFTING U.K. LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COHEN, Eric I
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    Segretario
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    American65582430009
    COHEN, Eric I
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    Amministratore
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    United StatesAmerican65582430009
    SHEEHAN, John Daniel
    200 Nyala Farm Road
    06880 Westport
    C/O Terex Corporation
    Usa
    Amministratore
    200 Nyala Farm Road
    06880 Westport
    C/O Terex Corporation
    Usa
    United StatesAmerican226001330001
    BROOKES, Howard Maurice
    14 Ryknild Close
    Four Oaks
    B74 4UP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    14 Ryknild Close
    Four Oaks
    B74 4UP Sutton Coldfield
    West Midlands
    British662930001
    HARRIS, Andrew David
    Forest Cottage
    20 High St Henley In Arden
    B95 5AG Solihull
    West Midlands
    Segretario
    Forest Cottage
    20 High St Henley In Arden
    B95 5AG Solihull
    West Midlands
    British47665710002
    MANDERS, Douglas Nigel
    44 Beebee Road
    WS10 9RX Wednesbury
    West Midlands
    Segretario nominato
    44 Beebee Road
    WS10 9RX Wednesbury
    West Midlands
    British900003700001
    APUZZO, Joseph
    190 Sturges Ridge Road
    Wilton
    Fairfield
    06897
    Usa
    Amministratore
    190 Sturges Ridge Road
    Wilton
    Fairfield
    06897
    Usa
    American66269020001
    BAILLIE, Fergus Cumming
    4 Abinger Gardens
    Murrayfield
    EH12 6DE Edinburgh
    Scotland
    Amministratore
    4 Abinger Gardens
    Murrayfield
    EH12 6DE Edinburgh
    Scotland
    British924340002
    BRADLEY, Kevin Patrick
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1FE Milton Keynes
    The Pinnacle
    United Kingdom
    Amministratore
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1FE Milton Keynes
    The Pinnacle
    United Kingdom
    Untied States Of AmericaAmerican176590390001
    COSGROVE, Barry
    11 Adair Avenue
    BT80 8PU Cookstown
    County Tyrone
    Northern Ireland
    Amministratore
    11 Adair Avenue
    BT80 8PU Cookstown
    County Tyrone
    Northern Ireland
    British13991920001
    CRAIG, John Egwin
    Saxonbury House
    Frant
    TN3 9HJ Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Saxonbury House
    Frant
    TN3 9HJ Tunbridge Wells
    Kent
    British15697900001
    DEFEO, Ronald Matthew
    Beachside Avenue
    Westport
    45
    Connecticut 06880
    Usa
    Amministratore
    Beachside Avenue
    Westport
    45
    Connecticut 06880
    Usa
    United StatesAmerican94656950001
    DOOEY, Hugh Pat
    14 Usnastraine Road
    BT71 5DE Coalisland
    Tyrone
    N Ireland
    Amministratore
    14 Usnastraine Road
    BT71 5DE Coalisland
    Tyrone
    N Ireland
    Northern IrelandIrish115095900001
    HARRIS, Andrew David
    Forest Cottage
    20 High St Henley In Arden
    B95 5AG Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Forest Cottage
    20 High St Henley In Arden
    B95 5AG Solihull
    West Midlands
    British47665710002
    HARRIS, Andrew David
    Forest Cottage
    20 High St Henley In Arden
    B95 5AG Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Forest Cottage
    20 High St Henley In Arden
    B95 5AG Solihull
    West Midlands
    British47665710002
    HOLMES, Edward
    Rushford House Rushford Bridge
    GL12 8JW Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    Amministratore
    Rushford House Rushford Bridge
    GL12 8JW Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    British55964730001
    KENNERLEY, John Frank William
    Old Westwick
    Chantry View Road
    GU1 3XW Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Old Westwick
    Chantry View Road
    GU1 3XW Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish69793560001
    MANDERS, Douglas Nigel
    44 Beebee Road
    WS10 9RX Wednesbury
    West Midlands
    Amministratore delegato nominato
    44 Beebee Road
    WS10 9RX Wednesbury
    West Midlands
    British900003700001
    MCGRATH, Brendan
    13 Newent Close
    Winyates Green
    B98 0QW Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    13 Newent Close
    Winyates Green
    B98 0QW Redditch
    Worcestershire
    Irish38927470001
    MCKEOWN, Shay
    41 Tullycullion Road
    Dungannon
    County Tyrone
    Northern Ireland
    Amministratore
    41 Tullycullion Road
    Dungannon
    County Tyrone
    Northern Ireland
    Irish40247040001
    MURCHAN, Seamus Michael
    2 Ferndale
    Clonallon Road
    BT34 3FE Warrenpoint
    County Down
    Amministratore
    2 Ferndale
    Clonallon Road
    BT34 3FE Warrenpoint
    County Down
    Northern IrelandNorthern Irish182530670001
    NICHOLSON SMITH, James Timothy
    Kings Farm
    Stockwell Lane, Woodmancote
    GL52 4QB Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Kings Farm
    Stockwell Lane, Woodmancote
    GL52 4QB Cheltenham
    Gloucestershire
    British70851540001
    NOONE, Liam
    121 Malmesbury Road
    SN15 1PZ Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    121 Malmesbury Road
    SN15 1PZ Chippenham
    Wiltshire
    Irish47114340001
    REES, Andrew Merfyn
    114 Vivian Road
    Harborne
    B17 0DJ Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    114 Vivian Road
    Harborne
    B17 0DJ Birmingham
    West Midlands
    British3425330001
    RICE, Michael Joseph
    The Street
    GL9 1HH Acton Turville
    Greenfields
    Gloucestershire
    Amministratore
    The Street
    GL9 1HH Acton Turville
    Greenfields
    Gloucestershire
    United KingdomBritish140087640001
    ROBERTSON, Colin
    4 Leemuir View
    ML8 4AN Carluke
    South Lanarkshire
    Amministratore
    4 Leemuir View
    ML8 4AN Carluke
    South Lanarkshire
    British77076440001
    WATSON, Hubert John
    20 Victoria Grove
    Dollingstown Lurgan
    BT66 7JJ Craigavon
    County Armagh
    Amministratore
    20 Victoria Grove
    Dollingstown Lurgan
    BT66 7JJ Craigavon
    County Armagh
    British56996050003
    WIDMAN, Phillip Charles
    25 Old Stone Crossing
    West Simsbury
    Connecticut 06092
    Usa
    Amministratore
    25 Old Stone Crossing
    West Simsbury
    Connecticut 06092
    Usa
    UsaAmerican144249950001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TEREX LIFTING U.K. LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1FE Milton Keynes
    The Pinnacle
    England
    06 apr 2016
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1FE Milton Keynes
    The Pinnacle
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03720364
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    TEREX LIFTING U.K. LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed charge on book and other debts
    Creato il 16 mag 2002
    Consegnato il 23 mag 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book debts and other debts.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite debenture
    Creato il 04 mar 1999
    Consegnato il 25 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 25 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 04 mar 1999
    Consegnato il 25 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 25 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 04 mar 1999
    Consegnato il 25 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC
    Transazioni
    • 25 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 04 mar 1999
    Consegnato il 25 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the composite guarantee and indemnity and/or the master agreement (both as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Smurfit Paribas Bank Limited
    Transazioni
    • 25 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 04 mar 1999
    Consegnato il 25 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland,as Security Trustee for the Secured Parties(As Defined)
    Transazioni
    • 25 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 26 mar 1998
    Consegnato il 16 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    In favour of the governor and company of the bank of ireland as security trustee for the banks ("the secured parties") all monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them whether collectively or individually by the company either alone or jointly with any person or company on any account under the terms and conditions as defined in the composite debenture
    Brevi particolari
    A fixed charge over all the companys f/h and l/h lands hereditaments, premises, property and chattels both present and future including the property particulars of which are specified under the company's name in the second schedule hereto and all the company's interests in all buildings, fixtures (including, without limitation, trade fixtures) and the fixed plant and machinery from time to time thereon; all present and future plant machinery vehicles fixtures implements utensils and equipment, all goodwill and uncalled capital and all debts; floating charge over the book debts undertaking and all other property assets and rights whatsoever both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Irelandas Security Trustee for the Banks ("the Securedparties")
    Transazioni
    • 16 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0