GL EDUCATION GROUP LIMITED
Panoramica
| Nome della società | GL EDUCATION GROUP LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02603456 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GL EDUCATION GROUP LIMITED?
- Altre attività di editoria (58190) / Informazione e comunicazione
Dove si trova GL EDUCATION GROUP LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1st Floor Vantage London Great West Road TW8 9AG Brentford United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GL EDUCATION GROUP LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| GRANADA LEARNING LIMITED | 28 mar 1998 | 28 mar 1998 |
| YORKSHIRE INTERNATIONAL THOMSON MULTIMEDIA LIMITED | 30 dic 1994 | 30 dic 1994 |
| ACADEMY TELEVISION LIMITED | 19 apr 1991 | 19 apr 1991 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GL EDUCATION GROUP LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per GL EDUCATION GROUP LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 01 nov 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 15 nov 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 01 nov 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per GL EDUCATION GROUP LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Bilancio redatto al 31 dic 2024 | 34 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2025 con aggiornamenti | 9 pagine | CS01 | ||
Notifica di Renaissance Learning Uk Limited come persona con controllo significativo il 16 dic 2024 | 2 pagine | PSC02 | ||
Cessazione di Assessments Bidco Limited come persona con controllo significativo il 16 dic 2024 | 1 pagine | PSC07 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2023 | 35 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Ted Jeffrey Wolf come amministratore in data 01 nov 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Nathan Patrick Brady come amministratore in data 01 nov 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Nathan Patrick Brady come amministratore in data 18 mar 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Ted Jeffrey Wolf come amministratore in data 18 mar 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Ted Jeffrey Wolf come amministratore in data 01 gen 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Alastair David Brooks come amministratore in data 31 dic 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Dean Tilsley come amministratore in data 18 ago 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Gregor Stanley Watson come amministratore in data 30 giu 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2022 | 34 pagine | AA | ||
Soddisfazione dell'onere 026034560005 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 026034560004 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 026034560006 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 026034560007 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 026034560009 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 026034560008 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Nomina di Dean Tilsley come amministratore in data 31 mar 2023 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Neal Dittersdorf come amministratore in data 31 mar 2023 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Christopher Bauleke come amministratore in data 31 mar 2023 | 2 pagine | AP01 | ||
Chi sono gli amministratori di GL EDUCATION GROUP LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROXBURGH MILKINS LIMITED | Segretario | Wapping Road BS1 4RW Bristol Merchants House North United Kingdom |
| 190025180001 | ||||||||||
| BAULEKE, Christopher | Amministratore | Peach Street Wisconsin Rapids 2911 Wi 54494 United States | United States | American | 307860950001 | |||||||||
| DITTERSDORF, Neal | Amministratore | Peach Street Wisconsin Rapids 2911 Wi 54494 United States | United States | American | 307861660001 | |||||||||
| WOLF, Ted Jeffrey | Amministratore | Peach Street Wisconsin Rapids 2911 Wi 54494 United States | United States | American | 317617700001 | |||||||||
| BERRY, Joanna | Segretario | 105 Dock House Victoria Quays Navigation Walk LS10 1JJ Leeds Wset Yorkshire | British | 42889110004 | ||||||||||
| CARLTON, Simon | Segretario | 32 Rakehill Road Scholes LS15 4AJ Leeds West Yorkshire | British | 26138750002 | ||||||||||
| CARLTON, Simon | Segretario | 2 Arthursdale Drive Scholes LS15 4AR Leeds West Yorkshire | British | 26138750001 | ||||||||||
| HODDER, Julie Alexandra | Segretario | 15 Lakeside Terrace Rawdon LS19 6EE Leeds West Yorkshire | British | 15822850001 | ||||||||||
| HOLLAND, David Richard | Segretario | 29 Coniger Road SW6 3TB London | Australian | 109927670002 | ||||||||||
| IRVING, Eleanor Kate | Segretario | Plimsoll Road N4 2ED London 137 | British | 79177030002 | ||||||||||
| MITCHELL, Jonathan Howard | Segretario | 9 Kings Road Bramhope LS16 9JW Leeds West Yorkshire | British | 2276700001 | ||||||||||
| ROOK, Gail Ann | Segretario | 76 Atwood Road M20 6JN Manchester Lancashire | British | 123112470001 | ||||||||||
| TAUTZ, Helen Jane | Segretario | 30 South Crescent Prittlewell SS2 6TA Southend On Sea Essex | British | 37564540001 | ||||||||||
| OVALSEC LIMITED | Segretario nominato | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002570001 | |||||||||||
| ROXBURGH MILKINS LLP | Segretario | Merchants House North Wapping Road BS1 4RW Bristol | 114974370003 | |||||||||||
| YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||||||
| BLUNDELL, Phillip Robert | Amministratore | 1 Queens Road SL7 2PS Marlow Bucks | British | 58228130001 | ||||||||||
| BLUNDELL, Phillip Robert | Amministratore | 1 Queens Road SL7 2PS Marlow Bucks | British | 58228130001 | ||||||||||
| BRADY, Nathan Patrick | Amministratore | Peach Street Wisconsin Rapids 2911 Wi 54494-1905 United States | United States | American | 322891670001 | |||||||||
| BRILL, Anthony George | Amministratore | 11 Manor Farm Close Copmanthorpe YO23 3GE York North Yorkshire | England | British | 67617000001 | |||||||||
| BROOKS, Alastair David | Amministratore | Vantage London Great West Road TW8 9AG Brentford 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 266110640002 | |||||||||
| BRYER, Christopher James | Amministratore | East Wing Potterton Hall Barwick In Elmet LS15 4NN Leeds | British | 18651680001 | ||||||||||
| BURNS, Julian Delisle | Amministratore | 10 Gayton Road Hampstead NW3 1TX London | United Kingdom | British | 17986720002 | |||||||||
| CASTRO, Nicholas | Amministratore | 18 Branscombe Gardens N21 3BN London | England | British | 39006500001 | |||||||||
| COILE, Ralph John | Amministratore | 12 Grange Glow Weston Lane LS21 3SE Otley W Yorks | British | 44358890005 | ||||||||||
| CRESSWELL, John | Amministratore | Rosslyn House 8 Park Road SO22 6AA Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 39795820003 | |||||||||
| DARGUE, Robert | Amministratore | Vantage London Great West Road TW8 9AG Brentford 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 140264270001 | |||||||||
| DEAN, Martin Raymond | Amministratore | High Street Clifford LS23 6HJ Wetherby 102 West Yorkshire | England | English | 23858540003 | |||||||||
| EAGLESTONE, Adrian Alexis | Amministratore | Longmeadow Downington GL7 3DL Lechlade Gloucestershire | England | British | 73751610003 | |||||||||
| FAIRLEY, John Alexander | Amministratore | Trainers House Eddlethorpe YO17 9QS Malton North Yorkshire | England | British | 45571660001 | |||||||||
| FOSTER, Geoffrey George | Amministratore | 361 Crossley Lane WF14 0NU Mirfield W Yorks | British | 11291780001 | ||||||||||
| FUHRUEISTER, Franz Gunter | Amministratore | Am Tanzberg 5 Bonn 53229 FOREIGN Germany | German | 61232290001 | ||||||||||
| GAUVIN, Rodrigue Eugene | Amministratore | Thomas Nelson Mayfield Road KT12 5PL Walton On Thames Surrey | American | 43213630004 | ||||||||||
| GILL, Sarah | Amministratore | Oak Edge House 271 Stark Holmes Road Starkholmes DE4 5JE Matlock Derbyshire | British | 35563090001 | ||||||||||
| GRAINGER, Alfred | Amministratore | Park Lodge Gainford DL2 3DA Darlington Durham | British | 36443570002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di GL EDUCATION GROUP LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renaissance Learning Uk Limited | 16 dic 2024 | Vantage London Great West Road TW8 9AG Brentford 1st Floor United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Assessments Bidco Limited | 06 apr 2016 | Merchants House North Wapping Road BS1 4RW Bristol C/O Roxburgh Milkins Llp United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0