CCS IT LIMITED
Panoramica
Nome della società | CCS IT LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02603995 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CCS IT LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova CCS IT LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Smith Cooper 158 Edmund Street B3 2HB Birmingham |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CCS IT LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CLIMATE CHANGER SOFTWARE LIMITED | 19 mar 1999 | 19 mar 1999 |
CLIMATE CHANGER COMPUTING AND CONCESSIONAIRES LIMITED | 13 giu 1991 | 13 giu 1991 |
SAVEPROUD LIMITED | 23 apr 1991 | 23 apr 1991 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CCS IT LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per CCS IT LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 18 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2020 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Civica Uk Limited come persona con controllo significativo il 29 mar 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Southbank Central 30 Stamford Street London SE1 9LQ England a Smith Cooper 158 Edmund Street Birmingham B3 2HB in data 12 dic 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Wayne Andrew Story il 01 lug 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 2 Burston Road Putney London United Kingdom SW15 6AR a Southbank Central 30 Stamford Street London SE1 9LQ in data 01 lug 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Richard Downing come amministratore in data 19 mar 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Wayne Story come amministratore in data 04 lug 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2015 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Jan Maes come amministratore in data 27 lug 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Robert George Hewes come amministratore in data 27 lug 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2014 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 apr 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di CCS IT LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STODDARD, Michael | Segretario | 158 Edmund Street B3 2HB Birmingham Smith Cooper | 189076210001 | |||||||
ROWLAND, Phillip David | Amministratore | 158 Edmund Street B3 2HB Birmingham Smith Cooper | United Kingdom | British | Company Director | 147804610001 | ||||
STORY, Wayne Andrew | Amministratore | 158 Edmund Street B3 2HB Birmingham Smith Cooper | England | British | Company Director | 203683330002 | ||||
MAES, Jan | Segretario | 46 St Marys Fields CO3 3AE Colchester Essex | Belgian | Director | 36670180003 | |||||
WARREN, Anne Hilary | Segretario | Abbotts Hall Eight Ash Green CO6 3QL Colchester Essex | British | 10967690001 | ||||||
WARREN, Joshua | Segretario | 36 St Marys Fields CO3 3AE Colchester Essex | British | 96389180002 | ||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BRUNNING, David James | Amministratore | North Close IP4 2TL Ipswich 15 Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | It Consultant | 188695690002 | ||||
DOHERTY, James Mark | Amministratore | 2 Archers Cottages Ashdon CB10 2HB Saffron Walden Essex | British | Senior Consultant/Administrato | 62872200001 | |||||
DOWNING, Simon Richard | Amministratore | Burston Road Putney SW15 6AR London 2 United Kingdom England | England | British | Company Director | 95005230002 | ||||
ELLIS, Ian | Amministratore | Fen Cottage The Causeway, Great Horkesley CO6 4EJ Colchester Essex | England | British | Managing Director | 66543130003 | ||||
HEWES, Robert George | Amministratore | Ponden Cottage Chapel Road Langham CO4 5NZ Colchester Essex | England | British | It Consultant | 115727750001 | ||||
HYND, Peter Geoffrey | Amministratore | 6 Ridgeway WD3 7NS Rickmansworth Hertfordshire | England | British | It Consultant | 16060050001 | ||||
MAES, Jan | Amministratore | 46 St Marys Fields CO3 3AE Colchester Essex | United Kingdom | Belgian | Software Engineer | 36670180003 | ||||
RAYNER, Michael Lester Anthony | Amministratore | 20 Oakfields Road NR4 6XF Norwich Norfolk | British | Consultant | 78606500001 | |||||
SOUTHGATE, Peter Edward | Amministratore | 2 Abbotts Cottages Abbotts Lane Eight Ash Green CO6 3QL Colchester Essex | British | Accountant | 40856990001 | |||||
WARREN, Joshua | Amministratore | Middleborough Colchester The Octagon Essex England | England | British | Company Director | 96389180003 | ||||
WARREN, Joshua | Amministratore | 36 St Marys Fields CO3 3AE Colchester Essex | United Kingdom | British | Electronic Engineer | 96389180002 | ||||
WARREN, Rowland John | Amministratore | Abbotts Hall Eight Ash Green CO6 3QL Colchester Essex | British | Engineer | 10967680001 | |||||
WRIGHT, Stephen | Amministratore | 54 Piggottshill Lane AL5 1LW Harpenden Hertfordshire | British | Sales Manager | 51598380001 | |||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CCS IT LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Civica Uk Limited | 06 apr 2016 | Stamford Street SE1 9LQ London Southbank Central England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
CCS IT LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Creato il 22 gen 1999 Consegnato il 28 gen 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date (as defined) | |
Brevi particolari £14,296.81. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 17 mag 1993 Consegnato il 28 mag 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 03 giu 1992 Consegnato il 22 giu 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
CCS IT LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0