LAND TO HOMES (CAMBRIDGE) LIMITED
Panoramica
Nome della società | LAND TO HOMES (CAMBRIDGE) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02604975 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LAND TO HOMES (CAMBRIDGE) LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova LAND TO HOMES (CAMBRIDGE) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | One Chapel Place W1G 0BG London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LAND TO HOMES (CAMBRIDGE) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
JANUARYS (KING'S LYNN) LIMITED | 02 ago 1991 | 02 ago 1991 |
LEGISLATOR 1126 LIMITED | 25 apr 1991 | 25 apr 1991 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LAND TO HOMES (CAMBRIDGE) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 apr 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per LAND TO HOMES (CAMBRIDGE) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2018 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 apr 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 apr 2017 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 apr 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2016 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Simon Anthony John Pallett come amministratore in data 17 dic 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Roderick Arthur Meade il 17 dic 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Alexander Henniker-Major come amministratore in data 17 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2015 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 apr 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 43 Priestgate Peterborough PE1 1AR | AD03 | |||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 43 Priestgate Peterborough PE1 1AR | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di David James Foord come segretario in data 30 gen 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Colin William Brown come amministratore in data 30 gen 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon James Dazeley come amministratore in data 30 gen 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David James Foord come amministratore in data 30 gen 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr John Alexander Henniker-Major come amministratore in data 30 gen 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Christopher Mark Power Granger come amministratore in data 30 gen 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Roderick Arthur Meade come segretario in data 30 gen 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 giu 2015 al 30 apr 2015 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di LAND TO HOMES (CAMBRIDGE) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEADE, Roderick Arthur St John | Segretario | Chapel Place W1G 0BG London One United Kingdom | 194795480001 | |||||||
GRANGER, Christopher Mark Power | Amministratore | Chapel Place W1G 0BG London One United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 60762360001 | ||||
PALLETT, Simon Anthony John | Amministratore | Chapel Place W1G 0BG London One | England | British | Chartered Surveyor | 12456950001 | ||||
BROWN, Colin William | Segretario | 54-62 Newmarket Road CB5 8DZ Cambridge 7 Dukes Court Cambridgeshire | English | Chartered Planner | 93003560001 | |||||
DAZELEY, Simon James | Segretario | Field House 71 Impington Lane Impington CB4 9NJ Cambridge | British | Chartered Surveyor | 84771400002 | |||||
FOORD, David James | Segretario | Chapel Place W1G 0BG London One United Kingdom | 174780060001 | |||||||
POOLEY, Maureen | Segretario nominato | 12 Lodge Lane Old Catton NR6 7HG Norwich Norfolk | British | 900008180001 | ||||||
BLAKE, Christopher Paul Forbes | Amministratore | Church House Little Wratting CB9 7UG Haverhill Suffolk | England | English | Chartered Surveyor | 15761880001 | ||||
BROWN, Colin William | Amministratore | Chapel Place W1G 0BG London One United Kingdom | England | English | Planning Consultant | 93003560001 | ||||
CALLIN, John Daniel | Amministratore | 54-62 Newmarket Road CB5 8DZ Cambridge 7 Dukes Court Cambridgeshire | England | British | Chartered Surveyor | 15761890001 | ||||
DAZELEY, Derek Arthur | Amministratore | Chesterton House Church Street Chesterton CB4 1DT Cambridge Cambridgeshire | England | British | Chartered Surveyor | 7806230001 | ||||
DAZELEY, Simon James | Amministratore | Chapel Place W1G 0BG London One United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 84771400002 | ||||
FOORD, David James | Amministratore | Chapel Place W1G 0BG London One United Kingdom | England | British | Company Director | 122984840002 | ||||
HENNIKER-MAJOR, John Alexander | Amministratore | Chapel Place W1G 0BG London One United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 47621720002 | ||||
MCGURK, Anthony Justin Gerard | Amministratore delegato nominato | 32 College Road Norwich Norfolk | British | 900008170001 | ||||||
POOLEY, Maureen | Amministratore delegato nominato | 12 Lodge Lane Old Catton NR6 7HG Norwich Norfolk | British | 900008180001 | ||||||
SCOTT, Robert | Amministratore | Meadow Farm Common Lane North Runcton PE33 0RD Kings Lynn Norfolk | British | Chartered Surveyor | 15761910001 | |||||
WILSON, Edward John | Amministratore | 28 Montague Road CB4 1BX Cambridge Cambridgeshire | British | Chartered Town Planner | 15761900001 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per LAND TO HOMES (CAMBRIDGE) LIMITED?
Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
---|---|---|
13 apr 2017 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
LAND TO HOMES (CAMBRIDGE) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 15 gen 2014 Consegnato il 30 gen 2014 | In corso | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 31 mar 2009 Consegnato il 18 apr 2009 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
An omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 05 nov 2008 Consegnato il 12 nov 2008 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 03 set 1991 Consegnato il 10 set 1991 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari And heritable property & asses in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0