BRITSHIP FOUR LIMITED

BRITSHIP FOUR LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRITSHIP FOUR LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02606797
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BRITSHIP FOUR LIMITED?

    • (6110) /

    Dove si trova BRITSHIP FOUR LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BRITSHIP FOUR LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BLUE STAR LINE (NORTH AMERICA) LIMITED06 dic 199606 dic 1996
    BLUE STAR (NORTH AMERICA) LIMITED15 ott 199215 ott 1992
    BLUE STAR PACE LIMITED30 ago 199130 ago 1991
    VALUEMODEL LIMITED01 mag 199101 mag 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRITSHIP FOUR LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per BRITSHIP FOUR LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    13 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Maersk House Braham Street London E1 8EP in data 22 ott 2010

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 14 ott 2010

    LRESSP

    Cessazione della carica di James Burridge come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Mr Martyn Clive Allen come amministratore

    3 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 apr 2010

    Stato del capitale al 29 apr 2010

    • Capitale: GBP 1,000,000
    SH01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    1 pagineMG02

    legacy

    1 pagineMG02

    legacy

    1 pagineMG02

    legacy

    1 pagineMG02

    Dettagli del segretario cambiati per John Kilby il 22 dic 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per John Kilby il 22 dic 2009

    2 pagineCH01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed blue star line (north america) LIMITED\certificate issued on 23/07/09
    2 pagineCERTNM

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    4 pagineAA

    legacy

    4 pagine288a

    legacy

    4 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di BRITSHIP FOUR LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KILBY, John, Mr.
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    1
    Segretario
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    1
    British76247880001
    ALLEN, Martyn Clive
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    1
    Amministratore
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    1
    United KingdomBritish117739980001
    KILBY, John, Mr.
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    1
    Amministratore
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    1
    EnglandBritish76247880001
    BECKETT, Geoffrey John
    48 Galton Road
    SS0 8LA Westcliff On Sea
    Essex
    Segretario
    48 Galton Road
    SS0 8LA Westcliff On Sea
    Essex
    British1964450001
    CHEESEMAN, Guy Robert
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    Segretario
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    British7865940001
    MCGEOCH, Christopher
    Longfield House
    Longfield Hill
    DA3 7AS Kent
    Segretario
    Longfield House
    Longfield Hill
    DA3 7AS Kent
    British40359510005
    WALKERLEY, Dennis John
    18 Paddock Close
    Nobles Green Eastwood
    SS9 5QR Leigh On Sea
    Essex
    Segretario
    18 Paddock Close
    Nobles Green Eastwood
    SS9 5QR Leigh On Sea
    Essex
    British73793480001
    ZIMMER, Kaarina Ann
    Riowstraat 43
    2585 Gs
    The Hague
    Netherlands
    Segretario
    Riowstraat 43
    2585 Gs
    The Hague
    Netherlands
    British104894830001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALLEN, Martyn Clive
    17 Inglis Road
    CO3 3HU Colchester
    Essex
    Amministratore
    17 Inglis Road
    CO3 3HU Colchester
    Essex
    United KingdomBritish117739980001
    BURRIDGE, James George Thomas
    Julien Road
    W5 4XA London
    5
    Amministratore
    Julien Road
    W5 4XA London
    5
    EnglandUnited Kingdom59355820001
    CHEESEMAN, Guy Robert
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    Amministratore
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    United KingdomBritish7865940001
    COLLINS, John Alexander, Sir
    Flat 4
    63 Millbank Terraces
    SW1P 4RW London
    Amministratore
    Flat 4
    63 Millbank Terraces
    SW1P 4RW London
    British53032980001
    COOKE, Anthony Roderick Chichester Bancroft
    Poland Court
    RG29 1JL Odiham
    Hampshire
    Amministratore
    Poland Court
    RG29 1JL Odiham
    Hampshire
    EnglandBritish5503780001
    COOPER, Robert Hamilton
    Great Yews
    Lubbock Road
    BR7 5LA Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    Great Yews
    Lubbock Road
    BR7 5LA Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish11632250002
    CORNTHWAITE, Christopher John
    24 The Drive
    TN13 3AE Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    24 The Drive
    TN13 3AE Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish34530990002
    HABGOOD, David John Cecil
    Richmond Cottage
    21 Ashley Park Avenue
    KT12 1ER Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    Richmond Cottage
    21 Ashley Park Avenue
    KT12 1ER Walton On Thames
    Surrey
    EnglandBritish29831660001
    HAZLITT, Basil Rodney
    Cousins Farm
    The Haven
    RH14 9BE Nr.Billingshurst
    West Sussex
    Amministratore
    Cousins Farm
    The Haven
    RH14 9BE Nr.Billingshurst
    West Sussex
    British1594150002
    MONEY, Timothy John
    Riverdale
    148 Peperharow Road
    GU7 2PW Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Riverdale
    148 Peperharow Road
    GU7 2PW Godalming
    Surrey
    EnglandBritish71374890003
    O'BRIEN, Bernadette Mary
    10 Stormont Road
    Highgate
    N6 4NL London
    Amministratore
    10 Stormont Road
    Highgate
    N6 4NL London
    EnglandIrish95129740001
    PUSEY, Nigel Simon
    Roslyns
    Water Lane
    CB9 7AL Helions Bumpstead
    Suffolk
    Amministratore
    Roslyns
    Water Lane
    CB9 7AL Helions Bumpstead
    Suffolk
    British83149350005
    RANKIN, Christopher John
    535 East 86th Apt 19a
    10028 New York City
    New York
    United States
    Amministratore
    535 East 86th Apt 19a
    10028 New York City
    New York
    United States
    British58089240001
    ROBBIE, David Andrew
    4 St Johns House 30 Smith Square
    SW1P 3HF London
    Amministratore
    4 St Johns House 30 Smith Square
    SW1P 3HF London
    United KingdomBritish108246820001
    SEYMOUR, Michael John Spencer
    22 Mirabel Road
    Fulham
    SW6 7EH London
    Amministratore
    22 Mirabel Road
    Fulham
    SW6 7EH London
    British17737160003
    WALKER, Peter Arthur
    64 Connaught Avenue
    Chingford
    E4 7AA London
    Amministratore
    64 Connaught Avenue
    Chingford
    E4 7AA London
    United KingdomBritish708770001
    WEATHERSTON, Ian Robert
    12 Chillis Wood Road
    RH16 1JT Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    12 Chillis Wood Road
    RH16 1JT Haywards Heath
    West Sussex
    EnglandBritish207360001
    WOODS, Robert Barclay
    Old Rectory
    Frilsham
    RG18 9XH Newbury
    Amministratore
    Old Rectory
    Frilsham
    RG18 9XH Newbury
    EnglandBritish154397820001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    BRITSHIP FOUR LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Subordination agreement
    Creato il 20 feb 1997
    Consegnato il 07 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or owing by the company and/or any of the other companies named therein to the senior creditors (as defined therein) under or in connection with the senior finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    All payments in cash or in kind in respect of the subordinated debt (as defined therein), and any payment in respect of any security interest or under any guarantee thereunder and payments on account of the purchase or other acquisition thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Agent and Trustee for Itself and the Seniorcreditors)
    Transazioni
    • 07 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Shares pledge
    Creato il 20 feb 1997
    Consegnato il 10 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company and each obligor pursuant to the terms of the finance documents or any other document evidencing or security for any such liabilities
    Brevi particolari
    Its whole right title and interes and benefit in and to the pledged securities and the related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and Each of the Finance Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 10 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of covenants
    Creato il 23 dic 1993
    Consegnato il 12 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the guarantee the mortgage this deed and the other security documents
    Brevi particolari
    The vessel and the insurances the earnings and requisition compensation the vessel means the M.V. "sydney star". See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transazioni
    • 12 gen 1994Registrazione di un'ipoteca
    • 03 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 08 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    • 08 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second assignment of insurances
    Creato il 23 dic 1993
    Consegnato il 12 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the guarantee,this assignment and the other security documents to which the company is a party
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to the insurances relating to the vessel "sydney star". See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transazioni
    • 12 gen 1994Registrazione di un'ipoteca
    • 03 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    • 03 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 08 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 20 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Second priority bahamian statutory ship mortgage
    Creato il 23 dic 1993
    Consegnato il 12 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of a second priority deed of covenants dated 23RD december 1993 and two demise charterparties both dated 30TH september 1993 and regulated by a guarantee dated 23RD december 1993 to be amended supplemented and/or varied from time to time
    Brevi particolari
    The M.V. "sydney star" registered with official no 343036.
    Persone aventi diritto
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transazioni
    • 12 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 08 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second priority bahamian statutory mortgage
    Creato il 23 dic 1993
    Consegnato il 12 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of a second priority deed of covenants dated 23RD december 1993 and two demise charterparties both dated 30TH september 1993 and regulated by a guarantee dated 23RD december 1993 to be amended supplemented and/or varied from time to time
    Brevi particolari
    Motor vessel "america star" official no 341451.
    Persone aventi diritto
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transazioni
    • 12 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 27 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second assignment
    Creato il 23 dic 1993
    Consegnato il 12 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the guarantee,this assignment the charterparties and the other security documents to which the assignor is a party
    Brevi particolari
    All freights hire passage monies demurrage detention monies and all monies arising out of the use of the M.V. "sydney star" official no 343036.
    Persone aventi diritto
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transazioni
    • 12 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 03 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    • 08 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of covenants
    Creato il 23 dic 1993
    Consegnato il 12 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the guarantee,this assignment,the mortgage and the other security documents to which the company is a party
    Brevi particolari
    The vessel M.V. "america star" ,the insurance and all benefits thereof the earnings and requisiton compensation. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transazioni
    • 12 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mag 1997Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 27 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second assignment of insurances
    Creato il 23 dic 1993
    Consegnato il 12 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the guarantee,this assignment and the other security documents to which the company is a party
    Brevi particolari
    All of the company's right title and interest in and to the insurances as defined on the reverse of the form 395 relating to M.V. "america star" official NO341456.
    Persone aventi diritto
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transazioni
    • 12 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mag 1997Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 27 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second assignment of earnings
    Creato il 23 dic 1993
    Consegnato il 12 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the guarantee this assignment,the charterparties and the other security documents to which the company is a party
    Brevi particolari
    All freights hire passage monies demurrage detention monies and all other monies arising out of the use of the vessel M.V. "america star" official no 241451. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transazioni
    • 12 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mag 1997Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 27 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second priority general assignmnent
    Creato il 23 dic 1993
    Consegnato il 11 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or blue star line limited to the chargee under or pursuant to the charterparties (as defined) and the security documents (as defined)
    Brevi particolari
    All earnings (as defined) the insurances and all requisition compensation relating to the ship "melbourne star". See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second priority statutory mortgage
    Creato il 23 dic 1993
    Consegnato il 11 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or blue star line limited in respect of an account current regulated by the charterparties (as defined) and a deed of covenant dated 23RD december 1993 as supplemented and amended from time to time
    Brevi particolari
    All the company's 64 64TH shares of the "melbourne star" and in her boats guns,ammunition,small arms and appurtenances.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second priority deed of covenants
    Creato il 23 dic 1993
    Consegnato il 11 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or blue star line limited to the chargee under or pursuant to the charterparties (as defined) and the security documents (as defined)
    Brevi particolari
    All of the company's right title and interest present and future in and to the ship M.V. "melbourne star". See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    General assignment
    Creato il 23 dic 1993
    Consegnato il 04 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Us $ 6,175,000 due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 7TH january 1993 as amended by a supplemental agreement dated 23RD december 1993 and any other monies payable under the loan agreement and security docements (as defined)
    Brevi particolari
    All monies due to the company arising out of the use of M.V. `melbourne star' all policies and contracts of insurance in respect of the ship. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 20 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    First priority bahamian statutory mortgage
    Creato il 23 dic 1993
    Consegnato il 04 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Us $ 6,175,000 due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 7TH january 1993 as amended by a supplemental agreement dated 23RD december 1993 and any other monies payable under the loan agreement and security documents (as defined)
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest present and future in the M.V. `melbourne star' registered in the bahamas official number 342859.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 20 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of covenants
    Creato il 23 dic 1993
    Consegnato il 04 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Us $ 6,175,000 due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 7TH january 1993 as amended by a supplemental agreement dated 23RD december 1993 and any other monies payable under the loan agreement and the security documents (as defined)
    Brevi particolari
    All the company's right,title and interest present and future in and to M.V. `melbourne star' registered in the bahamas official number 342859.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 20 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Second reinsurance agreement assignment
    Creato il 13 lug 1993
    Consegnato il 30 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or albion insurance company limited to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined)
    Brevi particolari
    All right title and interest in the "reinsurances" (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second assignment of insurances
    Creato il 13 lug 1993
    Consegnato il 30 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties and to the secured parties and to the secured parties or any of them subject to the covenants,undertakings,guarantees and agreements contained in the assignment and in any of the other security documents (as defined)
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to all policies of insurance relating to the bahamian vessel M.V. "brisbane star" see form 395 M9 for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 30 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second assignment of earnings
    Creato il 13 lug 1993
    Consegnato il 30 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties and to the secured parties (as defined) or any of them subject to the covenants undertakings guarantees and agreements contained in the assignment and any of the other security documents as(as defined)
    Brevi particolari
    All freights charterhire and other earnings of whatsoever nature of the company's bahamian registered vessel "brisbane star" see form 395 M8 for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC (As Sedcurity Trustee)
    Transazioni
    • 30 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second priority deed of covenants
    Creato il 13 lug 1993
    Consegnato il 30 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties and to the secured parties (as defined) or any of them subject to the covenants,undertakings,guarantees and agreements contained in the deed of covenants and any of the other security documents (as defined)
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the M.V.brisbane star and the insurances and all benefits thereof see form 395 M7 for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 30 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second priority bahamian statutory ship mortgage
    Creato il 13 lug 1993
    Consegnato il 30 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties and the secured parties (as defined) or any of them on an account current as regulated by the facility agreements (as defined) the guarantee and the mortgage debenture both dated 22/05/92 and a deed of covenants dated 13/07/93
    Brevi particolari
    All 64/64TH shares in the company's bahamian registered vessel M.V. brisbane star having official number 723468 and all benefits relating thereto see form 395 M6 for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 30 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An assignment agreement
    Creato il 13 lug 1993
    Consegnato il 21 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 12/07/93 and/or under the security documents (as defined)
    Brevi particolari
    The earnings being all freight,hire and any other amounts which may be earned or payable to or for the account of the company or their agents arising from ownership of the ship and the insurances of the ship. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mag 1997Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of covenant
    Creato il 13 lug 1993
    Consegnato il 21 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 12/07/93 and/or under the security documents (as defined)
    Brevi particolari
    M.V. "brisbane star" registered in the port of nassau under official no:723468 including any share or interest therein and the hull,machinery and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mag 1997Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First statutory mortgage
    Creato il 13 lug 1993
    Consegnato il 21 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of the facility letter dated 12/07/93 and/or the security documents (as defined) and/or the deed of covenants
    Brevi particolari
    M.V. "brisbane star" registered in the name of the company at the port of nassau under official no:723468 including any share or interest therein and the hull,machinery and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mag 1997Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First priority deed of covenants
    Creato il 26 mag 1992
    Consegnato il 10 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (in it's capacity as security trustee under the assignment and in it's capacity as the co-ordinator under an overrideagreement dated 220592)and all or any of the lenders named therein on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All right title and interest present and future in the bahamian flag vessel "queensland star" see form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BRITSHIP FOUR LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 ott 2010Inizio della liquidazione
    19 ago 2011Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Praticante
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0