BONHILL GROUP PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBONHILL GROUP PLC
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 02607995
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di BONHILL GROUP PLC?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova BONHILL GROUP PLC?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Begbies Traynor (London) Llp
    31st Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BONHILL GROUP PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VITESSE MEDIA PLC24 lug 200124 lug 2001
    E-VITESSE PLC17 dic 199917 dic 1999
    PRESS VITESSE PLC14 mag 199914 mag 1999
    BREMONHILL PLC22 set 199722 set 1997
    TUDOR MYLES & COMPANY PLC03 mag 199103 mag 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di BONHILL GROUP PLC?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2023
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 giu 2024
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2022

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per BONHILL GROUP PLC?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al04 mag 2024
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma18 mag 2024
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al04 mag 2023
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per BONHILL GROUP PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 31 lug 2024

    20 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 01 ago 2023

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Virtual Company Secretary Ltd 7 York Road Woking GU22 7XH United Kingdom a C/O Begbies Traynor (London) Llp 31st Floor, 40 Bank Street London E14 5NR in data 31 lug 2023

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Louise Emily Park come segretario in data 31 lug 2023

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di John Gerald French come amministratore in data 27 giu 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard Adam Staveley come amministratore in data 23 giu 2023

    1 pagineTM01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2022

    51 pagineAA

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 24 apr 2023

    • Capitale: GBP 3,169,076.87
    5 pagineSH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 24 apr 2023

    • Capitale: GBP 3,169,076.87
    8 pagineSH01

    Stato del capitale al 15 mag 2023

    • Capitale: GBP 1,192,886.87
    5 pagineSH19

    legacy

    2 pagineOC138

    Certificato di riduzione del capitale emesso e premio azionario e cancellazione del premio azionario

    1 pagineCERT17

    Cessazione della carica di Jonathan Kempster come amministratore in data 31 mar 2023

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 026079950007 in pieno

    1 pagineMR04

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    resolution

    Risoluzione di capitalizzazione o emissione di azioni bonus

    Sum of £1,976190 to be capitalised 27/02/2023
    RES14
    capital

    Risoluzioni

    Creation of new class of share 27/02/2023
    RES13
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Indirizzo della sede legale modificato da 29 Clerkenwell Road London EC1M 5RN United Kingdom a C/O Virtual Company Secretary Ltd 7 York Road Woking GU22 7XH in data 28 feb 2023

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Patrick Francis Ponsford come amministratore in data 28 feb 2023

    1 pagineTM01

    Iscrizione dell'ipoteca 026079950007, creata il 06 feb 2023

    55 pagineMR01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Laurie Benson il 15 dic 2022

    2 pagineCH01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di BONHILL GROUP PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BENSON, Laurie
    31st Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    C/O Begbies Traynor (London) Llp
    United Kingdom
    Amministratore
    31st Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    C/O Begbies Traynor (London) Llp
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director174951180002
    GLASSPOOL, Jonathan Rennie
    31st Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    C/O Begbies Traynor (London) Llp
    United Kingdom
    Amministratore
    31st Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    C/O Begbies Traynor (London) Llp
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector88953880003
    THOMPSON, Sarah Louise
    31st Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    C/O Begbies Traynor (London) Llp
    United Kingdom
    Amministratore
    31st Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    C/O Begbies Traynor (London) Llp
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector274241350001
    PARK, Louise Emily
    7 York Road
    GU22 7XH Woking
    C/O Virtual Company Secretary Ltd
    United Kingdom
    Segretario
    7 York Road
    GU22 7XH Woking
    C/O Virtual Company Secretary Ltd
    United Kingdom
    247926410001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Segretario
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    128593690002
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    United Kingdom
    Segretario
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06902863
    140723560001
    BROADBENT, Christopher Donald
    Flat 5
    Zaire Court Vlotaire Road
    SW4 6DE London
    Amministratore
    Flat 5
    Zaire Court Vlotaire Road
    SW4 6DE London
    BritishSales Director103044430001
    BRODE, Andrew Stephen
    Marsham Way
    SL9 8BQ Gerrards Cross
    Europa House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Marsham Way
    SL9 8BQ Gerrards Cross
    Europa House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishPublisher24654990002
    BROOKES, Nicola
    Amadeus 26a Holloway Lane
    Chesham Bois
    HP6 6DJ Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Amadeus 26a Holloway Lane
    Chesham Bois
    HP6 6DJ Amersham
    Buckinghamshire
    OtherFinance Director16704220001
    BROWN, David Anthony
    Fleet House
    59-61 Clerkenwell Road
    EC1M 5LA London
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    Fleet House
    59-61 Clerkenwell Road
    EC1M 5LA London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector163139060001
    COPELAND, Leslie Jason
    Hanley Road
    Stroud Green
    N4 3DQ London
    81a
    Amministratore
    Hanley Road
    Stroud Green
    N4 3DQ London
    81a
    United KingdomBritishCeo75778120002
    DONOGHUE, Anne Elizabeth
    Clerkenwell Road
    EC1M 5RN London
    29
    United Kingdom
    Amministratore
    Clerkenwell Road
    EC1M 5RN London
    29
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector221051590001
    DOWDALL, Nicola Jane
    Bonhill Street
    EC2A 4BX London
    14
    United Kingdom
    Amministratore
    Bonhill Street
    EC2A 4BX London
    14
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Operating Officer139921040005
    FRENCH, John Gerald
    7 York Road
    GU22 7XH Woking
    C/O Virtual Company Secretary Ltd
    United Kingdom
    Amministratore
    7 York Road
    GU22 7XH Woking
    C/O Virtual Company Secretary Ltd
    United Kingdom
    United StatesAmericanDirector297958030001
    GRAY, Fraser James
    Fleet House
    59-61 Clerkenwell Road
    EC1M 5LA London
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    Fleet House
    59-61 Clerkenwell Road
    EC1M 5LA London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector141897860002
    HALL, Clive Jonathan
    32 Elsynge Road
    Wandsworth
    SW18 2HN London
    Amministratore
    32 Elsynge Road
    Wandsworth
    SW18 2HN London
    EnglandBritishFinance Director116004780001
    HUMPHREY, Catherine Lesley
    6 St Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    6 St Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director238229820001
    INGRAM, Christopher John
    85 Tottenham Court Road
    W1T 4TQ London
    Ingram Enterprise Investors Llp
    United Kingdom
    Amministratore
    85 Tottenham Court Road
    W1T 4TQ London
    Ingram Enterprise Investors Llp
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector154163880001
    INGRAM, Christopher John
    Ridgemount
    Shere Road
    KT24 6EF West Horsley
    Surrey
    Amministratore
    Ridgemount
    Shere Road
    KT24 6EF West Horsley
    Surrey
    United KingdomBritishDirector154163880001
    KEMPSTER, Jonathan
    7 York Road
    GU22 7XH Woking
    C/O Virtual Company Secretary Ltd
    United Kingdom
    Amministratore
    7 York Road
    GU22 7XH Woking
    C/O Virtual Company Secretary Ltd
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector153034830002
    KINGWILL, Kymberley Newton
    49 Derwent Avenue
    Kingston Vale
    SW15 3RA London
    Amministratore
    49 Derwent Avenue
    Kingston Vale
    SW15 3RA London
    United KingdomBritishFinance Director2550080002
    MEARNS, Alan Adam
    The Moorings
    Willoughby Road
    TW1 2QG East Twickenham
    4
    United Kingdom
    Amministratore
    The Moorings
    Willoughby Road
    TW1 2QG East Twickenham
    4
    United Kingdom
    EnglandBritishInvestor 87187610002
    NISSIM, Leigh
    89 Lyndhurst Gardens
    N3 1TE London
    Amministratore
    89 Lyndhurst Gardens
    N3 1TE London
    EnglandBritishChief Operating Officer112210960001
    PONSFORD, Patrick Francis
    Clerkenwell Road
    EC1M 5RN London
    29
    United Kingdom
    Amministratore
    Clerkenwell Road
    EC1M 5RN London
    29
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector194132690001
    RIDDELL, Charles Edward
    198 Crondall Street
    N1 6JQ London
    Flat 5
    United Kingdom
    Amministratore
    198 Crondall Street
    N1 6JQ London
    Flat 5
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director240393780001
    SACHDEV, Nilesh
    Clerkenwell Road
    EC1M 5RN London
    29
    United Kingdom
    Amministratore
    Clerkenwell Road
    EC1M 5RN London
    29
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector242492030001
    SMITH, David John
    South Close
    RG40 2QJ Wokingham
    10
    Berks
    United Kingdom
    Amministratore
    South Close
    RG40 2QJ Wokingham
    10
    Berks
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector81852060001
    STAVELEY, Richard Adam
    7 York Road
    GU22 7XH Woking
    C/O Virtual Company Secretary Ltd
    United Kingdom
    Amministratore
    7 York Road
    GU22 7XH Woking
    C/O Virtual Company Secretary Ltd
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director288957150001
    STEWART, Derek George
    Rectory Lane
    Sidcup
    DA14 4QN Kent
    39
    United Kingdom
    Amministratore
    Rectory Lane
    Sidcup
    DA14 4QN Kent
    39
    United Kingdom
    EnglandBritishInvestment Manager151729050001
    STILWELL, Simon Leslie
    Clerkenwell Road
    EC1M 5RN London
    29
    United Kingdom
    Amministratore
    Clerkenwell Road
    EC1M 5RN London
    29
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector237193370007
    SUMNER, Jonathan
    Sydney Road
    Rayners Park
    SW20 8EG London
    89
    United Kingdom
    Amministratore
    Sydney Road
    Rayners Park
    SW20 8EG London
    89
    United Kingdom
    EnglandBritishMedia169076260001
    TAGG, Stephen John
    133b Highbury New Park
    N5 2DS London
    Amministratore
    133b Highbury New Park
    N5 2DS London
    BritishElectronic Pub Manager67600120001
    WILLEY, Keith James, Mr.
    Cleveland Road
    SW13 0AB Barnes
    36
    London
    United Kingdom
    Amministratore
    Cleveland Road
    SW13 0AB Barnes
    36
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector86190420001
    WILLIAMS, Elizabeth Sara
    30 Lydon Road
    Clapham
    SW4 0HW London
    Amministratore
    30 Lydon Road
    Clapham
    SW4 0HW London
    BritishPublisher & Executive Chairman41461550001
    WILLIAMS, Owen Emyr
    Ground Floor Flat
    53 Hambalt Road Clapham
    SW4 9EQ London
    Amministratore
    Ground Floor Flat
    53 Hambalt Road Clapham
    SW4 9EQ London
    BritishMarketing Director76639410001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per BONHILL GROUP PLC?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    26 giu 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    BONHILL GROUP PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 06 feb 2023
    Consegnato il 07 feb 2023
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rockwood Strategic PLC
    Transazioni
    • 07 feb 2023Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 13 mar 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 08 ott 2013
    Consegnato il 08 ott 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Convertible loan agreement.
    Persone aventi diritto
    • David Smith
    • Andrew Brode
    • Esm Williams
    Transazioni
    • 08 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 apr 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Loan agreement
    Creato il 15 mag 2012
    Consegnato il 01 giu 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £25,000 due or to become due
    Brevi particolari
    The assets of the business including brands, databases, websites, magazine titles, events and archives.
    Persone aventi diritto
    • P.R.T. Williams and G.S.M. Williams
    Transazioni
    • 01 giu 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 27 mag 2008
    Consegnato il 29 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 29 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 18 gen 2008
    Consegnato il 28 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Omnibus letter of set-off
    Creato il 05 nov 2007
    Consegnato il 09 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the the company and m & a deals limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 26 gen 1999
    Consegnato il 02 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 02 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    BONHILL GROUP PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 ago 2023Inizio della liquidazione
    30 giu 2023Data della dichiarazione di solvibilità giurata
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Gary Paul Shankland
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Praticante
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Mark Robert Fry
    Begbies Traynor 31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Praticante
    Begbies Traynor 31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0