CHEQUERS ESTATES LIMITED

CHEQUERS ESTATES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCHEQUERS ESTATES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02620147
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CHEQUERS ESTATES LIMITED?

    • (7011) /
    • (7020) /

    Dove si trova CHEQUERS ESTATES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4th Floor 4 Victoria Square
    AL1 3TF St Albans
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CHEQUERS ESTATES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STATUS BELL PROPERTIES LIMITED08 feb 199308 feb 1993
    CLASSIC ELECTROPLATING LIMITED13 giu 199113 giu 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di CHEQUERS ESTATES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2005

    Quali sono le ultime deposizioni per CHEQUERS ESTATES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Domanda di insolvenza

    INSOLVENCY:final report for period up to close.
    11 pagineLIQ MISC

    Avviso di conto finale prima della dissoluzione

    1 pagine4.43

    Indirizzo della sede legale modificato da , Kingston Smith & Partners Llp, 105 st Peters Street, St Albans, Hertfordshire, AL1 3EJ a 4th Floor 4 Victoria Square St Albans Hertfordshire AL1 3TF in data 06 set 2016

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore

    1 pagine4.31

    legacy

    1 pagine287

    Nomina di un liquidatore

    1 pagine4.31

    Ordine del tribunale di liquidazione

    1 pagineCOCOMP

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    legacy

    6 pagine395

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2005

    9 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    5 pagine395

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2004

    9 pagineAA

    legacy

    5 pagine395

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2003

    8 pagineAA

    legacy

    5 pagine395

    Chi sono gli amministratori di CHEQUERS ESTATES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HURSEY, Janet
    1 Ayres Close
    HP21 8PJ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Segretario
    1 Ayres Close
    HP21 8PJ Aylesbury
    Buckinghamshire
    British126295310001
    BUTLER, Thomas Joseph
    The Old Vicarage
    HP17 8AE Haddenham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Old Vicarage
    HP17 8AE Haddenham
    Buckinghamshire
    United KingdomIrish7999050002
    BUTLER, Sean Colm
    25 Bonnersfield
    Long Crendon
    HP18 9DJ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Segretario
    25 Bonnersfield
    Long Crendon
    HP18 9DJ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Irish11999370001
    GRAEME, Dorothy May
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Segretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001330001
    BUTLER, Tracy Jane
    The Old Vicarage
    Haddenham
    HP17 8AE Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Haddenham
    HP17 8AE Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish123593790001
    CROKE, John Noel
    31 High Street
    HP17 8ES Haddenham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    31 High Street
    HP17 8ES Haddenham
    Buckinghamshire
    EnglandIrish115115430001
    GRAEME, Lesley Joyce
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Amministratore delegato nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001320001
    PELLING, Timothy Gordon
    Walnut Tree House Mill Road
    Shiplake
    RG9 3LW Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Walnut Tree House Mill Road
    Shiplake
    RG9 3LW Henley On Thames
    Oxfordshire
    EnglandBritish20364950001

    CHEQUERS ESTATES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security assignment
    Creato il 24 set 2008
    Consegnato il 26 set 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the beneficiaries
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to or under or arising from the sale agreement meaning an agreement dated 22 august 2008 relating to the sale of f/h property k/a 17-25 octagon parage and 9-16 oxford street, high wycombe buckinghamshire t/no BM114958 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 26 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 31 mag 2006
    Consegnato il 14 giu 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from mentmore hotels and leisure (hertfordshire) limited to the chargee or any associated company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a 44 and 46 station road princes risborough bucks t/no BM227756, cornwall house station approach station road princes risborough bucks t/no BM165624 and 17-25 octagon parade high wycombe bucks and 9-16 oxford street high wycombe bucks t/no BM114958 including all buildings and other structures erected thereon and all fixtures by way of fixed charge the benefit of any covenants for title given or entered into, all proceeds of a capital nature in relation to the disposal of the property, the benefit of contract of sale letting or other disposal and all options to renew all leases or purchase all reversions in relation to each of the properties. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transazioni
    • 14 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 21 ott 2005
    Consegnato il 25 ott 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a 17-25 octagon parade and 9-16 oxford street high wycombe buckinghamshire t/n BM114958 assigns the rental income, the benefit of all guarantees warranties and representations, the benefit of all agreements for lease and all sums payable to the company under or in respect of any agreement for lease.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 25 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 28 feb 2005
    Consegnato il 02 mar 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The properties, all plant and machinery, all intellectual property, all goodwill and uncalled capital, the securities , the debts and all rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 02 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 07 apr 2000
    Consegnato il 21 apr 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Cornnwall house station approach princes risborrough buckinghamshire t/n BM165624. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 21 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 17 dic 1999
    Consegnato il 22 dic 1999
    In corso
    Importo garantito
    £350,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The royal castle hotel lynton devon and land adjoining.
    Persone aventi diritto
    • Robert William Steel
    Transazioni
    • 22 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 17 dic 1999
    Consegnato il 21 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £692,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Plots 1 and 2 brunel park aylesbury bucks.
    Persone aventi diritto
    • Robert Wiiliam Steel
    Transazioni
    • 21 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 giu 1998
    Consegnato il 26 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    An agreement dated 5/5/98..any rental income (if any)..floating charge. Undertaking and all property and assets. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 26 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 ott 1997
    Consegnato il 14 ott 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 44 & 46 station road and land adjoining prices risborough bucks. F/h property comprising the former gas depot at the junction of summersley road and manor park avenue princes risborough. By way of fixed charge all rental income present or future. By way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 24 feb 1997
    Consegnato il 27 feb 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property k/a 95 cumnor hill cumnor oxford t/n BK50985 together with all rental income present and future floating charge the undertaking and all other property assets and rights. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 27 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 08 nov 1996
    Consegnato il 15 nov 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement and/or this charge
    Brevi particolari
    All that land forming on the east side of church street bloxham t/no ON176996 & fixed charge all rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 15 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 05 mag 1995
    Consegnato il 06 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £140,000.00
    Brevi particolari
    The manor house bloxham oxfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Bulldog Properties Limited
    Transazioni
    • 06 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 mar 1995
    Consegnato il 01 apr 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Legal charge over f/h property k/a the old school church street bloxam oxfordshire t/n ON164367. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corp PLC
    Transazioni
    • 01 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge on deposit account
    Creato il 25 gen 1995
    Consegnato il 27 gen 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All sums under account no.313/310999/10 Opened with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 27 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 25 gen 1995
    Consegnato il 27 gen 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the east side of townside haddenham bucks t/no.BM72181. Land at the east side of townside haddenham bucks t/no.BM72180. The fire station townside road haddenham bucks t/no.BM3338. All land at the east side of townside haddenham bucks. Land at old school bloxham oxon. Fixed and floating charges over all undertaking and assets including goodwill and uncallled capital and book debts.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 27 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)

    CHEQUERS ESTATES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 ott 2016Conclusione della liquidazione
    11 nov 2008Data della petizione
    21 gen 2009Inizio della liquidazione
    19 gen 2017Data di scioglimento
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praticante
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Ian Mark Defty
    Kingston Smith & Partners Llp
    105 St Peter'S Street
    AL1 3EJ St Albans
    Hertfordshire
    Praticante
    Kingston Smith & Partners Llp
    105 St Peter'S Street
    AL1 3EJ St Albans
    Hertfordshire
    Michaela Joy Hall
    Kingston Smith And Partners
    105 St Peter'S Street
    AL1 3EJ St Albans
    Hertfordshire
    Praticante
    Kingston Smith And Partners
    105 St Peter'S Street
    AL1 3EJ St Albans
    Hertfordshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0