AMPWYN DEVELOPMENTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | AMPWYN DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02623933 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di AMPWYN DEVELOPMENTS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova AMPWYN DEVELOPMENTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 125 Colmore Row B3 3SD Birmingham |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di AMPWYN DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| YOUNGDRAW LIMITED | 26 giu 1991 | 26 giu 1991 |
Quali sono gli ultimi bilanci di AMPWYN DEVELOPMENTS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per AMPWYN DEVELOPMENTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 10 pagine | 4.71 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Gate House Turnpike Road High Wycombe Buckinghamshire HP12 3NR in data 13 nov 2012 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Risoluzione di insolvenza Resolution insolvency:special resolution ;- "in specie" | 1 pagine | LIQ MISC RES | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 gen 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Peter Anthony Carr come amministratore in data 30 set 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr. Michael Andrew Lonnon come amministratore in data 30 set 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Peter Anthony Carr il 31 mar 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Colin Richard Clapham il 28 mar 2011 | 2 pagine | CH03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 80 New Bond Street London W1S 1SB United Kingdom in data 30 mar 2011 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Carney come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 gen 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 2 Piries Place Horsham West Sussex RH12 1EH England | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Carney il 09 apr 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Peter Anthony Carr il 01 apr 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Peter Robert Andrew il 18 mar 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 gen 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Colin Richard Clapham il 11 gen 2010 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Peter Robert Andrew il 16 nov 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di AMPWYN DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAPHAM, Colin Richard | Segretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | Other | 135438270002 | ||||||
| ANDREW, Peter Robert | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 113503830003 | |||||
| LONNON, Michael Andrew, Mr. | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 34521340004 | |||||
| CARR, Peter Anthony | Segretario | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | British | 130306120001 | ||||||
| HASTIE, Nicola Amanda Eleanor | Segretario | 97 Yew Tree Lane Tettenhall WV6 8UN Wolverhampton | British | 76844970003 | ||||||
| HAYMAN, John Harold | Segretario | 35 Butterfield Park BS21 5ED Clevedon Somerset | British | 16217180002 | ||||||
| JORDAN, James John | Segretario | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | 120602100002 | ||||||
| MILLS, Stanley | Segretario | Whitegates Wixford B49 6DA North Alcester Warwickshire | British | 573140004 | ||||||
| PHILLIPS, James | Segretario | Stallworth 6 Wood Road Tettenhall WV6 8LS Wolverhampton West Midlands | British | 8364990001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BUTTON, Geoffrey Allan | Amministratore | The Mill House Chicksgrove Tisbury SP3 6LY Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 54100730001 | |||||
| CARDWELL, Alan | Amministratore | 2 Winton Close LU2 7BJ Luton Bedfordshire | British | 10778690001 | ||||||
| CARNEY, Christopher | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 125216670001 | |||||
| CARR, Peter Anthony | Amministratore | 551 Avebury Boulevard MK9 3DR Milton Keynes Beech House Buckinghamshire England | England | British | 130306120001 | |||||
| DOUGLAS, Ian Mcnicol | Amministratore | Ranworth Lodge Rock Lane Mucklestone TF9 4DU Market Drayton Shropshire | United Kingdom | British | 1277320001 | |||||
| GROVE, Eric William | Amministratore | The Rye House Catesby Lane Lapworth B94 5QY Solihull West Midlands | England | British | 632880001 | |||||
| HASTIE, Nicola Amanda Eleanor | Amministratore | 97 Yew Tree Lane Tettenhall WV6 8UN Wolverhampton | British | 76844970003 | ||||||
| HAYMAN, John Harold | Amministratore | 35 Butterfield Park BS21 5ED Clevedon Somerset | British | 16217180002 | ||||||
| HAYMAN, John Harold | Amministratore | Wyndham Court Pritchard Street BS2 8RH Bristol Avon | British | 16217180001 | ||||||
| HORSLEY, Mark Francis Howard | Amministratore | The Old Rectory North Wraxall SN14 7AD Chippenham Wiltshire | British | 15406920001 | ||||||
| HORSLEY, Mark Francis Howard | Amministratore | The Old Rectory North Wraxall SN14 7AD Chippenham Wiltshire | British | 15406920001 | ||||||
| HOWARD, Martin John | Amministratore | Friary Cottage Witham Friary BA11 5HD Frome Somerset | United Kingdom | British | 467110001 | |||||
| JENKINS, Stephen Adrian | Amministratore | Kingsview Manor Road HP10 8JA Penn Buckinghamshire | United Kingdom | British | 49738660003 | |||||
| JORDAN, James John | Amministratore | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British | 120602100002 | |||||
| MCCALLUM, Graeme Reid | Amministratore | The Poplars Whinfield Road Dodford B61 9BG Bromsgrove Worcestershire | United Kingdom | British | 152856250001 | |||||
| MURRIN, Jonathan Charles | Amministratore | 10 Silhill Hall Road B91 1JU Solihull West Midlands | British | 115863170001 | ||||||
| PEACOCK, Raymond Anthony | Amministratore | 9 Grosvenor Road Finchley N3 1EY London | United Kingdom | British | 75750250002 | |||||
| PHILLIPS, James | Amministratore | Stallworth 6 Wood Road Tettenhall WV6 8LS Wolverhampton West Midlands | British | 8364990001 | ||||||
| REDFERN, Peter Timothy | Amministratore | 5 Broadfield Road OX5 1UL Yarnton Oxfordshire | British | 74208670003 | ||||||
| REYNOLDS, Tristan Henry | Amministratore | Potters Mill Hogg End, Bloxham OX15 4NE Banbury Oxfordshire | British | 69427410001 | ||||||
| SUTCLIFFE, Ian Calvert | Amministratore | Windlesham Lodge Westwood Road GU20 6LX Windlesham Surrey | United Kingdom | British | 112534590002 | |||||
| WRIGHT, Mark Simon | Amministratore | 22 Windy Arbour CV8 2AS Kenilworth Warwickshire | British | 57523550002 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
AMPWYN DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Loan agreement | Creato il 07 ott 1991 Consegnato il 10 ott 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £2.255,000 due or to become due from the company to the chargee. | |
Brevi particolari The benefit of an agreement the property as defined in the agreement. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
AMPWYN DEVELOPMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0