PNI DIGITAL MEDIA EUROPE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PNI DIGITAL MEDIA EUROPE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02626037 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PNI DIGITAL MEDIA EUROPE LIMITED?
- Sviluppo di software per le imprese e per uso domestico (62012) / Informazione e comunicazione
Dove si trova PNI DIGITAL MEDIA EUROPE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Suite R, Medina Chamber Town Quay SO14 2AQ Southampton |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PNI DIGITAL MEDIA EUROPE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| PIXOLOGY SOFTWARE LIMITED | 01 dic 2003 | 01 dic 2003 |
| PIXOLOGY LIMITED | 15 feb 2000 | 15 feb 2000 |
| NBA QUALITY SYSTEMS LIMITED | 02 lug 1991 | 02 lug 1991 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PNI DIGITAL MEDIA EUROPE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 gen 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per PNI DIGITAL MEDIA EUROPE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 25 ott 2018
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Steven Douglas Bussberg come amministratore in data 04 feb 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Christine Tomlinson Komola come amministratore in data 03 feb 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 gen 2017 | 12 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 gen 2016 | 13 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 gen 2015 | 16 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2014 al 31 gen 2015 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Richard Mills come segretario in data 11 lug 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Cory Harrison Kent come amministratore in data 07 lug 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Miss Christine Komola come amministratore in data 11 lug 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Miss Christina Gonzalez come segretario in data 11 lug 2014 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Peter David Fitzgerald come amministratore in data 11 lug 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Karl Wilhelm Thomas Oertel come amministratore in data 11 lug 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2013 | 16 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di PNI DIGITAL MEDIA EUROPE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ, Christina | Segretario | Town Quay SO14 2AQ Southampton Suite R, Medina Chamber | 192508510001 | |||||||
| BUSSBERG, Steven Douglas | Amministratore | Town Quay SO14 2AQ Southampton Suite R, Medina Chamber | United States | American | 243755270001 | |||||
| BODYMORE, Simon | Segretario | Norton Court V7G 2E5 North Vancouver 1527 British Columbia Canada | British | 139114110001 | ||||||
| GOWER ISAAC, Edward Alexander | Segretario | 14 Bridge Road TW1 1RE Twickenham Middlesex | British | 82666270002 | ||||||
| KEEBLE, Michael Philip | Segretario | The Cottage Lower Street Shere GU5 9HX Guildford Surrey | British | 58448930001 | ||||||
| MACDONALD, John Malcolm Kenneth | Segretario | Ensor Woodland Drive KT24 5AN East Horsley Surrey | British | 33673310001 | ||||||
| MARTINEZ, Mary Ann | Segretario | 1 Foxglove Gardens Merrow Park GU4 7ES Guildford Surrey | British | 76419920001 | ||||||
| MILLS, Richard | Segretario | Town Quay SO14 2AQ Southampton Suite R, Medina Chamber England | 171322850001 | |||||||
| SLADEN, Mark | Segretario | 44 Jubilee Rd GU11 3QE Aldershot Hants | British | 124780840001 | ||||||
| SPARSHATT, Alison | Segretario | Michaelmas Cottage The Green GU8 6HA Elstead Surrey | British | 78094290001 | ||||||
| YASHIV, Yuval | Segretario | Flat 6 68 Greencroft Gardens NW6 3JQ London | French | 54203420001 | ||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario nominato | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||
| BENSON, Peter Macleod | Amministratore | 2 Kings Quay Chelsea Harbour SW10 0UX London | England | British | 41171190007 | |||||
| BIGGS, Robert Nigel | Amministratore | 1 Foxglove Gardens Merrow Park GU4 7ES Guildford Surrey | England | British | 37514520001 | |||||
| BOTT, Gordon James | Amministratore | Tichsa 10 Greenhill Farm Bishops Itchington CV47 2SS Southam | United Kingdom | British | 30349880001 | |||||
| CHAPCHAL, Daniel Robert | Amministratore | Varykino 9 Ridgelands Fetcham KT22 9DB Leatherhead Surrey | England | British | 75090790001 | |||||
| CHISHOLM, John Robert | Amministratore | 2775 Cypress Street FOREIGN Vancouver V6j 5b9 British Columbia Canada | Canadian | 123034990001 | ||||||
| DRAKE, Thomas Roger | Amministratore | Warren Lea Sandy Lane Kingswood KT20 6ND Tadworth Surrey | England | British | 122933820001 | |||||
| FITZGERALD, Peter David | Amministratore | The Ridge Shootersway HP4 3NJ Berkhamsted Hertfordshire | England | British | 123034740002 | |||||
| GOWER ISAAC, Edward Alexander | Amministratore | 14 Bridge Road TW1 1RE Twickenham Middlesex | British | 82666270002 | ||||||
| KENT, Cory Harrison | Amministratore | 3520 Aintree Drive North Vancouver British Columbia V7r 4e3 Canada | Usa | Canadian | 123180970001 | |||||
| KOMOLA, Christine Tomlinson | Amministratore | Town Quay SO14 2AQ Southampton Suite R, Medina Chamber | United States | American | 279221610001 | |||||
| KURTZBARD, Yoav | Amministratore | 6 Ashley Court Frognal Lane NW3 7DX London | British | 45132920001 | ||||||
| MACDONALD, John Malcolm Kenneth | Amministratore | Ensor Woodland Drive KT24 5AN East Horsley Surrey | British | 33673310001 | ||||||
| MARTINEZ, Mary Ann | Amministratore | 1 Foxglove Gardens Merrow Park GU4 7ES Guildford Surrey | England | British | 76419920001 | |||||
| OERTEL, Karl Wilhelm Thomas | Amministratore | Town Quay SO14 2AQ Southampton Suite R, Medina Chamber England | United Kingdom | German | 173351170001 | |||||
| RALLO, Aaron | Amministratore | 15127 Ne 24th Street Apartment 479 Redmond 98052 King Usa | Usa | American | 123034910001 | |||||
| RICHARDS, Michael Clive | Amministratore | 46 Recreation Road GU1 1HP Guildford Surrey | British | 48310530001 | ||||||
| STROUD, Michael Hugh | Amministratore | 65 Applegarth Avenue GU2 6LX Guildford Surrey | United Kingdom | British | 154949870001 | |||||
| WARE, Harley Keith | Amministratore | Collingwood Crescent Surrey V3S 0J3 Canada 15860 Bc | United Kingdom | British | 54497260006 | |||||
| WHATLEY, Andrea | Amministratore | White Horse Cottage White Horse Lane Ripley GU23 6BJ Woking | British | 95462410002 | ||||||
| WRIGHT, Terence Richard, Dr | Amministratore | 182 Headstone Lane HA2 6LY Harrow Middlesex | United Kingdom | British | 336269790002 | |||||
| YASHIV, Yuval | Amministratore | 20 The Vale NW11 8SG London | French | 54203420002 | ||||||
| YOUNG-OF-GRAFFHAM, David Ivor, Lord | Amministratore | 28 York Terrace West NW1 4QA London | United Kingdom | British | 79261740001 | |||||
| ZIMMERMAN, Stephen Anthony | Amministratore | 35 Stormont Road N6 4NR London | United Kingdom | British | 13330330003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PNI DIGITAL MEDIA EUROPE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pni Digital Media Ulc | 06 apr 2016 | Carrall St Vancouver V6b 6e3 100-425 Bc Canada | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
PNI DIGITAL MEDIA EUROPE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of postponement and assignment of claims | Creato il 26 gen 2012 Consegnato il 01 feb 2012 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari As a continuing security all debts and liabilities present and future of pni digital media inc (incorporated in british columbia canada under number BC0509287) and all benefits and other rights which may arise under the claims see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 22 apr 2008 Consegnato il 24 apr 2008 | In corso | Importo garantito £6,386.33 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The sum of £6,386.33. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 27 nov 2000 Consegnato il 15 dic 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £44,539.12 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Lease dated 29 february 1997 relating to ground floor 20 chancellor court surrey research park guildford surrey. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 02 lug 1996 Consegnato il 05 lug 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over credit balances | Creato il 30 mar 1993 Consegnato il 05 apr 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a guarantee to a guarantee dated 11 march 1993 in favour of british railways board for £171,500 | |
Brevi particolari The sum of £171,500 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 71010777 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0