02628149 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società02628149 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02628149
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 02628149 LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova 02628149 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Pinesgate
    Lower Bristol Road
    BA2 3DP Bath
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di 02628149 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    REDDE (SWIFT) LIMITED02 set 201602 set 2016
    AUXILLIS LIMITED12 nov 201512 nov 2015
    REDDE GROUP LIMITED28 gen 201428 gen 2014
    SWIFT RENTACAR LIMITED10 lug 199110 lug 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di 02628149 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per 02628149 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Martin Ward il 21 ago 2017

    2 pagineCH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name19 set 2017

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 11 set 2017

    RES15

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Notifica di Redde Plc come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    1 paginePSC02

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016

    6 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 01 set 2016

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Bilancio annuale redatto al 18 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 lug 2016

    Stato del capitale al 13 lug 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2015

    6 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed redde group LIMITED\certificate issued on 12/11/15
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name12 nov 2015

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 12 nov 2015

    RES15

    Bilancio annuale redatto al 18 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 lug 2015

    Stato del capitale al 13 lug 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2014

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 lug 2014

    Stato del capitale al 14 lug 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2013

    10 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed swift rentacar LIMITED\certificate issued on 28/01/14
    2 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name28 gen 2014

    Risoluzione di cambio di nome della società il 17 gen 2014

    RES15

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 17 gen 2014

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Varie

    Section 519 ca 2006
    2 pagineMISC

    Varie

    Section 519
    2 pagineMISC

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di 02628149 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TILLEY, Nicholas Paul
    Lower Bristol Road
    BA2 3DP Bath
    Pinesgate
    Segretario
    Lower Bristol Road
    BA2 3DP Bath
    Pinesgate
    BritishCompany Director107679440001
    OAKLEY, Stephen Edward
    Lower Bristol Road
    BA2 3DP Bath
    Pinesgate
    Amministratore
    Lower Bristol Road
    BA2 3DP Bath
    Pinesgate
    EnglandBritishDirector438640001
    WARD, Martin
    Lower Bristol Road
    BA2 3DP Bath
    Pinesgate
    Amministratore
    Lower Bristol Road
    BA2 3DP Bath
    Pinesgate
    EnglandBritishManaging Director137757470006
    GOMES, Peter Denis
    Qualicum Hermitage Lane
    Goostrey
    CW4 8HB Crewe
    Cheshire
    Segretario
    Qualicum Hermitage Lane
    Goostrey
    CW4 8HB Crewe
    Cheshire
    BritishCompany Director214561760001
    RICHARDS, Michael
    Bexton Lodge
    Toft Road
    WA16 9ED Knutsford
    Cheshire
    Segretario
    Bexton Lodge
    Toft Road
    WA16 9ED Knutsford
    Cheshire
    British86701050001
    ADAMS, Mark Andrew
    2 Swan Court
    1 Booth's Place
    W1T 3AF London
    Amministratore
    2 Swan Court
    1 Booth's Place
    W1T 3AF London
    EnglandEnglishCompany Director116475040001
    COOKSON, Carl Henry
    Red Gables
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    Amministratore
    Red Gables
    Mereside Road
    WA16 6QR Mere
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector87070970001
    COOKSON, Lawrence
    Low Wood
    Mereside Road Mere
    WA16 6QW Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Low Wood
    Mereside Road Mere
    WA16 6QW Knutsford
    Cheshire
    BritishCompany Director23755330005
    CORRIE, Nicholas Charles
    Tattenhall Road
    CH43 9NA Tattenhall
    Mayfield
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Tattenhall Road
    CH43 9NA Tattenhall
    Mayfield
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSales Director139189030001
    GILBERT, Alan George
    14 Kitts Moss Lane
    SK7 2BG Bramhall
    Cheshire
    Amministratore
    14 Kitts Moss Lane
    SK7 2BG Bramhall
    Cheshire
    BritishDirector43556620003
    GOMES, Peter Denis
    Qualicum Hermitage Lane
    Goostrey
    CW4 8HB Crewe
    Cheshire
    Amministratore
    Qualicum Hermitage Lane
    Goostrey
    CW4 8HB Crewe
    Cheshire
    EnglandBritishDirector214561760001
    LAMBERT, Charles Roger
    No 4 Old Orchard Cottage
    BA1 5BE Bath
    Upper Maisonette Flat
    Banes
    Amministratore
    No 4 Old Orchard Cottage
    BA1 5BE Bath
    Upper Maisonette Flat
    Banes
    BritishDirector135765220002
    LINDSAY, David Elliott
    St. Martins Farm
    Thickwood Lane, Colerne
    SN14 8BN Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    St. Martins Farm
    Thickwood Lane, Colerne
    SN14 8BN Chippenham
    Wiltshire
    United KingdomBritishCompany Director50328330005
    MCLEAN, Colin Richard
    Woodlands 11 Llanvair Drive
    SL5 9HS South Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Woodlands 11 Llanvair Drive
    SL5 9HS South Ascot
    Berkshire
    BritishChief Executive5382220002
    POULTON, Simon Nicholas
    Lower Bristol Road
    BA2 3DP Bath
    Pinesgate
    Amministratore
    Lower Bristol Road
    BA2 3DP Bath
    Pinesgate
    United KingdomBritishDirector11323860002
    RICHARDS, Michael
    Bexton Lodge
    Toft Road
    WA16 9ED Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Bexton Lodge
    Toft Road
    WA16 9ED Knutsford
    Cheshire
    BritishInsurance Broker86701050001
    WARDLE, Ian
    Lower Bristol Road
    BA2 3DP Bath
    Pinesgate
    Amministratore
    Lower Bristol Road
    BA2 3DP Bath
    Pinesgate
    United KingdomBritishDirector138278030001

    Chi sono le persone con controllo significativo di 02628149 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Lower Bristol Road
    BA2 3DP Bath
    Pinesgate
    England
    06 apr 2016
    Lower Bristol Road
    BA2 3DP Bath
    Pinesgate
    England
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3120010
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    02628149 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 31 mar 2009
    Consegnato il 15 apr 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 15 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 31 mar 2009
    Consegnato il 15 apr 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 15 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 31 mar 2009
    Consegnato il 15 apr 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 07 lug 2006
    Consegnato il 12 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 set 2005
    Consegnato il 30 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or any additional obligors to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Trustee for Thebeneficiaries (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 30 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 29 lug 2004
    Consegnato il 30 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 30 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 17 feb 2003
    Consegnato il 22 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bibby Factors Limited
    Transazioni
    • 22 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 feb 1999
    Consegnato il 11 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0