BERISFORD HOLDINGS LIMITED

BERISFORD HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBERISFORD HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02629465
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BERISFORD HOLDINGS LIMITED?

    • Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova BERISFORD HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BERISFORD HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SILTONE LIMITED15 lug 199115 lug 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di BERISFORD HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per BERISFORD HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2019

    12 pagineAA

    legacy

    42 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Nomina di Esyllt John-Featherby come amministratore in data 19 giu 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di John Albert James Rourke come amministratore in data 19 giu 2020

    1 pagineTM01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2018

    12 pagineAA

    legacy

    32 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2017

    13 pagineAA

    legacy

    32 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Graham Philip Brisley Veal come amministratore in data 30 nov 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr John Albert James Rourke come amministratore in data 30 nov 2017

    2 pagineAP01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2016

    13 pagineAA

    legacy

    31 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Chi sono gli amministratori di BERISFORD HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    England
    Segretario
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione4363143
    94529700001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    Amministratore
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    United KingdomBritish146072380001
    JOHN-FEATHERBY, Esyllt
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    Amministratore
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    EnglandBritish273323780001
    BURROWES, Rosemary Anne
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    Segretario
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    British49687740001
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    SYMS, Rhonda Sneddon
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    Segretario
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    British16978550002
    BARNETT, Stephen John
    Porchester Mead 53 Southend Road
    BR3 1SP Beckenham
    Kent
    Amministratore
    Porchester Mead 53 Southend Road
    BR3 1SP Beckenham
    Kent
    United KingdomBritish62629660001
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    Amministratore
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritish79449700002
    BUTLER, Peter Robert
    Gifford House
    22 Chalklands Howe Green
    CM2 7TH Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Gifford House
    22 Chalklands Howe Green
    CM2 7TH Chelmsford
    Essex
    British34707070001
    CUTHBERTSON, George Brian
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish6996370001
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    Amministratore
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United States134081280001
    GORDON, Alastair Neil
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    Amministratore
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    EnglandBritish61620710001
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    Amministratore
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmerican134328700001
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    Usa
    Amministratore
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    Usa
    United StatesAmerican136570610001
    MULHALL, Denis Joseph
    Fitzgeorge House
    Fitzgeorge Avenue
    KT3 4SH New Malden
    Surrey
    Amministratore
    Fitzgeorge House
    Fitzgeorge Avenue
    KT3 4SH New Malden
    Surrey
    EnglandBritish,Irish32235150003
    O'CONNOR, Patrick Finbarr
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    Amministratore delegato nominato
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    British/Irish900010100001
    ROURKE, John Albert James
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    Amministratore
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    United KingdomBritish77646900002
    TIVEY, Andrew David
    2 Manor Farm Cottages
    Church Street
    KT4 7RY Worcester Park
    Amministratore
    2 Manor Farm Cottages
    Church Street
    KT4 7RY Worcester Park
    British9318760001
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    Amministratore
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritish43215170003
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310650003
    S & W BERISFORD LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310610006

    Chi sono le persone con controllo significativo di BERISFORD HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    06 apr 2016
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England & Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione4330202
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    BERISFORD HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002
    Creato il 11 apr 2002
    Consegnato il 25 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 25 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent
    Creato il 20 feb 2002
    Consegnato il 08 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 08 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent)
    Creato il 20 nov 2001
    Consegnato il 30 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 ott 1991
    Consegnato il 17 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the indebtness agreements
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 09 set 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 15 ott 1991
    Consegnato il 17 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from each obligor (as defined) to the chargee and the banks (as defined) or any account whatsoever under the terms of each of the indebtedness agreements (as defined)
    Brevi particolari
    See doc for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 09 set 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0