SSE IMPERIAL PARK PN LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SSE IMPERIAL PARK PN LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02631510 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SSE IMPERIAL PARK PN LIMITED?
- Distribuzione di energia elettrica (35130) / Fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata
Dove si trova SSE IMPERIAL PARK PN LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | No. 1 Forbury Place 43 Forbury Road RG1 3JH Reading England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SSE IMPERIAL PARK PN LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MANWEB SERVICES LIMITED | 25 giu 1993 | 25 giu 1993 |
| WHEATSHEAF ENERGY LIMITED | 17 set 1991 | 17 set 1991 |
| LEGIBUS 1640 LIMITED | 22 lug 1991 | 22 lug 1991 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SSE IMPERIAL PARK PN LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 mar 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 dic 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per SSE IMPERIAL PARK PN LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 01 feb 2027 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 15 feb 2027 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 01 feb 2026 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per SSE IMPERIAL PARK PN LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2026 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2025 | 18 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 288 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||
Nomina di Mr Martin Beattie come amministratore in data 27 nov 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2024 | 18 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 343 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2023 | 16 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorandum e Statuto | 34 pagine | MA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2023 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Graham Atkinson come segretario in data 15 mar 2023 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione di Sp Manweb Plc come persona con controllo significativo il 20 dic 2022 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Notifica di Sse Utility Solutions Limited come persona con controllo significativo il 20 dic 2022 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2022 al 31 mar 2023 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed manweb services LIMITED\certificate issued on 30/12/22 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 3 Prenton Way Prenton CH43 3ET a No. 1 Forbury Place 43 Forbury Road Reading RG1 3JH in data 28 dic 2022 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SSE IMPERIAL PARK PN LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATKINSON, Graham | Segretario | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No. 1 Forbury Place England | 306879060001 | |||||||
| ANDERSON, Scott Keelor | Amministratore | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | United Kingdom | British | 204396790001 | |||||
| BEATTIE, Martin | Amministratore | 200 Dunkeld Road PH1 3GH Perth Grampian House Scotland | Scotland | British | 342950110001 | |||||
| SANDERS, Nathan | Amministratore | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place England | England | British | 150936520002 | |||||
| DAVIES, Michael Howard | Segretario | 1 Atlantic Quay Robertson Street G2 8SP Glasgow Scottish Power Ltd | British | 157758380001 | ||||||
| DUFFIELD, Sheelagh Jane | Segretario | 32 Highburgh Road Dowanhill G12 9EF Glasgow | British | 52720790002 | ||||||
| GREGG, Rhona | Segretario | 25 Lammermuir Wynd ML9 1UT Larkhall Lanarkshire | British | 111591600001 | ||||||
| MCPHERSON, Donald James | Segretario | 14 Braid Drive Cardross G82 5QD Dumbarton Dunbartonshire | British | 40519810004 | ||||||
| MITCHELL, Andrew Ross | Segretario | Highwood PA13 4TA Kilmacolm Refrewshire | British | 25359180002 | ||||||
| O'GORMAN, Seumus | Segretario | 3 Prenton Way Prenton CH43 3ET | 193946680001 | |||||||
| ROSS, Marie Isobel | Segretario | c/o Scottish Power Atlantic Quay Robertson St G2 8SP Glasgow 1 | British | 42057170004 | ||||||
| WILLIAMS, David Nicholas | Segretario | 1 The Copse Station Road Rossett LL12 0GD Wrexham Clwyd | British | 14953210002 | ||||||
| ALCAIN, Daniel | Amministratore | Atlantic Quay Robertson Street G2 8SP Glasgow 1 Scotland | United Kingdom | Spanish | 172264220001 | |||||
| ASTALL, John | Amministratore | Marbury Cottage Bentleys Farm Lane Higher Whitley WA4 4QW Warrington Cheshire | British | 19570720001 | ||||||
| BENNS, Robert Arthur | Amministratore | 36 Mossgiel Road Newlands G43 2DF Glasgow | United Kingdom | British | 79528400001 | |||||
| BERRY, Charles Andrew | Amministratore | 5 Grange Road Bearsden G61 3PL Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 109780690001 | |||||
| COCHRANE, Keith Robertson | Amministratore | 15 Brompton Terrace PH2 7DQ Perth Perthshire | British | 105823620001 | ||||||
| DUFFIELD, Sheelagh Jane | Amministratore | 197 Queen Victoria Drive Scotstounhill G14 9BP Glasgow | Scotland | British | 52720790003 | |||||
| FENWICK, Trevor John | Amministratore | 55 Baronswood Gosforth NE3 3UB Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | 49828990002 | |||||
| FERNANDEZ OLMEDO, Ramon | Amministratore | Robertson Street G2 8SP Glasgow 1 Atlantic Quay | United Kingdom | Spanish | 130956370001 | |||||
| GREEN, Robert David | Amministratore | 10 Castlehill Crescent ML3 7DG Hamilton Lanarkshire | British | 76720550001 | ||||||
| KINSKI, Michael John | Amministratore | Cherry Tree House 268 Dunchurch Road CV22 6HX Rugby Warwickshire | United Kingdom | British | 58643710001 | |||||
| MATHIESON, Scott Hamilton | Amministratore | 3 Prenton Way Prenton CH43 3ET | Scotland | British | 109181730001 | |||||
| MITCHELL, Andrew Ross | Amministratore | Highwood PA13 4TA Kilmacolm Refrewshire | British | 25359180002 | ||||||
| NISH, David Thomas | Amministratore | Kiloran Houston Road PA13 4NY Kilmacolm | Scotland | British | 57316940002 | |||||
| RICHARDSON, Alan Victor, Prof | Amministratore | Dyke Farm Cottage KA1 5PN Symington Ayrshire | British | 32696250001 | ||||||
| ROBERTS, John Edward | Amministratore | The Cottage Ganarew House Ganarew NP25 3SS Monmouth Gwent | British | 66276580001 | ||||||
| ROSSI, Marc Domenico | Amministratore | 3 Prenton Way Prenton CH43 3ET | Scotland | British | 329086940001 | |||||
| STANLEY, Rupert James | Amministratore | New School Farm 6 Station Road Tilbrook PE28 0JT Huntingdon Cambridgeshire | Uk | British | 50448490001 | |||||
| STEWART, Stephen Alexander | Amministratore | 3 Prenton Way Prenton CH43 3ET | Scotland | British | 197316840001 | |||||
| VENMAN, Marion | Amministratore | Atlantic Quay Robertson Street G2 8SP Glasgow 1 | Scotland | British | 125700460002 | |||||
| VERNON-SMITH, David Alexander | Amministratore | Alder House Prestbury Road SK9 2LJ Wilmslow Cheshire | British | 34426490001 | ||||||
| WESTON, Bryan Henry | Amministratore | Fountainhead Cottage Brassey Green CW6 9UG Tarporley Cheshire | British | 14901220001 | ||||||
| WILLIAMS, David Nicholas | Amministratore | 9 Victoria Pathway Queens Park CH4 7AG Chester Cheshire | British | 14953210001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SSE IMPERIAL PARK PN LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sse Utility Solutions Limited | 20 dic 2022 | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Sp Manweb Plc | 06 apr 2016 | CH43 3ET Prenton 3 Prenton Way England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0