MORLEY LODGE PROPERTIES LIMITED

MORLEY LODGE PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMORLEY LODGE PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02632096
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MORLEY LODGE PROPERTIES LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova MORLEY LODGE PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    61 Thames Street
    SL4 1QW Windsor
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MORLEY LODGE PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHALECOURT LIMITED24 lug 199124 lug 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di MORLEY LODGE PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MORLEY LODGE PROPERTIES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per MORLEY LODGE PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 feb 2014

    Stato del capitale al 07 feb 2014

    • Capitale: GBP 170,322
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Derek Maurice Joseph il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    6 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da The Gatehouse, 2 Park Street Windsor Berkshire SL4 1LU in data 16 mar 2010

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Derek Maurice Joseph il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2008

    8 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di MORLEY LODGE PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KERR, James Michael
    Woodmancott Close
    RG12 0XU Bracknell
    25
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Woodmancott Close
    RG12 0XU Bracknell
    25
    Berkshire
    United Kingdom
    BritishFinance Director64287560003
    JOSEPH, Derek Maurice
    Tempus Wharf
    29 Bermondsey Wall West
    SE16 4RW London
    Flat 8
    United Kingdom
    Amministratore
    Tempus Wharf
    29 Bermondsey Wall West
    SE16 4RW London
    Flat 8
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director40393740002
    TAYLOR, Denis Newman
    8 Syke Cluan
    SL0 9EH Iver
    Buckinghamshire
    Amministratore
    8 Syke Cluan
    SL0 9EH Iver
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChartered Surveyor57777760001
    BOAKES, Timothy David
    Northbrook Farmhouse
    Sherbourne
    CV35 8AG Warwick
    Warwickshire
    Segretario
    Northbrook Farmhouse
    Sherbourne
    CV35 8AG Warwick
    Warwickshire
    BritishChartered Accountant38948010001
    BUTTERFIELD, Christopher Alan
    North Lodge Farm
    Widmerpool Lane Widmerpool
    NG12 5QE Nottingham
    Segretario
    North Lodge Farm
    Widmerpool Lane Widmerpool
    NG12 5QE Nottingham
    BritishChartered Accountant7649100002
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BOAKES, Timothy David
    Northbrook Farmhouse
    Sherbourne
    CV35 8AG Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    Northbrook Farmhouse
    Sherbourne
    CV35 8AG Warwick
    Warwickshire
    BritishChartered Accountant38948010001
    BOOLER, Michael David
    55 The Woodlands
    LE16 7BW Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    55 The Woodlands
    LE16 7BW Market Harborough
    Leicestershire
    BritishIndependent Financial Adviser23889810001
    BUTTERFIELD, Christopher Alan
    North Lodge Farm
    Widmerpool Lane Widmerpool
    NG12 5QE Nottingham
    Amministratore
    North Lodge Farm
    Widmerpool Lane Widmerpool
    NG12 5QE Nottingham
    EnglandBritishChartered Accountant7649100002
    CLEAVER, Robert John
    Highland Cottage Giddy Lake
    BH21 2QT Wimborne
    Dorset
    Amministratore
    Highland Cottage Giddy Lake
    BH21 2QT Wimborne
    Dorset
    United KingdomBritishCompany Director55300920001
    COURT, Robert Leonard
    Southdown House Southdown Road
    Shawford
    SO21 2BX Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Southdown House Southdown Road
    Shawford
    SO21 2BX Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishChartered Surveyor7767540001
    KEYS, Brian Sarel
    Island Covert
    Steep
    GU32 1AE Petersfield
    Hampshire
    Amministratore
    Island Covert
    Steep
    GU32 1AE Petersfield
    Hampshire
    EnglandBritishChartered Surveyor28540060001
    LIFFORD, Edward James Wingfield, The Viscount
    Field House
    Hursley
    SO21 2LE Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Field House
    Hursley
    SO21 2LE Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishStockbroker14020560001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Amministratore delegato nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    MORLEY LODGE PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Third party legal charge
    Creato il 26 gen 1999
    Consegnato il 30 gen 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the city of winchester investments PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as 21 plaza gardens basford nottingham nottinghamshire title number NT272915.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Third party legal chrge
    Creato il 26 gen 1999
    Consegnato il 30 gen 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from city of winchester investments PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 20 plaza gardens basford nottingham nottinghamshire t/n NT272914. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Third party legal charge
    Creato il 26 gen 1999
    Consegnato il 30 gen 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from city of winchester investments PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 26 plaza gardens basford nottingham nottinghamshire t/n NT272922. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Third party legal charge
    Creato il 26 gen 1999
    Consegnato il 30 gen 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from city of winchester investments PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 22 plaza gardens basford nottingham nottinghamshire t/n NT272936. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Third party legal charge
    Creato il 26 gen 1999
    Consegnato il 30 gen 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from city of winchester investments PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 27 plaza gardens basford nottingham nottinghamshire t/n NT272923. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 06 dic 1991
    Consegnato il 11 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H plot 26 barlock road, basford, nottingham, part title number NT191742.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 11 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 06 dic 1991
    Consegnato il 11 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H, plot 27 barlock road, basford, nottingham, part title number NT191742. Assigns goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 11 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    O3
    Creato il 06 dic 1991
    Consegnato il 11 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H, plot 25 barlock road, basford, nottingham. Part title number NT191742. Assigns goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 11 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0