THE UNLIMITED GROUP HOLDINGS LTD

THE UNLIMITED GROUP HOLDINGS LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE UNLIMITED GROUP HOLDINGS LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02636904
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE UNLIMITED GROUP HOLDINGS LTD?

    • Agenzie pubblicitarie (73110) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova THE UNLIMITED GROUP HOLDINGS LTD?

    Indirizzo della sede legale
    7-11 Lexington Street
    W1F 9AF London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE UNLIMITED GROUP HOLDINGS LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE REAL ADVENTURE MARKETING COMMUNICATIONS LIMITED23 set 199123 set 1991
    PREFERACTION LIMITED12 ago 199112 ago 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE UNLIMITED GROUP HOLDINGS LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2023

    Quali sono le ultime deposizioni per THE UNLIMITED GROUP HOLDINGS LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 026369040017 in pieno

    1 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da First Floor, Orion House 5 Upper St. Martin's Lane London WC2H 9EA England a 7-11 Lexington Street London W1F 9AF in data 30 nov 2023

    1 pagineAD01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2023

    17 pagineAA

    legacy

    40 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 mag 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2022

    19 pagineAA

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 mag 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2021

    20 pagineAA

    legacy

    43 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 90 High Holborn London WC1V 6XX England a Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF

    1 pagineAD02

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2020

    21 pagineAA

    legacy

    46 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Indirizzo della sede legale modificato da Unlimited House 10 Great Pulteney Street London W1F 9NB United Kingdom a First Floor, Orion House 5 Upper St. Martin's Lane London WC2H 9EA in data 15 apr 2021

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di THE UNLIMITED GROUP HOLDINGS LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HASSETT, Timothy Brian
    Lexington Street
    W1F 9AF London
    7-11
    England
    Amministratore
    Lexington Street
    W1F 9AF London
    7-11
    England
    United StatesAmerican259548850001
    HORATIO GUEST, Edward Melville
    Lexington Street
    W1F 9AF London
    7-11
    England
    Amministratore
    Lexington Street
    W1F 9AF London
    7-11
    England
    United KingdomBritish266714710001
    COOK, Ben
    20 The Circus
    BA1 2EU Bath
    Bath And North East Somerset
    Segretario
    20 The Circus
    BA1 2EU Bath
    Bath And North East Somerset
    British99154320001
    LEGGE, Jonathan Paul Thomson
    4 Coburg Villas
    Camden Road
    BA1 5JF Bath
    Somerset
    Segretario
    4 Coburg Villas
    Camden Road
    BA1 5JF Bath
    Somerset
    British83219660001
    WALKER, Olivia Alexandra
    10 Great Pulteney Street
    W1F 9NB London
    Unlimited House
    United Kingdom
    Segretario
    10 Great Pulteney Street
    W1F 9NB London
    Unlimited House
    United Kingdom
    206655720002
    CITY GROUP PLC
    Middle Street
    EC1A 7JA London
    6
    England
    Segretario
    Middle Street
    EC1A 7JA London
    6
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione1443918
    35794270004
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALDERSON, Timothy Buckler
    30 Arundel Terrace
    Barnes
    SW13 8DS London
    Amministratore
    30 Arundel Terrace
    Barnes
    SW13 8DS London
    United KingdomBritish58819410001
    BATES, Ian Mitchell
    Temple Quay
    BS2 0EL Bristol
    One Glass Wharf
    England
    Amministratore
    Temple Quay
    BS2 0EL Bristol
    One Glass Wharf
    England
    EnglandBritish158164920001
    BICKNELL, Geoffrey James
    10 Great Pulteney Street
    W1F 9NB London
    Unlimited House
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Great Pulteney Street
    W1F 9NB London
    Unlimited House
    United Kingdom
    United StatesBritish70240070003
    BONNET, Timothy James Justin
    10 Great Pulteney Street
    W1F 9NB London
    Unlimited House
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Great Pulteney Street
    W1F 9NB London
    Unlimited House
    United Kingdom
    EnglandBritish65305700003
    BOORMAN, Peter Alan
    10 Great Pulteney Street
    W1F 9NB London
    Creston House
    England
    Amministratore
    10 Great Pulteney Street
    W1F 9NB London
    Creston House
    England
    EnglandBritish95220380001
    BRACE, Simon Paul
    Temple Quay
    BS2 0EL Bristol
    One Glass Wharf
    England
    Amministratore
    Temple Quay
    BS2 0EL Bristol
    One Glass Wharf
    England
    EnglandBritish154700970002
    BRIEN, Barrie Christopher
    10 Great Pulteney Street
    W1F 9NB London
    Creston House
    England
    Amministratore
    10 Great Pulteney Street
    W1F 9NB London
    Creston House
    England
    EnglandBritish68731570002
    COOK, Ben
    20 The Circus
    BA1 2EU Bath
    Bath And North East Somerset
    Amministratore
    20 The Circus
    BA1 2EU Bath
    Bath And North East Somerset
    EnglandBritish99154320001
    COOK, Ben
    20 The Circus
    BA1 2EU Bath
    Bath And North East Somerset
    Amministratore
    20 The Circus
    BA1 2EU Bath
    Bath And North East Somerset
    EnglandBritish99154320001
    COOK, Fraser James, Dr
    10 Chilton Road
    BA1 6DR Bath
    Avon
    Amministratore
    10 Chilton Road
    BA1 6DR Bath
    Avon
    EnglandBritish124317640001
    DEWHURST, Sean
    Ash Mill
    EX36 4QY South Molton
    East Port Farm
    Devon
    Amministratore
    Ash Mill
    EX36 4QY South Molton
    East Port Farm
    Devon
    United KingdomBritish140690970001
    ELGIE, Donald Hunter
    10 Great Pulteney Street
    W1F 9NB London
    Creston House
    England
    Amministratore
    10 Great Pulteney Street
    W1F 9NB London
    Creston House
    England
    United KingdomBritish6661980002
    FERGUSON, Iain Fraser
    10 Great Pulteney Street
    W1F 9NB London
    Unlimited House
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Great Pulteney Street
    W1F 9NB London
    Unlimited House
    United Kingdom
    United KingdomBritish259478790001
    HANCOCK, Mark Danvers
    Temple Quay
    BS2 0EL Bristol
    One Glass Wharf
    England
    Amministratore
    Temple Quay
    BS2 0EL Bristol
    One Glass Wharf
    England
    United KingdomBritish33097440005
    HARDY, Matthew Alan
    Temple Quay
    BS2 0EL Bristol
    One Glass Wharf
    England
    Amministratore
    Temple Quay
    BS2 0EL Bristol
    One Glass Wharf
    England
    EnglandBritish107633610002
    HERRICK, Kathryn Louise
    10 Great Pulteney Street
    W1F 9NB London
    Unlimited House
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Great Pulteney Street
    W1F 9NB London
    Unlimited House
    United Kingdom
    EnglandBritish76110680002
    KIRKMAN, Neil
    5 Bradford Road
    Winsley
    BA15 2HN Bradford On Avon
    Amministratore
    5 Bradford Road
    Winsley
    BA15 2HN Bradford On Avon
    EnglandBritish16401500002
    KIRKMAN, Neil
    St Anthonys
    Mells Green Mells
    BA11 3QF Frome
    Somerset
    Amministratore
    St Anthonys
    Mells Green Mells
    BA11 3QF Frome
    Somerset
    British16401500001
    KIRKMAN, Nicole Anne Marie
    5 Bradford Road
    Winsley
    BA15 2HN Bradford On Avon
    Wiltshire
    Amministratore
    5 Bradford Road
    Winsley
    BA15 2HN Bradford On Avon
    Wiltshire
    EnglandBritish257853600001
    LEGGE, Jonathan Paul Thomson
    Glebe Barton
    Cheddon Fitzpaine
    TA28JU Taunton
    Somerset
    Amministratore
    Glebe Barton
    Cheddon Fitzpaine
    TA28JU Taunton
    Somerset
    British83219660002
    LONGHORN, Mark
    10 Great Pulteney Street
    W1F 9NB London
    Creston House
    England
    Amministratore
    10 Great Pulteney Street
    W1F 9NB London
    Creston House
    England
    EnglandBritish101263860001
    MARSHALL, Richard
    30 City Road
    London
    EC1Y 2AG
    Amministratore
    30 City Road
    London
    EC1Y 2AG
    EnglandBritish17440820006
    MONK, Graham William
    39 Criffel Avenue
    SW2 4AY London
    Amministratore
    39 Criffel Avenue
    SW2 4AY London
    EnglandBritish104482650001
    MONK, Neil
    Attwood House 37 Rivers Street
    BA1 2QA Bath
    Avon
    Amministratore
    Attwood House 37 Rivers Street
    BA1 2QA Bath
    Avon
    British69813060001
    POPE, Elizabeth Rachel
    Temple Quay
    BS2 0EL Bristol
    One Glass Wharf
    England
    Amministratore
    Temple Quay
    BS2 0EL Bristol
    One Glass Wharf
    England
    United KingdomBritish124317520002
    SEWELL, Carolyn Denise
    Temple Quay
    BS2 0EL Bristol
    One Glass Wharf
    England
    Amministratore
    Temple Quay
    BS2 0EL Bristol
    One Glass Wharf
    England
    EnglandBritish201191990001
    WARREN, Christopher Richard
    22 Perrymead Street
    SW6 3SP London
    Amministratore
    22 Perrymead Street
    SW6 3SP London
    United KingdomBritish4128240003
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di THE UNLIMITED GROUP HOLDINGS LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Digital Unlimited Group Ltd
    Great Pulteney Street
    W1F 9NB London
    10
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Great Pulteney Street
    W1F 9NB London
    10
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneThe Register Of Companies For England And Wales
    Numero di registrazione00210505
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    THE UNLIMITED GROUP HOLDINGS LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 27 feb 2017
    Consegnato il 07 mar 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All current and future land (except for any restricted land or floating charge leasehold property) and intellectual property (except for any restricted ip) owned by the company in each case as specified (and defined) in the deed of accession registered by this form MR01 (the "deed of accession"). For more details please refer to the deed of accession.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 07 mar 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 25 mar 2024Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 28 mag 2015
    Consegnato il 05 giu 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 05 giu 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 gen 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 29 nov 2011
    Consegnato il 08 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors or any of them to any secured party or their assignee or successor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 10 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 23 giu 2006
    Consegnato il 05 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2000 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    £2,000 cash deposit together with interest.
    Persone aventi diritto
    • Matrix (Data Processing) Limited
    Transazioni
    • 05 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 23 giu 2006
    Consegnato il 05 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2000 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    £2,000 cash deposit together with interest.
    Persone aventi diritto
    • Matrix (Data Processing) Limited
    Transazioni
    • 05 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 23 giu 2006
    Consegnato il 05 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £11400 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    £11,400 cash deposit together with interest.
    Persone aventi diritto
    • Matrix (Data Processing) Limited
    Transazioni
    • 05 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 23 giu 2006
    Consegnato il 05 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £4700 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    £4,700 cash deposit together with interest.
    Persone aventi diritto
    • Matrix (Data Processing) Limited
    Transazioni
    • 05 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 23 giu 2006
    Consegnato il 05 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2000 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    £2,000 cash deposit together with interest.
    Persone aventi diritto
    • Jason Anthony John Mohr
    Transazioni
    • 05 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Second deed of accession to a composite guarantee and debenture
    Creato il 03 set 2004
    Consegnato il 16 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Third deed of accession to a composite guarantee and debenture
    Creato il 03 set 2004
    Consegnato il 16 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 28 feb 2003
    Consegnato il 06 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £11,400.
    Persone aventi diritto
    • Matrix (Data Processing) Limited
    Transazioni
    • 06 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 14 ott 2002
    Consegnato il 17 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £4,250.
    Persone aventi diritto
    • Trustees of the Matrix Senior Executive Pension Scheme
    Transazioni
    • 17 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 28 nov 2001
    Consegnato il 05 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 08 ago 2001
    Consegnato il 10 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a lease of even date
    Brevi particolari
    The sum of £2,000 as initial deposit.
    Persone aventi diritto
    • Jason Anthony John Mohr
    Transazioni
    • 10 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 21 dic 1998
    Consegnato il 30 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a lease of even date
    Brevi particolari
    £2,000.
    Persone aventi diritto
    • Paul Imri Hatvany, Ruby Diana Hatvany, Roman Stephen Mohr and Helen Ruth Mohr
    Transazioni
    • 30 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 25 set 1996
    Consegnato il 26 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £44,000 and all other moneys due or to become from the company to the chargee under the terms of this charge
    Brevi particolari
    Leasehold property at 21-22 circus mews bath. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Neil Kirkman
    Transazioni
    • 26 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 25 set 1996
    Consegnato il 26 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £59,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge
    Brevi particolari
    Leasehold property at 21-22 circus mews bath. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ben Cook
    Transazioni
    • 26 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0