PERUDA LEASING LIMITED

PERUDA LEASING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPERUDA LEASING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02638677
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PERUDA LEASING LIMITED?

    • Leasing finanziario (64910) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova PERUDA LEASING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Interpath Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PERUDA LEASING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ABBEY NATIONAL JUNE LEASING (3) LIMITED01 mag 199201 mag 1992
    FOCUSLOCAL LIMITED16 ago 199116 ago 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di PERUDA LEASING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per PERUDA LEASING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    18 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB a C/O Interpath Limited 10 Fleet Place London EC4M 7RB in data 28 lug 2023

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 giu 2023

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    7 pagineLIQ01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2021

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2020

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    13 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Charles Snailham il 31 ott 2017

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Mr Matthew James Thorne come amministratore in data 18 dic 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Kenyon Thomas come amministratore in data 30 nov 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 12 ott 2017

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    Chi sono gli amministratori di PERUDA LEASING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BAGSHAW, Joanne Louise
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    Segretario
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    180380540001
    BARTLETT, Andrew William
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    Segretario
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    British73852930003
    SNAILHAM, Christopher Charles
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant202149290001
    THORNE, Matthew
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    United KingdomBritishBanker267811560001
    BURTON, Jennifer Sandra
    39b Butler Avenue
    HA1 4EJ West Harrow
    Middlesex
    Segretario
    39b Butler Avenue
    HA1 4EJ West Harrow
    Middlesex
    British100622570001
    FLETCHER, Edward Michael
    3 Aldrich Terrace
    SW18 3PU Earlsfield
    Segretario
    3 Aldrich Terrace
    SW18 3PU Earlsfield
    British78572640002
    NAGRECHA, Lenna
    2 Oaktree Close
    HA7 2PX Stanmore
    Middlesex
    Segretario
    2 Oaktree Close
    HA7 2PX Stanmore
    Middlesex
    British4949790001
    RUTHERFORD, Adam Paul
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    Segretario
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    British70451850004
    ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Abbey National House
    2 Triton Square Regent's Place
    NW1 3AN London
    Segretario
    Abbey National House
    2 Triton Square Regent's Place
    NW1 3AN London
    61749570003
    BATCHELOR, Gwendoline Mary
    26 Crescent Wood Road
    SE26 6RU London
    Amministratore
    26 Crescent Wood Road
    SE26 6RU London
    BritishFinance Director34184100001
    BATCHELOR, Gwendoline Mary
    26 Crescent Wood Road
    SE26 6RU London
    Amministratore
    26 Crescent Wood Road
    SE26 6RU London
    BritishFinance Director34184100001
    COHEN, Jonathan Paul
    13 Gowan Lea
    15 Woodford Road
    E18 2ER London
    Amministratore
    13 Gowan Lea
    15 Woodford Road
    E18 2ER London
    EnglandBritishAccountant26953400001
    EDWARDS, Shirley Ann Elizabeth
    Tilbrook Mill
    Lower Dean
    PE28 0LH Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Tilbrook Mill
    Lower Dean
    PE28 0LH Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishFinancial Controller61855020002
    ELLIS, David James
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    Amministratore
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    EnglandBritishChartered Accountant113760650001
    GARRATT, Robin
    Wansunt Road
    DA5 2DN Bexley
    107
    Kent
    Amministratore
    Wansunt Road
    DA5 2DN Bexley
    107
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant14290340001
    GOLDSBROUGH, Christopher Andrew John
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    United KingdomBritish/New ZealandBanker153832500002
    GREEN, David Martin
    7 Restharrow Road
    Weavering
    ME14 5UH Maidstone
    Kent
    Amministratore
    7 Restharrow Road
    Weavering
    ME14 5UH Maidstone
    Kent
    BritishChartered Accountant83033800001
    HARLEY, Ian
    36 Kersey Drive
    Selsdon Ridge
    CR2 8SX South Croydon
    Surrey
    Amministratore
    36 Kersey Drive
    Selsdon Ridge
    CR2 8SX South Croydon
    Surrey
    BritishGroup Treasurer25941180001
    HOYLE, Stephen Lewis
    2 Haslemere Road
    N8 9QX London
    Amministratore
    2 Haslemere Road
    N8 9QX London
    United KingdomBritishBanker96838010001
    HUTCHISON, Sarah Anne
    77 Parliament Hill
    NW3 2TH London
    Amministratore
    77 Parliament Hill
    NW3 2TH London
    BritishBanker36372610001
    JONES, David Gareth
    Hillhouse Farm
    Misbrooks Green Road Beare Green
    RH5 4QQ Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Hillhouse Farm
    Misbrooks Green Road Beare Green
    RH5 4QQ Dorking
    Surrey
    United KingdomBritishManaging Director6205890002
    JONES, David Gareth
    The Buffers
    11 Deepdene Drive
    RH5 4AH Dorking
    Surrey
    Amministratore
    The Buffers
    11 Deepdene Drive
    RH5 4AH Dorking
    Surrey
    BritishAsst Gen Mgr & Treasurer6205890001
    JULIAN, Suzanne Margaret
    25 Quick Road
    Chiswick
    W4 2BU London
    Amministratore
    25 Quick Road
    Chiswick
    W4 2BU London
    BritishAccountant36432460001
    LONG, Graham Stephen
    22 Cumberland Road
    SW13 9LY London
    Amministratore
    22 Cumberland Road
    SW13 9LY London
    BritishDirector38022070005
    LOWE, William Nairn
    Briar Gap
    Loseberry Road
    KT10 9DQ Claygate
    Surrey
    Amministratore
    Briar Gap
    Loseberry Road
    KT10 9DQ Claygate
    Surrey
    EnglandBritishBanker282371920001
    MACFARLANE, Stuart Edward
    29 Leaside Avenue
    Muswell Hill
    N10 3BT London
    Amministratore
    29 Leaside Avenue
    Muswell Hill
    N10 3BT London
    AustralianBanker125721120001
    MACFARLANE, Stuart Edward
    6 Lynmouth Road
    East Finchley
    N2 9LS London
    Amministratore
    6 Lynmouth Road
    East Finchley
    N2 9LS London
    AustralianBanker125721120002
    MCGIDDY, Mark Andrew
    Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House 1
    Amministratore
    Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House 1
    AustralianBanker114990900003
    MERRICK, Anna
    27 Jacksons Lane
    Highgate
    N6 5SR London
    Amministratore
    27 Jacksons Lane
    Highgate
    N6 5SR London
    BritishBanker39621110002
    NICHOLLS, Jonathan Clive
    Longmeadow
    Prinsted Lane
    PO10 8HR Emsworth
    Hampshire
    Amministratore
    Longmeadow
    Prinsted Lane
    PO10 8HR Emsworth
    Hampshire
    United KingdomEnglishDeputy Treasurer127532290001
    OSWALD JACOBS, John James
    15 Clapham Common West Side
    SW4 9AJ London
    Amministratore
    15 Clapham Common West Side
    SW4 9AJ London
    AustralianLawyer Banker77965500001
    PRESS, Matthew
    106 Ledbury Road
    W11 2AH London
    Amministratore
    106 Ledbury Road
    W11 2AH London
    AustralianInvestment Banker104610910001
    SHAH, Rumit
    32 The Drive
    HA6 1HP Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    32 The Drive
    HA6 1HP Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishInvestment Banker101964890001
    SIVANITHY, Rajanbabu
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    Amministratore
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United KingdomBritishAccountant63268810003
    THOMAS, David Kenyon
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    England
    England
    Amministratore
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    England
    England
    United KingdomBritishBanker59397060006

    Chi sono le persone con controllo significativo di PERUDA LEASING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04560735
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    PERUDA LEASING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A deed of covenant
    Creato il 19 gen 2006
    Consegnato il 07 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The vessel "ramform victory" registered on the bahamas flag with serial number 8000855 and includes any share or interest therin and her engines machinery boats tackle outfit spare gear fuel consumable or other stores belongings and appurtenances whether on board or ashore. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Pgs Shipping (Isle of Man) Limited
    Transazioni
    • 07 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A first priority bahamas ship mortgage
    Creato il 19 gen 2006
    Consegnato il 07 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    64 shares in the vessel "ramform victory" registered on the bahamas flag at the port of nassau with official number 8000855 and includes her boats guns ammunition small arms appurtenances.
    Persone aventi diritto
    • Pgs Shipping (Isle of Man) Limited
    Transazioni
    • 07 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security assignment
    Creato il 18 dic 2003
    Consegnato il 23 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Up to a maximum principal amount of £182,000,000 due or to become due from the company to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    With full title guarantee, the assigned property being the lease; the guarantee; any and all other guarantees; all claims, rights and remedies of the assignor arising out of or in connection with a breach of or default under or in connection with any of the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London
    Transazioni
    • 23 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    PERUDA LEASING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 giu 2024Data prevista di scioglimento
    28 giu 2023Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Howard Smith
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Nicholas James Timpson
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0