PERUDA LEASING LIMITED
Panoramica
Nome della società | PERUDA LEASING LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02638677 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PERUDA LEASING LIMITED?
- Leasing finanziario (64910) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova PERUDA LEASING LIMITED?
Indirizzo della sede legale | C/O Interpath Limited 10 Fleet Place EC4M 7RB London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PERUDA LEASING LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ABBEY NATIONAL JUNE LEASING (3) LIMITED | 01 mag 1992 | 01 mag 1992 |
FOCUSLOCAL LIMITED | 16 ago 1991 | 16 ago 1991 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PERUDA LEASING LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per PERUDA LEASING LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 18 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB a C/O Interpath Limited 10 Fleet Place London EC4M 7RB in data 28 lug 2023 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 4 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 7 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2021 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2020 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Charles Snailham il 31 ott 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Matthew James Thorne come amministratore in data 18 dic 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Kenyon Thomas come amministratore in data 30 nov 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2018 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 12 ott 2017
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PERUDA LEASING LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSHAW, Joanne Louise | Segretario | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | 180380540001 | |||||||
BARTLETT, Andrew William | Segretario | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House | British | 73852930003 | ||||||
SNAILHAM, Christopher Charles | Amministratore | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 202149290001 | ||||
THORNE, Matthew | Amministratore | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | United Kingdom | British | Banker | 267811560001 | ||||
BURTON, Jennifer Sandra | Segretario | 39b Butler Avenue HA1 4EJ West Harrow Middlesex | British | 100622570001 | ||||||
FLETCHER, Edward Michael | Segretario | 3 Aldrich Terrace SW18 3PU Earlsfield | British | 78572640002 | ||||||
NAGRECHA, Lenna | Segretario | 2 Oaktree Close HA7 2PX Stanmore Middlesex | British | 4949790001 | ||||||
RUTHERFORD, Adam Paul | Segretario | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House | British | 70451850004 | ||||||
ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Segretario | Abbey National House 2 Triton Square Regent's Place NW1 3AN London | 61749570003 | |||||||
BATCHELOR, Gwendoline Mary | Amministratore | 26 Crescent Wood Road SE26 6RU London | British | Finance Director | 34184100001 | |||||
BATCHELOR, Gwendoline Mary | Amministratore | 26 Crescent Wood Road SE26 6RU London | British | Finance Director | 34184100001 | |||||
COHEN, Jonathan Paul | Amministratore | 13 Gowan Lea 15 Woodford Road E18 2ER London | England | British | Accountant | 26953400001 | ||||
EDWARDS, Shirley Ann Elizabeth | Amministratore | Tilbrook Mill Lower Dean PE28 0LH Huntingdon Cambridgeshire | British | Financial Controller | 61855020002 | |||||
ELLIS, David James | Amministratore | Batts Row Cottage Laverstoke Lane, Laverstoke RG28 7PA Whitchurch Hampshire | England | British | Chartered Accountant | 113760650001 | ||||
GARRATT, Robin | Amministratore | Wansunt Road DA5 2DN Bexley 107 Kent | England | British | Chartered Accountant | 14290340001 | ||||
GOLDSBROUGH, Christopher Andrew John | Amministratore | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | United Kingdom | British/New Zealand | Banker | 153832500002 | ||||
GREEN, David Martin | Amministratore | 7 Restharrow Road Weavering ME14 5UH Maidstone Kent | British | Chartered Accountant | 83033800001 | |||||
HARLEY, Ian | Amministratore | 36 Kersey Drive Selsdon Ridge CR2 8SX South Croydon Surrey | British | Group Treasurer | 25941180001 | |||||
HOYLE, Stephen Lewis | Amministratore | 2 Haslemere Road N8 9QX London | United Kingdom | British | Banker | 96838010001 | ||||
HUTCHISON, Sarah Anne | Amministratore | 77 Parliament Hill NW3 2TH London | British | Banker | 36372610001 | |||||
JONES, David Gareth | Amministratore | Hillhouse Farm Misbrooks Green Road Beare Green RH5 4QQ Dorking Surrey | United Kingdom | British | Managing Director | 6205890002 | ||||
JONES, David Gareth | Amministratore | The Buffers 11 Deepdene Drive RH5 4AH Dorking Surrey | British | Asst Gen Mgr & Treasurer | 6205890001 | |||||
JULIAN, Suzanne Margaret | Amministratore | 25 Quick Road Chiswick W4 2BU London | British | Accountant | 36432460001 | |||||
LONG, Graham Stephen | Amministratore | 22 Cumberland Road SW13 9LY London | British | Director | 38022070005 | |||||
LOWE, William Nairn | Amministratore | Briar Gap Loseberry Road KT10 9DQ Claygate Surrey | England | British | Banker | 282371920001 | ||||
MACFARLANE, Stuart Edward | Amministratore | 29 Leaside Avenue Muswell Hill N10 3BT London | Australian | Banker | 125721120001 | |||||
MACFARLANE, Stuart Edward | Amministratore | 6 Lynmouth Road East Finchley N2 9LS London | Australian | Banker | 125721120002 | |||||
MCGIDDY, Mark Andrew | Amministratore | Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House 1 | Australian | Banker | 114990900003 | |||||
MERRICK, Anna | Amministratore | 27 Jacksons Lane Highgate N6 5SR London | British | Banker | 39621110002 | |||||
NICHOLLS, Jonathan Clive | Amministratore | Longmeadow Prinsted Lane PO10 8HR Emsworth Hampshire | United Kingdom | English | Deputy Treasurer | 127532290001 | ||||
OSWALD JACOBS, John James | Amministratore | 15 Clapham Common West Side SW4 9AJ London | Australian | Lawyer Banker | 77965500001 | |||||
PRESS, Matthew | Amministratore | 106 Ledbury Road W11 2AH London | Australian | Investment Banker | 104610910001 | |||||
SHAH, Rumit | Amministratore | 32 The Drive HA6 1HP Northwood Middlesex | England | British | Investment Banker | 101964890001 | ||||
SIVANITHY, Rajanbabu | Amministratore | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House | United Kingdom | British | Accountant | 63268810003 | ||||
THOMAS, David Kenyon | Amministratore | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House England England | United Kingdom | British | Banker | 59397060006 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PERUDA LEASING LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempurrite Leasing Limited | 06 apr 2016 | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
PERUDA LEASING LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A deed of covenant | Creato il 19 gen 2006 Consegnato il 07 feb 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The vessel "ramform victory" registered on the bahamas flag with serial number 8000855 and includes any share or interest therin and her engines machinery boats tackle outfit spare gear fuel consumable or other stores belongings and appurtenances whether on board or ashore. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A first priority bahamas ship mortgage | Creato il 19 gen 2006 Consegnato il 07 feb 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari 64 shares in the vessel "ramform victory" registered on the bahamas flag at the port of nassau with official number 8000855 and includes her boats guns ammunition small arms appurtenances. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Security assignment | Creato il 18 dic 2003 Consegnato il 23 dic 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Up to a maximum principal amount of £182,000,000 due or to become due from the company to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari With full title guarantee, the assigned property being the lease; the guarantee; any and all other guarantees; all claims, rights and remedies of the assignor arising out of or in connection with a breach of or default under or in connection with any of the agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
PERUDA LEASING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0