PUNCH TAVERNS (CMG) LIMITED

PUNCH TAVERNS (CMG) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPUNCH TAVERNS (CMG) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02639687
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PUNCH TAVERNS (CMG) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PUNCH TAVERNS (CMG) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Elsley Court
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PUNCH TAVERNS (CMG) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PUNCH PUB COMPANY (CMG) LIMITED 14 gen 200214 gen 2002
    C M GROUP LIMITED21 ago 199121 ago 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di PUNCH TAVERNS (CMG) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per PUNCH TAVERNS (CMG) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 ago 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di David Forde come amministratore in data 31 lug 2020

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 20 gen 2020

    • Capitale: GBP 2
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduction of share premium account 31/12/2019
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    legacy

    79 paginePARENT_ACC

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 ago 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Sean Michael Paterson come amministratore in data 24 apr 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David James Tannahill come amministratore in data 24 apr 2019

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 026396870065 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 64 in pieno

    4 pagineMR04

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 24 ago 2018 al 31 dic 2018

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 ago 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 19 ago 2017

    3 pagineAA

    Modifica dei dettagli di L&P34 Limited come persona con controllo significativo il 04 set 2017

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 set 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Jubilee House Second Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 2WF a Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street London W1W 8BE in data 08 set 2017

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Francesca Appleby come segretario in data 29 ago 2017

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Stephen Peter Dando come amministratore in data 29 ago 2017

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di PUNCH TAVERNS (CMG) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MOORE, Christopher John
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish136853310001
    MOUNTSTEVENS, Lawson John Wembridge
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    EnglandBritish112375050001
    PATERSON, Sean Michael
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4 Broadway Park
    Scotland
    Amministratore
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4 Broadway Park
    Scotland
    ScotlandBritish257892140001
    ANSPACH, Jeff Alan
    8 Turnpike Road
    LS24 8JS Tadcaster
    North Yorkshire
    Segretario
    8 Turnpike Road
    LS24 8JS Tadcaster
    North Yorkshire
    British49769150002
    APPLEBY, Francesca
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    191628480001
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    British637110001
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    175489140001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    British117216940001
    TYRRELL, Helen
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    161722570001
    WALSH, Sarah Elizabeth
    Low Hall
    Hackness
    YO13 0JN Scarborough
    North Yorkshire
    Segretario
    Low Hall
    Hackness
    YO13 0JN Scarborough
    North Yorkshire
    British30538860001
    ANSPACH, Jeff Alan
    8 Turnpike Road
    LS24 8JS Tadcaster
    North Yorkshire
    Amministratore
    8 Turnpike Road
    LS24 8JS Tadcaster
    North Yorkshire
    British49769150002
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BUTLER, Philip Stanley
    Garden House
    Skelton
    YO3 6XY York
    Yorkshire
    Amministratore
    Garden House
    Skelton
    YO3 6XY York
    Yorkshire
    EnglandBritish32490610001
    CRAWFURD-PORTER, James Justin
    1 Burnett Close
    Burton Leonard
    HG3 3TX Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    1 Burnett Close
    Burton Leonard
    HG3 3TX Harrogate
    North Yorkshire
    British49769230002
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    FORDE, David
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomIrish180590780001
    KEMP, Deborah Jane
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    Amministratore
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    United KingdomBritish79388130005
    LAMBERT, Stephen David
    Fernley 84 Newmarket Road
    NR2 2LB Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    Fernley 84 Newmarket Road
    NR2 2LB Norwich
    Norfolk
    British43572470001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    MITCHELL, Andrew John Bower, Rt Hon
    30 Gibson Square
    N1 0RD London
    Amministratore
    30 Gibson Square
    N1 0RD London
    UkBritish55191260001
    PATTON, Francis Andrew
    13 Lake Lock Grove
    Stanley
    WF3 4JJ Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    13 Lake Lock Grove
    Stanley
    WF3 4JJ Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish74404250001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002
    TANNAHILL, David James
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    ScotlandBritish237381690001
    THOMPSON, Andrew George
    5 Selkirk Drive
    CW4 7LJ Holmes Chapel
    Cheshire
    Amministratore
    5 Selkirk Drive
    CW4 7LJ Holmes Chapel
    Cheshire
    British66211570001
    THORLEY, Giles Alexander
    Charlton Manor
    Ashley Road Charlton Kings
    GL52 6NS Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Charlton Manor
    Ashley Road Charlton Kings
    GL52 6NS Cheltenham
    Gloucestershire
    Gb-EngBritish81928120001
    WALKER, William John
    1 Simpkins Close
    Weston Under Wetherley
    CV33 9GE Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    1 Simpkins Close
    Weston Under Wetherley
    CV33 9GE Leamington Spa
    Warwickshire
    EnglandBritish84041950001
    WALSH, James
    Low Hall
    Hackness
    YO13 0JN Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Low Hall
    Hackness
    YO13 0JN Scarborough
    North Yorkshire
    British30538870001
    WALSH, Sarah Elizabeth
    Low Hall
    Hackness
    YO13 0JN Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Low Hall
    Hackness
    YO13 0JN Scarborough
    North Yorkshire
    British30538860001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PUNCH TAVERNS (CMG) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Scotland
    29 ago 2017
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Scotland
    No
    Forma giuridicaCorporate
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleUnited Kingdom (Scotland)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc065527
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    L&P 34 Limited
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    06 apr 2016
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    PUNCH TAVERNS (CMG) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 08 ott 2014
    Consegnato il 15 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Trustee Company Limited as Security Trustee for the Punch Taverns Secured Parties
    Transazioni
    • 15 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 gen 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Third supplemental deed of charge
    Creato il 03 nov 2003
    Consegnato il 20 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other punch taverns secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all right, title, interest and benefit, present and future (if any), in, to and under: the f/h or l/h property comprising the further punch taverns mortgaged properties; and all estates or interests in such property and all buildings, trade and other fixtures. By way of fixed security the whole right, title, interest and benefit in and to the whole of the scottish trust property.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Trustee Company Limited (Or Such Other Person Acting as Security Trustee Under Thepunch Taverns First Priority Deed of Charge) (the "Security Trustee")
    Transazioni
    • 20 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental security agreement
    Creato il 12 giu 2003
    Consegnato il 13 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any transaction party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge any beneficial interest claim or entitlement it has in any pension fund, its goodwill, the benefit of any authorization (statutory or otherwise) held in connection with its use of any security asset. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Agent)
    Transazioni
    • 13 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental security agreement
    Creato il 14 mag 2003
    Consegnato il 22 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to any transaction party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge any beneficial interest,claim or entitlement it has in any pension fund;its goodwill;the benefit of any authorization held in connection with its use of any security asset;its uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental security agreement
    Creato il 26 feb 2003
    Consegnato il 04 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any transaction party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Black bull, commercial street, rothwell leeds t/n WYK687859, blue lion, tailors hill, great baddow, chelmsford essex t/n EX653768, chambers 2 railway road, leigh, wigan greater manchester t/n GM896953 for details of further property charged please refer to form 395. by way of first fixed charge and by way of security the assets relating to that property.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Facility Agent and Arranger)
    Transazioni
    • 04 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental security agreement
    Creato il 10 feb 2003
    Consegnato il 14 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any transaction party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the assets relating to the property, the bell 2 westbourne road bedford MK40 4LB t/N.BD177542, the blue ball 57 bradway grantchester cambridge CB3 9NQ t/N.CB160171, the bricklayers arms 1 new town potton sandy bedfordshire SG19 2QH t/N.BD177621 (for details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Facility Agent and Arranger)
    Transazioni
    • 14 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental security agreement
    Creato il 10 feb 2003
    Consegnato il 14 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any transaction party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the assets relating to the property-ashford arms church street ashford in the water bakewell derbyshire DE45 1QB t/N.DY184099, biddy mulligans 79 milbourne street carlisle cumbria CA2 5XF, bridge hotel the square minsterley SY5 0BA t/N.SL74471 (for details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Facility Agent and Arranger)
    Transazioni
    • 14 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental security agreement
    Creato il 20 mag 2002
    Consegnato il 30 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or any transaction party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The airdale heifer 53 stockbank road batteford mirfield west yorkshire t/n WYK492888; the albion bridge street morley t/n WYK596143; the angel 151 main street grenoside south yorkshire t/m SYK376158 (for full details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As the Agent)
    Transazioni
    • 30 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 10 dic 2001
    Consegnato il 19 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to each transaction party under each transaction document to which the obligor is a party
    Brevi particolari
    Real property k/a albion the village ryhope sunderland tyne & wear t/n TY327903 for further properties please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Trustee for Itself, the Finance Parties and the Hedging Counterparties Under the Intercreditor Deed (The"Security Trustee")
    Transazioni
    • 19 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 mar 1999
    Consegnato il 30 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 30 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 14 dic 1998
    Consegnato il 17 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a old plough main street egmanston mansfield nottinghamshire t/no NT301761. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 15 ott 1998
    Consegnato il 22 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as great northern station street boston lincolnshire title number LL74070.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 15 ott 1998
    Consegnato il 22 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as the bird in hand high street measham near ashby de la zouch leicestershire title number LT284984.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 set 1998
    Consegnato il 02 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as the hebble brook public house 2 mill lane old mixenden halifax west yorkshire; t/no WYK527860. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 14 set 1998
    Consegnato il 17 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a the bay horse inn manor street evenwood bishop auckland county durham t/no DU136637. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 09 set 1998
    Consegnato il 15 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a the highwayman's tavern ousegate selby northyorkshire t/n NYK144507. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 26 ago 1998
    Consegnato il 04 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a the montalt arms public house george street mablethorpe lincolnshire t/no LL46842. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 01 lug 1998
    Consegnato il 10 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a the electrician's arms 159-161 manchester road huddersfield west yorkshire t/no WYK532249. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 lug 1997
    Consegnato il 06 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a the junction 115 church street manningham bradford west yorkshire t/no.WYK498047. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 lug 1997
    Consegnato il 06 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a goldsborough inn bolton road bradfordwest yorkshire t/n WYK332185. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 lug 1997
    Consegnato il 06 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a the black lion burnley road luddendenfoot halifax west yorkshire.t/no.WYK418755. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 lug 1997
    Consegnato il 01 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a the red ginn bowling old lane bradford west yorkshire t/n WYK588284. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 lug 1997
    Consegnato il 01 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a the craven gate 2 dow street leeds west yorkshire t/no WYK597383 and WYK589189. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 lug 1997
    Consegnato il 01 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a the malt shovel church lane southowram halifax west yorkshire t/n WYK339951. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 29 nov 1996
    Consegnato il 09 dic 1996
    In corso
    Importo garantito
    Any sums due or to become due from the company to the chargee under the provisions of the covenant contained in clause 2 of the charge
    Brevi particolari
    Black swan church street north cave goole.
    Persone aventi diritto
    • £Whitbread PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0