FISHING REPUBLIC TRADING LIMITED

FISHING REPUBLIC TRADING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFISHING REPUBLIC TRADING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02641312
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FISHING REPUBLIC TRADING LIMITED?

    • Agenti specializzati nella vendita di altri prodotti particolari (46180) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Commercio all'ingrosso di abbigliamento e calzature (46420) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, attrezzature da pesca, articoli da campeggio, barche e biciclette (47640) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Vendita al dettaglio tramite case d'ordine per corrispondenza o tramite Internet (47910) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova FISHING REPUBLIC TRADING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Riverside House
    Irwell Street
    M3 5EN Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FISHING REPUBLIC TRADING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LUREFLASH INTERNATIONAL LIMITED10 dic 199710 dic 1997
    LUREFLASH PRODUCTS LIMITED28 ago 199128 ago 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di FISHING REPUBLIC TRADING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per FISHING REPUBLIC TRADING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    34 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    34 pagineAM10

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    10 pagineAM02

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    29 pagineAM10

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo o aggiuntivo

    3 pagineAM11

    Avviso dell'ordinanza di revoca dell'amministratore dall'incarico

    11 pagineAM16

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    31 pagineAM10

    Indirizzo della sede legale modificato da Tower 12 18-22 Bridge Street Spinningfields Manchester M3 3BZ a Riverside House Irwell Street Manchester M3 5EN in data 27 dic 2019

    2 pagineAD01

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    29 pagineAM10

    Risultato della riunione dei creditori

    6 pagineAM07

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    74 pagineAM03

    Indirizzo della sede legale modificato da Vulcan Works Chesterton Road Eastwood Trading Estate Eastwood Rotherham S65 1SU a Tower 12 18-22 Bridge Street Spinningfields Manchester M3 3BZ in data 25 gen 2019

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    39 pagineAA

    Nomina di Mr Stephen Kyriacou come amministratore in data 20 set 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Jonathan Richard Walker come amministratore in data 20 set 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Zoe Gross come amministratore in data 20 set 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Henry Gross come amministratore in data 20 set 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jean Estelle Gross come amministratore in data 20 set 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 ago 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 026413120008 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 026413120009 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    34 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di FISHING REPUBLIC TRADING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GROSS, Stephen John
    2 Farrington Court
    Wickersley
    S66 1JQ Rotherham
    South Yorkshire
    Segretario
    2 Farrington Court
    Wickersley
    S66 1JQ Rotherham
    South Yorkshire
    British24918650003
    GROSS, Stephen John
    2 Farrington Court
    Wickersley
    S66 1JQ Rotherham
    South Yorkshire
    Amministratore
    2 Farrington Court
    Wickersley
    S66 1JQ Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritish24918650003
    KYRIACOU, Stephen
    Irwell Street
    M3 5EN Manchester
    Riverside House
    Amministratore
    Irwell Street
    M3 5EN Manchester
    Riverside House
    EnglandBritish211861130001
    WALKER, Jonathan Richard
    Irwell Street
    M3 5EN Manchester
    Riverside House
    Amministratore
    Irwell Street
    M3 5EN Manchester
    Riverside House
    EnglandBritish250602530001
    SEMKEN LIMITED
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree Borehamwood
    Hertfordshire
    Segretario nominato
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree Borehamwood
    Hertfordshire
    900005970001
    GROSS, Jean Estelle
    Mourino Princess Road
    S64 0AW Mexborough
    South Yorkshire
    Amministratore
    Mourino Princess Road
    S64 0AW Mexborough
    South Yorkshire
    United KingdomBritish51813950001
    GROSS, John Henry
    Mourino Princess Road
    S64 0AW Mexborough
    South Yorkshire
    Amministratore
    Mourino Princess Road
    S64 0AW Mexborough
    South Yorkshire
    EnglandBritish24918660001
    GROSS, Zoe
    2 Farrington Court
    Wickersley
    S66 1JQ Rotherham
    South Yorkshire
    Amministratore
    2 Farrington Court
    Wickersley
    S66 1JQ Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritish51813980002
    LUFMER LIMITED
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree Borehamwood
    Hertfordshire
    Amministratore delegato nominato
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree Borehamwood
    Hertfordshire
    900005960001

    Chi sono le persone con controllo significativo di FISHING REPUBLIC TRADING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Chesterton Road
    Eastwood Trading Estate
    S65 1SU Rotherham
    Vulcan Works
    England
    06 apr 2016
    Chesterton Road
    Eastwood Trading Estate
    S65 1SU Rotherham
    Vulcan Works
    England
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione09196822
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    FISHING REPUBLIC TRADING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 27 lug 2015
    Consegnato il 28 lug 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    A fixed and floating charge over all assets.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 28 lug 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 giu 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 10 giu 2015
    Consegnato il 16 giu 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    A legal mortgage over the freehold property known as hudson house and land and buildings on the north side of victoria street, kilnhurst, rotherham. Hm land registry title number(s) SYK216858 and SYK311993.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 16 giu 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 giu 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assignment of life policy
    Creato il 05 feb 2009
    Consegnato il 11 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of deed of assignment of life policy over halifax financial services p/no. ASSH058422.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 09 gen 2003
    Consegnato il 10 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and premises at victoria street kilnhurst rotherham south yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 23 ott 2002
    Consegnato il 30 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 19 mar 2001
    Consegnato il 24 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land at rear of victoria buildings victoria street kilnhurst mexborough t/no SYK411293. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 16 apr 1998
    Consegnato il 28 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 10 mar 1997
    Consegnato il 12 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a victoria street kilnhurst rotherham county of south yorkshire and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 10 mar 1997
    Consegnato il 12 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a victoria street kilnhurst rotherham in the county of south yorkshire and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    FISHING REPUBLIC TRADING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 dic 2018Inizio dell'amministrazione
    17 dic 2020Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Katy Mcandrew
    Leonard Curtis Riverside House
    Irwell Street
    M3 5EN Manchester
    Praticante
    Leonard Curtis Riverside House
    Irwell Street
    M3 5EN Manchester
    Andrew Poxon
    Tower 12 Manchester House 18/22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Praticante
    Tower 12 Manchester House 18/22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Julien Robert Irving
    Tower 12 Manchester House 18-22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Praticante
    Tower 12 Manchester House 18-22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0