DELTA RADIO LIMITED

DELTA RADIO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDELTA RADIO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02642617
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DELTA RADIO LIMITED?

    • Radiodiffusione (60100) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova DELTA RADIO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Media House Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DELTA RADIO LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WEY VALLEY RADIO LTD04 set 199204 set 1992
    THIRD MILE INVESTMENT LTD.04 ott 199104 ott 1991
    ALLIED RADIO LIMITED03 set 199103 set 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di DELTA RADIO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per DELTA RADIO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2021 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2020 al 31 dic 2020

    1 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2019

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account cancelled 15/09/2020
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale al 01 ott 2020

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Diedre Ann Ford il 31 gen 2019

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Celador Radio Limited come persona con controllo significativo il 27 feb 2019

    2 paginePSC05

    Cessazione di Celador Entertainment Limited come persona con controllo significativo il 31 gen 2019

    1 paginePSC07

    Notifica di Celador Radio Limited come persona con controllo significativo il 31 gen 2019

    2 paginePSC02

    Cessazione della carica di Paul Adrian Smith come amministratore in data 31 gen 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Michael Charman come amministratore in data 31 gen 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Bauer Group Secretariat Limited come segretario in data 31 gen 2019

    2 pagineAP04

    Nomina di Mrs Sarah Jane Vickery come amministratore in data 31 gen 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Paul Anthony Keenan come amministratore in data 31 gen 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Diedre Ann Ford come amministratore in data 31 gen 2019

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Celador Radio Roman Landing Kingsway Southampton Hampshire SO14 1BN England a Media House Peterborough Business Park Lynch Wood Peterborough PE2 6EA in data 15 feb 2019

    1 pagineAD01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2018

    2 pagineAA

    Cessazione di Celador Entertainment Ltd come persona con controllo significativo il 30 lug 2018

    1 paginePSC07

    Chi sono gli amministratori di DELTA RADIO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BAUER GROUP SECRETARIAT LIMITED
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Segretario
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione00944753
    159023720001
    FORD, Deidre Ann
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    EnglandBritish255749500002
    KEENAN, Paul Anthony
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    EnglandBritish39692770004
    VICKERY, Sarah Jane
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    United KingdomBritish119137220002
    BRUCE, David Kevin
    10 Huxley Close
    GU7 2AS Godalming
    Surrey
    Segretario
    10 Huxley Close
    GU7 2AS Godalming
    Surrey
    British37948150001
    CHRISTMAS, Colin Roy George
    College Place
    Alfred Road
    GU9 8JE Farnham
    4
    Surrey
    England
    Segretario
    College Place
    Alfred Road
    GU9 8JE Farnham
    4
    Surrey
    England
    British1678140002
    CLAYTON, Yvonne Lynn
    South Bank
    31a Woodland Avenue
    TR10 8PG Penryn
    Cornwall
    Segretario
    South Bank
    31a Woodland Avenue
    TR10 8PG Penryn
    Cornwall
    British40640850001
    JOHNSON, Mark Alasdair Smith
    Long Acre
    WC2E 9LG London
    39
    United Kingdom
    Segretario
    Long Acre
    WC2E 9LG London
    39
    United Kingdom
    171897870001
    KITNEY, Stephen James
    Sunchyme15 Tongham Road
    Runfold
    GU10 1PH Farnham
    Surrey
    Segretario
    Sunchyme15 Tongham Road
    Runfold
    GU10 1PH Farnham
    Surrey
    British90188890001
    RUSHTON, June Elizabeth
    100 London Road
    Holybourne
    GU34 4EW Alton
    Hampshire
    Segretario
    100 London Road
    Holybourne
    GU34 4EW Alton
    Hampshire
    British31945390001
    YATES, Susan Ruth
    Union Road
    GU9 7PT Farnham
    The Old Court House
    Surrey
    Segretario
    Union Road
    GU9 7PT Farnham
    The Old Court House
    Surrey
    British55952690003
    BAKER, John
    1 Pound Cottages
    Stroud Green
    RG14 7JH Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    1 Pound Cottages
    Stroud Green
    RG14 7JH Newbury
    Berkshire
    British122288220001
    BRUCE, David Kevin
    10 Huxley Close
    GU7 2AS Godalming
    Surrey
    Amministratore
    10 Huxley Close
    GU7 2AS Godalming
    Surrey
    British37948150001
    CHARMAN, Paul Michael
    Kingsway
    St. Marys Place
    SO14 1BN Southampton
    Roman Landing
    England
    Amministratore
    Kingsway
    St. Marys Place
    SO14 1BN Southampton
    Roman Landing
    England
    EnglandBritish226735460001
    CHEESEWRIGHT, Gillian Anne Elizabeth
    23 Beechlands Road
    Medstead
    GU34 5EQ Alton
    Hampshire
    Amministratore
    23 Beechlands Road
    Medstead
    GU34 5EQ Alton
    Hampshire
    British34511210001
    CHRISTMAS, Colin Roy George
    College Place
    Alfred Road
    GU9 8JE Farnham
    4
    Surrey
    England
    Amministratore
    College Place
    Alfred Road
    GU9 8JE Farnham
    4
    Surrey
    England
    EnglandBritish1678140002
    CRAIG, Wendy Diane, Mrs.
    Union Road
    GU9 7PT Farnham
    The Old Court House
    Surrey
    Amministratore
    Union Road
    GU9 7PT Farnham
    The Old Court House
    Surrey
    United KingdomBritish57867210001
    DOEL, Brian Gilroy
    Union Road
    GU9 7PT Farnham
    The Old Court House
    Surrey
    Amministratore
    Union Road
    GU9 7PT Farnham
    The Old Court House
    Surrey
    EnglandBritish107694860001
    HANDLEY, Valerie Jayne
    Spring Cottage
    Stoney Bottom Grayshott
    GU26 6HN Hindhead
    Surrey
    Amministratore
    Spring Cottage
    Stoney Bottom Grayshott
    GU26 6HN Hindhead
    Surrey
    EnglandBritish44328220001
    HARRIS, Martyn Vaughan
    5 The Cloisters
    Steeple Drive
    GU34 1TW Alton
    Hampshire
    Amministratore
    5 The Cloisters
    Steeple Drive
    GU34 1TW Alton
    Hampshire
    British15804830001
    HAWKSLEY, Andrew
    c/o Celador Radio
    Kingsway
    SO14 1BN Southampton
    Roman Landing
    England
    Amministratore
    c/o Celador Radio
    Kingsway
    SO14 1BN Southampton
    Roman Landing
    England
    EnglandBritish244980330001
    HEDGES, Gerald Michael
    64 Patricks Copse Road
    GU33 7DW Liss
    Hampshire
    Amministratore
    64 Patricks Copse Road
    GU33 7DW Liss
    Hampshire
    British3309540001
    ISAAC, Keith Shelby
    Clare Cottage Fir Tree Road
    KT22 8RF Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Clare Cottage Fir Tree Road
    KT22 8RF Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish5862580001
    JOHNSON, Mark Alasdair Smith
    Long Acre
    WC2E 9LG London
    39
    United Kingdom
    Amministratore
    Long Acre
    WC2E 9LG London
    39
    United Kingdom
    EnglandBritish79195840006
    KITNEY, Stephen James
    Sunchyme15 Tongham Road
    Runfold
    GU10 1PH Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Sunchyme15 Tongham Road
    Runfold
    GU10 1PH Farnham
    Surrey
    British90188890001
    LAWLEY, Richard Henry John
    3 Pine Bank
    GU26 6SR Hindhead
    Surrey
    Amministratore
    3 Pine Bank
    GU26 6SR Hindhead
    Surrey
    EnglandBritish83623820001
    MANN, Paul
    80 Normandy Street
    GU34 1DH Alton
    Hampshire
    Amministratore
    80 Normandy Street
    GU34 1DH Alton
    Hampshire
    English31945400001
    MANN, Terrence Keith
    23 Hillside Crescent
    Uplands
    SA2 0RD Swansea
    Amministratore
    23 Hillside Crescent
    Uplands
    SA2 0RD Swansea
    WalesBritish37372220003
    MARCUS, Paul Arthur
    206 Mytchett Road
    GU16 6AE Camberley
    Surrey
    Amministratore
    206 Mytchett Road
    GU16 6AE Camberley
    Surrey
    EnglandBritish114397970001
    ODELL, Melanie Jill
    18 Chestnut Avenue
    GU27 2AT Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    18 Chestnut Avenue
    GU27 2AT Haslemere
    Surrey
    United KingdomBritish67969220001
    PAYNE, Susan Elizabeth
    89 New Cross Road
    GU2 9NU Guildford
    Surrey
    Amministratore
    89 New Cross Road
    GU2 9NU Guildford
    Surrey
    British78913920001
    POWELL, Michael Leslie
    Nightingale Cottage
    Great Holt Old Lane Dockenfield
    GU10 4HQ Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Nightingale Cottage
    Great Holt Old Lane Dockenfield
    GU10 4HQ Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish11273310001
    PRIOR, Rosemary
    17 Woodpecker Close
    GU35 0UR Bordon
    Hampshire
    Amministratore
    17 Woodpecker Close
    GU35 0UR Bordon
    Hampshire
    British89707450001
    ROGERS, William James Gerald
    16 Regent Square
    TR18 4BG Penzance
    Cornwall
    Amministratore
    16 Regent Square
    TR18 4BG Penzance
    Cornwall
    British37957110002
    RUSHTON, June Elizabeth
    Draycott House
    3a Blackberry Lane, Four Marks
    GU34 5BN Alton
    Hampshire
    Amministratore
    Draycott House
    3a Blackberry Lane, Four Marks
    GU34 5BN Alton
    Hampshire
    British31945390002

    Chi sono le persone con controllo significativo di DELTA RADIO LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    31 gen 2019
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05439096
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Paddington House
    Festival Place
    RG21 7JN Basingstoke
    Suite 2
    England
    06 apr 2016
    Paddington House
    Festival Place
    RG21 7JN Basingstoke
    Suite 2
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05679435
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Kingsway
    St. Marys Place
    SO14 1BN Southampton
    Roman Landing
    England
    06 apr 2016
    Kingsway
    St. Marys Place
    SO14 1BN Southampton
    Roman Landing
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05679435
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    DELTA RADIO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 27 mar 2001
    Consegnato il 29 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date
    Brevi particolari
    All monies standing to the creedit of a deposit account opened by the landlord pursuant to the lease.
    Persone aventi diritto
    • David Henry James Kemp, Judith Kemp, Christopher Mark Kemp and Sarah Jane Rose
    Transazioni
    • 29 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 22 gen 2000
    Consegnato il 11 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 16 ott 1992
    Consegnato il 20 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date
    Brevi particolari
    The sum of £3,650 under the lease.
    Persone aventi diritto
    • D.H.J. Kemp
    • C.M. Kemp
    • S.J. Rose
    • J. Kemp
    Transazioni
    • 20 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0