DELTA RADIO LIMITED
Panoramica
| Nome della società | DELTA RADIO LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02642617 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DELTA RADIO LIMITED?
- Radiodiffusione (60100) / Informazione e comunicazione
Dove si trova DELTA RADIO LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Media House Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di DELTA RADIO LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| WEY VALLEY RADIO LTD | 04 set 1992 | 04 set 1992 |
| THIRD MILE INVESTMENT LTD. | 04 ott 1991 | 04 ott 1991 |
| ALLIED RADIO LIMITED | 03 set 1991 | 03 set 1991 |
Quali sono gli ultimi bilanci di DELTA RADIO LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per DELTA RADIO LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2021 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2020 al 31 dic 2020 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2019 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stato del capitale al 01 ott 2020
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Diedre Ann Ford il 31 gen 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Celador Radio Limited come persona con controllo significativo il 27 feb 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||||||
Cessazione di Celador Entertainment Limited come persona con controllo significativo il 31 gen 2019 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||||||
Notifica di Celador Radio Limited come persona con controllo significativo il 31 gen 2019 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Paul Adrian Smith come amministratore in data 31 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Paul Michael Charman come amministratore in data 31 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Bauer Group Secretariat Limited come segretario in data 31 gen 2019 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||||||
Nomina di Mrs Sarah Jane Vickery come amministratore in data 31 gen 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Paul Anthony Keenan come amministratore in data 31 gen 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Diedre Ann Ford come amministratore in data 31 gen 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Celador Radio Roman Landing Kingsway Southampton Hampshire SO14 1BN England a Media House Peterborough Business Park Lynch Wood Peterborough PE2 6EA in data 15 feb 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2018 | 2 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione di Celador Entertainment Ltd come persona con controllo significativo il 30 lug 2018 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di DELTA RADIO LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUER GROUP SECRETARIAT LIMITED | Segretario | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom |
| 159023720001 | ||||||||||
| FORD, Deidre Ann | Amministratore | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | England | British | 255749500002 | |||||||||
| KEENAN, Paul Anthony | Amministratore | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | England | British | 39692770004 | |||||||||
| VICKERY, Sarah Jane | Amministratore | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | United Kingdom | British | 119137220002 | |||||||||
| BRUCE, David Kevin | Segretario | 10 Huxley Close GU7 2AS Godalming Surrey | British | 37948150001 | ||||||||||
| CHRISTMAS, Colin Roy George | Segretario | College Place Alfred Road GU9 8JE Farnham 4 Surrey England | British | 1678140002 | ||||||||||
| CLAYTON, Yvonne Lynn | Segretario | South Bank 31a Woodland Avenue TR10 8PG Penryn Cornwall | British | 40640850001 | ||||||||||
| JOHNSON, Mark Alasdair Smith | Segretario | Long Acre WC2E 9LG London 39 United Kingdom | 171897870001 | |||||||||||
| KITNEY, Stephen James | Segretario | Sunchyme15 Tongham Road Runfold GU10 1PH Farnham Surrey | British | 90188890001 | ||||||||||
| RUSHTON, June Elizabeth | Segretario | 100 London Road Holybourne GU34 4EW Alton Hampshire | British | 31945390001 | ||||||||||
| YATES, Susan Ruth | Segretario | Union Road GU9 7PT Farnham The Old Court House Surrey | British | 55952690003 | ||||||||||
| BAKER, John | Amministratore | 1 Pound Cottages Stroud Green RG14 7JH Newbury Berkshire | British | 122288220001 | ||||||||||
| BRUCE, David Kevin | Amministratore | 10 Huxley Close GU7 2AS Godalming Surrey | British | 37948150001 | ||||||||||
| CHARMAN, Paul Michael | Amministratore | Kingsway St. Marys Place SO14 1BN Southampton Roman Landing England | England | British | 226735460001 | |||||||||
| CHEESEWRIGHT, Gillian Anne Elizabeth | Amministratore | 23 Beechlands Road Medstead GU34 5EQ Alton Hampshire | British | 34511210001 | ||||||||||
| CHRISTMAS, Colin Roy George | Amministratore | College Place Alfred Road GU9 8JE Farnham 4 Surrey England | England | British | 1678140002 | |||||||||
| CRAIG, Wendy Diane, Mrs. | Amministratore | Union Road GU9 7PT Farnham The Old Court House Surrey | United Kingdom | British | 57867210001 | |||||||||
| DOEL, Brian Gilroy | Amministratore | Union Road GU9 7PT Farnham The Old Court House Surrey | England | British | 107694860001 | |||||||||
| HANDLEY, Valerie Jayne | Amministratore | Spring Cottage Stoney Bottom Grayshott GU26 6HN Hindhead Surrey | England | British | 44328220001 | |||||||||
| HARRIS, Martyn Vaughan | Amministratore | 5 The Cloisters Steeple Drive GU34 1TW Alton Hampshire | British | 15804830001 | ||||||||||
| HAWKSLEY, Andrew | Amministratore | c/o Celador Radio Kingsway SO14 1BN Southampton Roman Landing England | England | British | 244980330001 | |||||||||
| HEDGES, Gerald Michael | Amministratore | 64 Patricks Copse Road GU33 7DW Liss Hampshire | British | 3309540001 | ||||||||||
| ISAAC, Keith Shelby | Amministratore | Clare Cottage Fir Tree Road KT22 8RF Leatherhead Surrey | England | British | 5862580001 | |||||||||
| JOHNSON, Mark Alasdair Smith | Amministratore | Long Acre WC2E 9LG London 39 United Kingdom | England | British | 79195840006 | |||||||||
| KITNEY, Stephen James | Amministratore | Sunchyme15 Tongham Road Runfold GU10 1PH Farnham Surrey | British | 90188890001 | ||||||||||
| LAWLEY, Richard Henry John | Amministratore | 3 Pine Bank GU26 6SR Hindhead Surrey | England | British | 83623820001 | |||||||||
| MANN, Paul | Amministratore | 80 Normandy Street GU34 1DH Alton Hampshire | English | 31945400001 | ||||||||||
| MANN, Terrence Keith | Amministratore | 23 Hillside Crescent Uplands SA2 0RD Swansea | Wales | British | 37372220003 | |||||||||
| MARCUS, Paul Arthur | Amministratore | 206 Mytchett Road GU16 6AE Camberley Surrey | England | British | 114397970001 | |||||||||
| ODELL, Melanie Jill | Amministratore | 18 Chestnut Avenue GU27 2AT Haslemere Surrey | United Kingdom | British | 67969220001 | |||||||||
| PAYNE, Susan Elizabeth | Amministratore | 89 New Cross Road GU2 9NU Guildford Surrey | British | 78913920001 | ||||||||||
| POWELL, Michael Leslie | Amministratore | Nightingale Cottage Great Holt Old Lane Dockenfield GU10 4HQ Farnham Surrey | United Kingdom | British | 11273310001 | |||||||||
| PRIOR, Rosemary | Amministratore | 17 Woodpecker Close GU35 0UR Bordon Hampshire | British | 89707450001 | ||||||||||
| ROGERS, William James Gerald | Amministratore | 16 Regent Square TR18 4BG Penzance Cornwall | British | 37957110002 | ||||||||||
| RUSHTON, June Elizabeth | Amministratore | Draycott House 3a Blackberry Lane, Four Marks GU34 5BN Alton Hampshire | British | 31945390002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di DELTA RADIO LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celador Radio Limited | 31 gen 2019 | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Celador Entertainment Limited | 06 apr 2016 | Paddington House Festival Place RG21 7JN Basingstoke Suite 2 England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Celador Entertainment Ltd | 06 apr 2016 | Kingsway St. Marys Place SO14 1BN Southampton Roman Landing England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
DELTA RADIO LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Creato il 27 mar 2001 Consegnato il 29 mar 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date | |
Brevi particolari All monies standing to the creedit of a deposit account opened by the landlord pursuant to the lease. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 22 gen 2000 Consegnato il 11 feb 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 16 ott 1992 Consegnato il 20 ott 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date | |
Brevi particolari The sum of £3,650 under the lease. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0