THE THOMAS FOOD PARTNERSHIP LIMITED

THE THOMAS FOOD PARTNERSHIP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE THOMAS FOOD PARTNERSHIP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02644839
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE THOMAS FOOD PARTNERSHIP LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova THE THOMAS FOOD PARTNERSHIP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE THOMAS FOOD PARTNERSHIP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KT557 LIMITED11 set 199111 set 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE THOMAS FOOD PARTNERSHIP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al01 ott 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per THE THOMAS FOOD PARTNERSHIP LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per THE THOMAS FOOD PARTNERSHIP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 11 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 set 2013

    Stato del capitale al 12 set 2013

    • Capitale: GBP 653,380.08
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Food Partners House Poyle Road Colnbrook Slough SL3 0QX England* in data 10 set 2013

    1 pagineAD01

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Varie

    Section 519
    2 pagineMISC

    Cessazione della carica di Christopher Thomas come amministratore

    2 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    11 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O 01/11/2011 Food Partners House Poyle Road Colnbrook Slough SL3 0QX England* in data 08 gen 2013

    1 pagineAD01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2012 al 31 mar 2013

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Steve Wood come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 11 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Gavin Cox il 01 nov 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Thomas il 01 nov 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Steve Wood il 01 nov 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Gavin Cox il 01 nov 2011

    1 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da * Food Partners House Poyle Road Colnbrook, Slough England SL3 0EN England* in data 13 nov 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 01 ott 2011

    19 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Cessazione della carica di Ian Mccracken come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Joe Rainert come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Julian Momen come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Julian Momen come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di THE THOMAS FOOD PARTNERSHIP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COX, Gavin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Segretario
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    165756680001
    COX, Gavin Eliot
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Amministratore
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    United KingdomBritishDirector153840250001
    COX, Jacqueline
    81 Manchester Road
    Deepcar
    S30 5QX Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    81 Manchester Road
    Deepcar
    S30 5QX Sheffield
    South Yorkshire
    British11720990002
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    Segretario
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    British150501350001
    WATSON, David Ian
    Knoll Farm Aston
    Hope
    S33 6RA Hope Valley
    Segretario
    Knoll Farm Aston
    Hope
    S33 6RA Hope Valley
    BritishFinance Director8474300001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    Segretario
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    119967690001
    BARNES, Kevin
    11 Heather Lane
    Ravenstone
    LE67 2AH Leicestershire
    Amministratore
    11 Heather Lane
    Ravenstone
    LE67 2AH Leicestershire
    BritishOperations Director96190510001
    BROWN, Cameron Matthew
    23 Cunningham Gardens
    PA6 7GA Houston
    Renfrewshire
    Amministratore
    23 Cunningham Gardens
    PA6 7GA Houston
    Renfrewshire
    United KingdomBritishCompany Director108690220001
    COX, Jacqueline
    81 Manchester Road
    Deepcar
    S30 5QX Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    81 Manchester Road
    Deepcar
    S30 5QX Sheffield
    South Yorkshire
    BritishLegal Executive11720990002
    DEUTSCH, Andrew Simon
    43 Whirlow Park Road
    S11 9NN Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    43 Whirlow Park Road
    S11 9NN Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishManaging Director99357230001
    FILDES, Richard
    Manley Knoll
    WA6 9DX Manley
    Cheshire
    Amministratore
    Manley Knoll
    WA6 9DX Manley
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director94278790001
    FORD, Martin Francis
    23 Swallow Drive
    Claypole
    NG23 5FG Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    23 Swallow Drive
    Claypole
    NG23 5FG Newark
    Nottinghamshire
    EnglandBritishTechnical Director85713000001
    FRITH, David Frederick Alfred
    White House 21 Whirlow Park Road
    S11 9NN Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    White House 21 Whirlow Park Road
    S11 9NN Sheffield
    South Yorkshire
    BritishFinancial Consultant3549820001
    HAZELDEAN, James William
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    Amministratore
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    ScotlandBritishCompany Director10359650007
    HUNTER, Nigel John
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    Amministratore
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United KingdomBritishDirector45026040001
    JEFFREY, Nicholas
    Riley Croft
    Eyam
    S32 5QZ Hope Valley
    Amministratore
    Riley Croft
    Eyam
    S32 5QZ Hope Valley
    EnglandBritishChief Executive15639340001
    JOHNSTONE, Ian Duncan
    67 Hillside Avenue
    Bromley Cross
    BL7 9NQ Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    67 Hillside Avenue
    Bromley Cross
    BL7 9NQ Bolton
    Lancashire
    BritishProduction Director70923770001
    MCCARTNEY, William
    4 Holly Grange
    WA14 2HU Bowdon
    Cheshire
    Amministratore
    4 Holly Grange
    WA14 2HU Bowdon
    Cheshire
    BritishBusiness Consultant33576380001
    MCCOY, Stephen
    17 Westcroft Lane
    Hambleton
    YO8 9JQ Selby
    North Yorkshire
    Amministratore
    17 Westcroft Lane
    Hambleton
    YO8 9JQ Selby
    North Yorkshire
    BritishProduction Director35813550001
    MCCRACKEN, Ian
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Amministratore
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector139503220001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    Amministratore
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    EnglandBritishDirector51784930002
    POCOCK, Patrick William
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    Amministratore
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    BritishCompany Director96978470001
    RAINERT, Joe Frederick
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    England
    England
    Amministratore
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    England
    England
    United KingdomBritishDirector100745180001
    RIDLER, Mark Philip
    35 Oakdale Road Netheredge
    S7 1SL Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    35 Oakdale Road Netheredge
    S7 1SL Sheffield
    South Yorkshire
    BritishSolicitor66732880002
    ROTHERY, Janet Ann
    9 Leebrook Drive
    Owlthorpe
    S20 6QG Sheffield
    Yorkshire
    Amministratore
    9 Leebrook Drive
    Owlthorpe
    S20 6QG Sheffield
    Yorkshire
    EnglandEnglishFinance Director98779140001
    SHEPHERD, James Gordon
    Ridgeways 100 Bawtry Road
    Bessacarr
    DN4 7BW Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Ridgeways 100 Bawtry Road
    Bessacarr
    DN4 7BW Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritishChief Executive8474280001
    SIMS, Howard Ronald
    Acre Head Longburgh
    Burgh-By-Sands
    CA5 6AF Carlisle
    Cumbria
    Amministratore
    Acre Head Longburgh
    Burgh-By-Sands
    CA5 6AF Carlisle
    Cumbria
    BritishCompany Director801940002
    SORSBY, John Mark
    7 Oates Orchard
    Mosborough
    S20 5PG Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    7 Oates Orchard
    Mosborough
    S20 5PG Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritishTechnical Director96190400001
    THOMAS, Christopher
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Amministratore
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    United KingdomBritishDirector63844650001
    THOMAS, Rodney Neil Seagoe
    Castle Mount Newcastle Avenue
    S80 1EY Worksop
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Castle Mount Newcastle Avenue
    S80 1EY Worksop
    Nottinghamshire
    BritishManaging Director18102180001
    THOMAS, Sarah Rosemary
    Castle Mount Newcastle Avenue
    S80 1EY Worksop
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Castle Mount Newcastle Avenue
    S80 1EY Worksop
    Nottinghamshire
    BritishDirector18102170001
    TRUELOVE, Amelia Anne
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    BritishDirector37845970003
    WATSON, David Ian
    Knoll Farm Aston
    Hope
    S33 6RA Hope Valley
    Amministratore
    Knoll Farm Aston
    Hope
    S33 6RA Hope Valley
    United KingdomBritishFinance Director8474300001
    WOOD, Steven John
    c/o 01/11/2011
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Amministratore
    c/o 01/11/2011
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    United KingdomBritishDirector232132390001

    THE THOMAS FOOD PARTNERSHIP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 21 apr 2008
    Consegnato il 02 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Duke Street Capital General Partner Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 02 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 24 ott 2007
    Consegnato il 31 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Premium of £7,500 deposited and any interest.
    Persone aventi diritto
    • Trw Pensions Trust Limited
    Transazioni
    • 31 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Insurance assignment
    Creato il 03 mar 2006
    Consegnato il 17 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the security agent and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the policies being: insurer scottish equitable, life assured cameron brown, number L0196703472 sum assured £500,000,. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Agent)
    Transazioni
    • 17 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 03 mar 2006
    Consegnato il 17 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Secured Parties)the Security Agent
    Transazioni
    • 17 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 18 nov 2005
    Consegnato il 22 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the book debts and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Islandsbanki Hf as Security Agent for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 22 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 set 2002
    Consegnato il 03 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 1A meadowbrook park sheffield. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 03 nov 1993
    Consegnato il 10 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the chattels as detailed on the form 395 with the benefit of all existing manufacturers & future suppliers contracts located at 15 meadowbrook park meadowbrook industrial park mosborough sheffield south yorkshire. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 giu 1992
    Consegnato il 16 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £150,000 and all other monies due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • British Coal Enterprise Limited
    Transazioni
    • 16 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 mar 1992
    Consegnato il 20 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0