THE THOMAS FOOD PARTNERSHIP LIMITED
Panoramica
Nome della società | THE THOMAS FOOD PARTNERSHIP LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02644839 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THE THOMAS FOOD PARTNERSHIP LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova THE THOMAS FOOD PARTNERSHIP LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 2 The Square Southall Lane UB2 5NH Heathrow England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di THE THOMAS FOOD PARTNERSHIP LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
KT557 LIMITED | 11 set 1991 | 11 set 1991 |
Quali sono gli ultimi bilanci di THE THOMAS FOOD PARTNERSHIP LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 01 ott 2011 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per THE THOMAS FOOD PARTNERSHIP LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per THE THOMAS FOOD PARTNERSHIP LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 set 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Food Partners House Poyle Road Colnbrook Slough SL3 0QX England* in data 10 set 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 2 pagine | AUD | ||||||||||
Varie Section 519 | 2 pagine | MISC | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Thomas come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 11 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * C/O 01/11/2011 Food Partners House Poyle Road Colnbrook Slough SL3 0QX England* in data 08 gen 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2012 al 31 mar 2013 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Steve Wood come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 set 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Gavin Cox il 01 nov 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Thomas il 01 nov 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Steve Wood il 01 nov 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Gavin Cox il 01 nov 2011 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Food Partners House Poyle Road Colnbrook, Slough England SL3 0EN England* in data 13 nov 2012 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 01 ott 2011 | 19 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Mccracken come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Joe Rainert come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Julian Momen come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Julian Momen come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di THE THOMAS FOOD PARTNERSHIP LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COX, Gavin | Segretario | The Square Southall Lane UB2 5NH Heathrow 2 England | 165756680001 | |||||||
COX, Gavin Eliot | Amministratore | The Square Southall Lane UB2 5NH Heathrow 2 England | United Kingdom | British | Director | 153840250001 | ||||
COX, Jacqueline | Segretario | 81 Manchester Road Deepcar S30 5QX Sheffield South Yorkshire | British | 11720990002 | ||||||
MOMEN, Julian Akhtar Karim | Segretario | Tanners Drive MK14 5BN Blakelands 28 Milton Keynes | British | 150501350001 | ||||||
WATSON, David Ian | Segretario | Knoll Farm Aston Hope S33 6RA Hope Valley | British | Finance Director | 8474300001 | |||||
MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Segretario | 66 Queen's Road AB15 4YE Aberdeen | 119967690001 | |||||||
BARNES, Kevin | Amministratore | 11 Heather Lane Ravenstone LE67 2AH Leicestershire | British | Operations Director | 96190510001 | |||||
BROWN, Cameron Matthew | Amministratore | 23 Cunningham Gardens PA6 7GA Houston Renfrewshire | United Kingdom | British | Company Director | 108690220001 | ||||
COX, Jacqueline | Amministratore | 81 Manchester Road Deepcar S30 5QX Sheffield South Yorkshire | British | Legal Executive | 11720990002 | |||||
DEUTSCH, Andrew Simon | Amministratore | 43 Whirlow Park Road S11 9NN Sheffield South Yorkshire | England | British | Managing Director | 99357230001 | ||||
FILDES, Richard | Amministratore | Manley Knoll WA6 9DX Manley Cheshire | United Kingdom | British | Company Director | 94278790001 | ||||
FORD, Martin Francis | Amministratore | 23 Swallow Drive Claypole NG23 5FG Newark Nottinghamshire | England | British | Technical Director | 85713000001 | ||||
FRITH, David Frederick Alfred | Amministratore | White House 21 Whirlow Park Road S11 9NN Sheffield South Yorkshire | British | Financial Consultant | 3549820001 | |||||
HAZELDEAN, James William | Amministratore | 6a Balmoral Court Gleneagles Village PH3 1SH Auchterarder Perthshire | Scotland | British | Company Director | 10359650007 | ||||
HUNTER, Nigel John | Amministratore | Tanners Drive Blakelands MK14 5BN Milton Keynes 28 | United Kingdom | British | Director | 45026040001 | ||||
JEFFREY, Nicholas | Amministratore | Riley Croft Eyam S32 5QZ Hope Valley | England | British | Chief Executive | 15639340001 | ||||
JOHNSTONE, Ian Duncan | Amministratore | 67 Hillside Avenue Bromley Cross BL7 9NQ Bolton Lancashire | British | Production Director | 70923770001 | |||||
MCCARTNEY, William | Amministratore | 4 Holly Grange WA14 2HU Bowdon Cheshire | British | Business Consultant | 33576380001 | |||||
MCCOY, Stephen | Amministratore | 17 Westcroft Lane Hambleton YO8 9JQ Selby North Yorkshire | British | Production Director | 35813550001 | |||||
MCCRACKEN, Ian | Amministratore | Tanners Drive Blakelands MK14 5BN Milton Keynes 28 United Kingdom | England | British | Director | 139503220001 | ||||
MOMEN, Julian Akhtar Karim | Amministratore | Tanners Drive Blakelands MK14 5BN Milton Keynes 28 | England | British | Director | 51784930002 | ||||
POCOCK, Patrick William | Amministratore | The Steadings Woodside Of Cloghill, Kingswells AB15 8SA Aberdeen | British | Company Director | 96978470001 | |||||
RAINERT, Joe Frederick | Amministratore | Tanners Drive Blakelands MK14 5BN Milton Keynes 28 England England | United Kingdom | British | Director | 100745180001 | ||||
RIDLER, Mark Philip | Amministratore | 35 Oakdale Road Netheredge S7 1SL Sheffield South Yorkshire | British | Solicitor | 66732880002 | |||||
ROTHERY, Janet Ann | Amministratore | 9 Leebrook Drive Owlthorpe S20 6QG Sheffield Yorkshire | England | English | Finance Director | 98779140001 | ||||
SHEPHERD, James Gordon | Amministratore | Ridgeways 100 Bawtry Road Bessacarr DN4 7BW Doncaster South Yorkshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 8474280001 | ||||
SIMS, Howard Ronald | Amministratore | Acre Head Longburgh Burgh-By-Sands CA5 6AF Carlisle Cumbria | British | Company Director | 801940002 | |||||
SORSBY, John Mark | Amministratore | 7 Oates Orchard Mosborough S20 5PG Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | Technical Director | 96190400001 | ||||
THOMAS, Christopher | Amministratore | Poyle Road Colnbrook SL3 0QX Slough Food Partners House England | United Kingdom | British | Director | 63844650001 | ||||
THOMAS, Rodney Neil Seagoe | Amministratore | Castle Mount Newcastle Avenue S80 1EY Worksop Nottinghamshire | British | Managing Director | 18102180001 | |||||
THOMAS, Sarah Rosemary | Amministratore | Castle Mount Newcastle Avenue S80 1EY Worksop Nottinghamshire | British | Director | 18102170001 | |||||
TRUELOVE, Amelia Anne | Amministratore | Bentley Hall Fenny Bentley DE6 1LE Ashbourne Derbyshire | British | Director | 37845970003 | |||||
WATSON, David Ian | Amministratore | Knoll Farm Aston Hope S33 6RA Hope Valley | United Kingdom | British | Finance Director | 8474300001 | ||||
WOOD, Steven John | Amministratore | c/o 01/11/2011 Poyle Road Colnbrook SL3 0QX Slough Food Partners House England | United Kingdom | British | Director | 232132390001 |
THE THOMAS FOOD PARTNERSHIP LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 21 apr 2008 Consegnato il 02 mag 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 24 ott 2007 Consegnato il 31 ott 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Premium of £7,500 deposited and any interest. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Insurance assignment | Creato il 03 mar 2006 Consegnato il 17 mar 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any group company to the security agent and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right title and interest in and to the policies being: insurer scottish equitable, life assured cameron brown, number L0196703472 sum assured £500,000,. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 03 mar 2006 Consegnato il 17 mar 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 18 nov 2005 Consegnato il 22 nov 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the book debts and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 27 set 2002 Consegnato il 03 ott 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Unit 1A meadowbrook park sheffield. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattel mortgage | Creato il 03 nov 1993 Consegnato il 10 nov 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All the chattels as detailed on the form 395 with the benefit of all existing manufacturers & future suppliers contracts located at 15 meadowbrook park meadowbrook industrial park mosborough sheffield south yorkshire. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 12 giu 1992 Consegnato il 16 giu 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £150,000 and all other monies due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 18 mar 1992 Consegnato il 20 mar 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0