TOWERGATE MARINE UNDERWRITING LIMITED

TOWERGATE MARINE UNDERWRITING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTOWERGATE MARINE UNDERWRITING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02646688
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TOWERGATE MARINE UNDERWRITING LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova TOWERGATE MARINE UNDERWRITING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Towergate House Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Kent
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TOWERGATE MARINE UNDERWRITING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CARRINGTON INTERNATIONAL UNDERWRITING AGENCIES LIMITED18 set 199118 set 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di TOWERGATE MARINE UNDERWRITING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per TOWERGATE MARINE UNDERWRITING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 11 dic 2012

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Peter Geoffrey Cullum come amministratore in data 29 nov 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 18 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Mr Mark Steven Hodges come amministratore in data 17 set 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Timothy Duncan Philip come amministratore in data 30 giu 2012

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Scott Egan come amministratore in data 19 apr 2012

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 18 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Mr Samuel Thomas Budgen Clark come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Andrew Hunter come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Nomina di Mr Andrew Stewart Hunter come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Darryl Clark come segretario

    1 pagineTM02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 18 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Nomina di Mr Darryl Clark come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Timothy Craton come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di TOWERGATE MARINE UNDERWRITING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    161873320001
    EGAN, Scott
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector170703910001
    HODGES, Mark Steven
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector58444370003
    ALEXANDER, Peter
    4 Pintail Way
    Broomfield
    CT6 7XP Herne Bay
    Kent
    Segretario
    4 Pintail Way
    Broomfield
    CT6 7XP Herne Bay
    Kent
    British60245740001
    CLARK, Darryl
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    153032010001
    CRATON, Timothy Charles
    Downings
    Quarry Close
    RH8 9HG Oxted
    Surrey
    Segretario
    Downings
    Quarry Close
    RH8 9HG Oxted
    Surrey
    BritishSolicitor76055420004
    DYER, Paul Francis
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    Segretario
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    BritishInsurance99424380001
    HARRIS, Anthony Richard Montague
    Freshfield Barnes Lane
    Milford On Sea
    SO41 0RR Lymington
    Hampshire
    Segretario
    Freshfield Barnes Lane
    Milford On Sea
    SO41 0RR Lymington
    Hampshire
    British10316640002
    HUNTER, Andrew Stewart
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Eclipse Park,
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    156607780001
    REDDI, John
    Farbank 21 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    Segretario
    Farbank 21 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    BritishSolicitor6180280001
    CARDUS, Martin John
    22 Denham Drive
    Highcliffe
    BH23 5AT Christchurch
    Dorset
    Amministratore
    22 Denham Drive
    Highcliffe
    BH23 5AT Christchurch
    Dorset
    EnglandBritishInsurance64951780001
    CLEMENTS, Peter
    High Acre 70 Firs Road
    West Mersea
    CO5 8NL Colchester
    Essex
    Amministratore
    High Acre 70 Firs Road
    West Mersea
    CO5 8NL Colchester
    Essex
    EnglandBritishInsurance Broker68235730001
    CROCKER, Nicholas John David
    The Barn
    Little Biddenden Green Lewd Lane
    TN27 8NP Smarden
    Kent
    Amministratore
    The Barn
    Little Biddenden Green Lewd Lane
    TN27 8NP Smarden
    Kent
    BritishInsurance60697560014
    CULLUM, Peter Geoffrey
    Wealden Hall
    Parkfield
    TN15 0HX Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Wealden Hall
    Parkfield
    TN15 0HX Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishInsurance59873490009
    DODD, Jeffery Andrew
    Sarum
    May Avenue
    SO41 9DQ Lymington
    Hampshire
    Amministratore
    Sarum
    May Avenue
    SO41 9DQ Lymington
    Hampshire
    BritishUnderwriter46213330002
    DODD, John Leslie
    2 Hollywood Court
    Hollywood Lane
    SO41 9HD Lymington
    Hampshire
    England
    Amministratore
    2 Hollywood Court
    Hollywood Lane
    SO41 9HD Lymington
    Hampshire
    England
    BritishInsurance Broker57603650001
    DYER, Paul Francis
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    Amministratore
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    EnglandBritishInsurance99424380001
    HARRIS, Anthony Richard Montague
    Freshfield Barnes Lane
    Milford On Sea
    SO41 0RR Lymington
    Hampshire
    Amministratore
    Freshfield Barnes Lane
    Milford On Sea
    SO41 0RR Lymington
    Hampshire
    United KingdomBritishInsurance Broker10316640002
    PHILIP, Timothy Duncan
    20 The Old Saw Mill
    Long Mill Lane Platt
    TN15 8QJ Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    20 The Old Saw Mill
    Long Mill Lane Platt
    TN15 8QJ Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishAccountant99066410001
    PROVERBS, Antony
    27 Capital Wharf
    50 Wapping High Street
    E1W 1LY London
    Amministratore
    27 Capital Wharf
    50 Wapping High Street
    E1W 1LY London
    EnglandBritishInsurance79185700012
    SELBIE, Ian Robertson
    10 The Hill Avenue
    WR5 2AW Worcester
    Amministratore
    10 The Hill Avenue
    WR5 2AW Worcester
    BritishDirector37249880002

    TOWERGATE MARINE UNDERWRITING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 31 ago 2001
    Consegnato il 13 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the chargee (the agent), the lender, the mezzanine lender, the overdraft bank, the hedging bank, the zero per cent lenders, the investors and to any of them on any account whatsoever including without limitation under any of the financing documents (all terms as defined)
    Brevi particolari
    (Other than f/h property k/a 317 woodham lane new haw t/no.SY350608 and the f/h land at the south west of scotland bridge road new haw t/no.SY536467 in each case so long as the same is charged by towergate chase parkinson limited to coutts & co). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 31 mar 2000
    Consegnato il 07 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Agent and Trustee for Itself and for Each of the Lender, the Mezzanine Lender, the Overdraft Bank, the Hedging Bank and the Investor (All as Defined)
    Transazioni
    • 07 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee and debenture
    Creato il 18 dic 1998
    Consegnato il 06 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Mezzanine Limited,as Agent and Trustee for Itself and for Each of the Lender,the Overdraftbank,the Hedging Bank and the Investors (All Asdefined)
    Transazioni
    • 06 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Single debenture
    Creato il 25 giu 1993
    Consegnato il 07 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0