NEWS DATACOM LIMITED

NEWS DATACOM LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNEWS DATACOM LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02646785
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NEWS DATACOM LIMITED?

    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova NEWS DATACOM LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Callaghan Square
    CF10 5BT Cardiff
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NEWS DATACOM LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TYROLESE (236) LIMITED18 set 199118 set 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di NEWS DATACOM LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al27 lug 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per NEWS DATACOM LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Evan Barry Sloves il 27 nov 2019

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 27 lug 2019

    5 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2018

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da One London Road Staines Middlesex TW18 4EX a 1 Callaghan Square Cardiff CF10 5BT in data 11 ott 2018

    1 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 31 ago 2018

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Nomina di Evan Sloves come amministratore in data 28 giu 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ismat Levin come amministratore in data 09 giu 2018

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 lug 2017

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 30 lug 2016

    5 pagineAA

    Nomina di Mr Sajaid Rashid come amministratore in data 16 mar 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David James Sweet come amministratore in data 16 mar 2017

    2 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 25 lug 2015

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di NEWS DATACOM LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RASHID, Sajaid
    New Square
    Bedfont Lakes
    TW14 8HA Feltham
    9
    Middlesex
    England
    Amministratore
    New Square
    Bedfont Lakes
    TW14 8HA Feltham
    9
    Middlesex
    England
    EnglandBritish227062400001
    SLOVES, Evan Barry
    East Tasman Drive
    95134 San Jose
    300
    United States
    Amministratore
    East Tasman Drive
    95134 San Jose
    300
    United States
    United StatesAmerican99784540002
    MEDLOCK, Charles Richard Kenneth
    1 Blackwater View
    Lower Sandhurst Road Finchampstead
    RG40 3TF Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    1 Blackwater View
    Lower Sandhurst Road Finchampstead
    RG40 3TF Wokingham
    Berkshire
    British23450040004
    ROGERS, Eleanor
    393 London Road
    CR4 4BF Mitcham
    Surrey
    Segretario
    393 London Road
    CR4 4BF Mitcham
    Surrey
    British141000001
    STEHRENBERGER, Peter Walter
    The Knapp
    Oak Way
    RH2 7ES Reigate
    Surrey
    Segretario
    The Knapp
    Oak Way
    RH2 7ES Reigate
    Surrey
    Swiss415350001
    WOODWARD, Andrew Paul
    London Road
    TW18 4EX Staines
    One
    Middlesex
    Segretario
    London Road
    TW18 4EX Staines
    One
    Middlesex
    British100885620001
    BARDEN-STYLIANOU, Stelios Stephen
    47 Carlyle Court
    Chelsea Harbour
    SW10 0UQ London
    Amministratore
    47 Carlyle Court
    Chelsea Harbour
    SW10 0UQ London
    EnglandBritish125782940001
    BARRACLOUGH, Stephen Thomas
    Flat 1 Brasenose House
    35 Kensington High Street
    W8 5EB London
    Amministratore
    Flat 1 Brasenose House
    35 Kensington High Street
    W8 5EB London
    British32978040002
    BROWN, Steven John
    7 Broadwater Lane
    Aston
    SG2 7EN Stevenage
    Hertfordshire
    Amministratore
    7 Broadwater Lane
    Aston
    SG2 7EN Stevenage
    Hertfordshire
    EnglandBritish3379480001
    CHISHOLM, Samuel Hewlings
    Flat 7 21 Hyde Park Square
    W2 London
    Amministratore
    Flat 7 21 Hyde Park Square
    W2 London
    New Zealander14185520001
    CLARK, Greogory John, Dr
    2142 Century Park Lane
    CA 90067 Los Angeles
    California
    America
    Amministratore
    2142 Century Park Lane
    CA 90067 Los Angeles
    California
    America
    American45010780001
    FISCHER, August Antonius
    58 Egerton Crescent
    SW3 2ED London
    Amministratore
    58 Egerton Crescent
    SW3 2ED London
    Swiss40347940002
    GERSH, Alexander
    London Road
    TW18 4EX Staines
    One
    Middlesex
    Amministratore
    London Road
    TW18 4EX Staines
    One
    Middlesex
    United KingdomBritish174100540001
    HONEY, Stanley Kohnen
    827 Lytton Street
    Palo Alto
    Ca 94301
    America
    Amministratore
    827 Lytton Street
    Palo Alto
    Ca 94301
    America
    American32567760001
    LEVIN, Ismat
    London Road
    TW18 4EX Staines
    One
    Middlesex
    Amministratore
    London Road
    TW18 4EX Staines
    One
    Middlesex
    United KingdomBritish83241580001
    LINFORD, Richard Martin
    Four Beeches
    Beech Close
    KT11 2EN Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Four Beeches
    Beech Close
    KT11 2EN Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish77209960001
    MEDLOCK, Charles Richard Kenneth
    1 Blackwater View
    Lower Sandhurst Road Finchampstead
    RG40 3TF Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    1 Blackwater View
    Lower Sandhurst Road Finchampstead
    RG40 3TF Wokingham
    Berkshire
    British23450040004
    NIELSEN, Gorm Ward
    London Road
    TW18 4EX Staines
    One
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    London Road
    TW18 4EX Staines
    One
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritish169694340001
    PELED, Abraham, Dr
    28 Wynnstay Gardens
    W8 London
    Amministratore
    28 Wynnstay Gardens
    W8 London
    United States44312940003
    PRICE, Thomas George
    The Cottage 25 North Park
    SL9 8JS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Cottage 25 North Park
    SL9 8JS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British22878750001
    SISKIND, Arthur Michael
    2 Vine Place
    Westchester County
    NY10538 Larchmont
    Usa
    Amministratore
    2 Vine Place
    Westchester County
    NY10538 Larchmont
    Usa
    American49338320001
    SMITH, Peter Wade
    Harwood Mount Spring Lane
    SL6 6PW Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Harwood Mount Spring Lane
    SL6 6PW Maidenhead
    Berkshire
    Australian36065300002
    SWEET, David James
    New Square
    Bedfont Lakes
    TW14 8HA Feltham
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    New Square
    Bedfont Lakes
    TW14 8HA Feltham
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritish161536210001
    WOODWARD, Andrew Paul
    London Road
    TW18 4EX Staines
    One
    Middlesex
    Amministratore
    London Road
    TW18 4EX Staines
    One
    Middlesex
    United KingdomBritish100885620001

    Chi sono le persone con controllo significativo di NEWS DATACOM LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    London Road
    TW18 4EX Staines
    One
    Middlesex
    United Kingdom
    06 apr 2016
    London Road
    TW18 4EX Staines
    One
    Middlesex
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03173930
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    NEWS DATACOM LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Intellectual property security agreement
    Creato il 10 mar 2011
    Consegnato il 18 mar 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers and the other loan parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Right title and interest in all copyrights and copyright licenses, all patents and patent licenses, all trademarks and trademark licenses and all trade secrets and trade secret licenses see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited
    Transazioni
    • 18 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 10 mar 2011
    Consegnato il 18 mar 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers and the other loan parties to any counterparty that is a secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited
    Transazioni
    • 18 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Intellectual property security agreement
    Creato il 28 apr 2009
    Consegnato il 06 mag 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obigor to any priority secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right, title and interest in, to and under all copyrights, all patents and all trademarks see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited as Security Agent for the Secured Parties
    Transazioni
    • 06 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 06 feb 2009
    Consegnato il 09 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nds Holdco, Inc.
    Transazioni
    • 09 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 28 gen 2009
    Consegnato il 30 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • J P Morgan Europe Limited as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 30 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0