QUONDAM ESTATES LIMITED

QUONDAM ESTATES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàQUONDAM ESTATES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02649214
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di QUONDAM ESTATES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova QUONDAM ESTATES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    180 Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di QUONDAM ESTATES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FISCAL ESTATES LIMITED14 ott 199114 ott 1991
    PALMHILL LIMITED26 set 199126 set 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di QUONDAM ESTATES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per QUONDAM ESTATES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 026492140010 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 026492140011 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 set 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017

    15 pagineAA

    Stato del capitale al 15 feb 2018

    • Capitale: GBP 100
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Modifica dei dettagli di Quondam Properties Limited come persona con controllo significativo il 01 dic 2017

    2 paginePSC05

    Dettagli del direttore cambiati per Mr. James Michael Edward Saunders il 01 dic 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr. Angus Alexander Dodd il 01 dic 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Frances Victoria Heazell il 01 dic 2017

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr. Michael Ben Jenkins il 01 dic 2017

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 43-45 Portman Square London W1H 6LY a 180 Great Portland Street London W1W 5QZ in data 03 dic 2017

    1 pagineAD01

    Iscrizione dell'ipoteca 026492140011, creata il 03 nov 2017

    134 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 set 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2016

    16 pagineAA

    Nomina di Mr Michael Ben Jenkins come amministratore in data 17 mar 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Frances Victoria Heazell come segretario in data 17 mar 2017

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Angus Alexander Dodd come amministratore in data 17 mar 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr James Michael Edward Saunders come amministratore in data 17 mar 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Daniel Mark Greenslade come amministratore in data 17 mar 2017

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di QUONDAM ESTATES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HEAZELL, Frances Victoria
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Segretario
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    228312140001
    DODD, Angus Alexander
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritish201606390001
    JENKINS, Michael Ben
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    United KingdomBritish221017630001
    SAUNDERS, James Michael Edward
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritish192568400002
    DIXON, Susan Elizabeth
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    Segretario
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    British90007990001
    EASTWOOD, Charlotte Ind
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    Segretario
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    British50099790003
    GODDARD, Terence Philip
    St Annes Grange
    MK17 0BH Newton Longville
    Bucks
    Segretario
    St Annes Grange
    MK17 0BH Newton Longville
    Bucks
    British15955560001
    HUGHES, Paul
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    Segretario
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    British23950030001
    ODELL, Sandra Judith
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Segretario
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    175341180001
    RICE, Sarah Jane
    12 Rangers Square
    Greenwich
    SE10 8HR London
    Segretario
    12 Rangers Square
    Greenwich
    SE10 8HR London
    British72584080001
    ROBSON SKEETE, Gail
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    Segretario
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    British66939460001
    SHATTOCK, Nicholas Simon Keith
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    Segretario
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    British43632680001
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Segretario
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    British130493170001
    ARNOLD, Robin David Clement
    Adam & Eve Mews
    W8 6UG London
    13a
    Amministratore
    Adam & Eve Mews
    W8 6UG London
    13a
    United KingdomBritish136590160001
    BLAXLAND, Richard Bryan
    Gleamingwood
    10 Walderslade Road
    ME4 6NX Chatham
    Kent
    Amministratore
    Gleamingwood
    10 Walderslade Road
    ME4 6NX Chatham
    Kent
    EnglandBritish9530670001
    BLOOR, Gordon
    Rowas Lodge
    Limpley Stoke
    BA3 6HD Bath
    Amministratore
    Rowas Lodge
    Limpley Stoke
    BA3 6HD Bath
    British38998390001
    DUGDALE, Edward Stratford
    190 Avenue Road
    W3 8QQ London
    Amministratore
    190 Avenue Road
    W3 8QQ London
    British35942980001
    DWYER, Tonianne
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    Amministratore
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    United KingdomAustralian94124780001
    ELLIS, Nigel George
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    British14185110002
    GAVAGHAN, David Nicholas
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    Amministratore
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    United KingdomBritish151855940001
    GODDARD, Terence Philip
    St Annes Grange
    MK17 0BH Newton Longville
    Bucks
    Amministratore
    St Annes Grange
    MK17 0BH Newton Longville
    Bucks
    EnglandBritish15955560001
    GREENSLADE, Daniel Mark
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritish196504990001
    GREENSLADE, Daniel Mark
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritish196504990001
    HAMILTON STUBBER, James Robert
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    Amministratore
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    United KingdomBritish84913850002
    HARE, Alexander Edward Compton
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish215786330001
    HUGHES, Paul
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    British23950030001
    JAMES, Maxwell David Shaw
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish164108510001
    MACKANESS, Alexandra Antonia
    156 Campden Hill Road
    W8 7AS London
    Amministratore
    156 Campden Hill Road
    W8 7AS London
    British39096000001
    MASTERSON, Christopher Mary
    19 Tower Road
    TW14 4PD Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    19 Tower Road
    TW14 4PD Twickenham
    Middlesex
    British35526310001
    ODELL, Sandra Judith
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish132142980001
    RASPIN, Grahame Anthony
    14 Albany Crescent
    Claygate
    KT10 0PF Surrey
    Amministratore
    14 Albany Crescent
    Claygate
    KT10 0PF Surrey
    EnglandBritish93295910001
    RILEY, Michael Edward
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    Amministratore
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    British94724020002
    SHATTOCK, Nicholas Simon Keith
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    Amministratore
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    EnglandBritish43632680001
    STEARN, Richard James
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish94050800002
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Amministratore
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    EnglandBritish130493170001

    Chi sono le persone con controllo significativo di QUONDAM ESTATES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Quondam Properties Limited
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione2891409
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    QUONDAM ESTATES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 03 nov 2017
    Consegnato il 09 nov 2017
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Homes and Communities Agency
    Transazioni
    • 09 nov 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 03 nov 2016
    Consegnato il 16 nov 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch, 90 Long Acre, London, WC2E 9RA (As Common Security Agent for Each of the Secured Parties)
    Transazioni
    • 16 nov 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge security agreement
    Creato il 14 mar 2008
    Consegnato il 17 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First floating charge all its assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 17 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security agreement
    Creato il 04 feb 2008
    Consegnato il 15 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise ffectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 15 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 29 gen 2008
    Consegnato il 01 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Capital as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 01 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A security agreement
    Creato il 29 gen 2008
    Consegnato il 07 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise effectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 07 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 22 ott 2007
    Consegnato il 25 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company assigns all of its rights under any hedging arrangements; a first floating charge all its assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 25 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 26 ott 2005
    Consegnato il 11 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of a first floating charge all its assets not at any time othererwise effectively mortgages charged of assigned. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 26 ott 2005
    Consegnato il 11 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of a first floating charge all its assets not at any time othererwise effectively mortgages charged of assigned. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 nov 1993
    Consegnato il 20 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The various properties as described on form 395 see doc for full details M239C. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 20 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security trust deed
    Creato il 21 ott 1991
    Consegnato il 08 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan stock instrument dated 21 october 1991
    Brevi particolari
    Floating charge over the company's undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever both present and future,including any uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Montagu Ventures Limited
    Transazioni
    • 08 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0