JUNIPER (NO. 7) LIMITED

JUNIPER (NO. 7) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJUNIPER (NO. 7) LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02649336
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JUNIPER (NO. 7) LIMITED?

    • Estrazione a cielo aperto di carbone (05102) / Attività estrattive

    Dove si trova JUNIPER (NO. 7) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Bdo Llp
    Central Square
    LS1 4DL 29 Wellington Street
    Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JUNIPER (NO. 7) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MINING SERVICES LTD25 mag 200125 mag 2001
    RJB MINING SERVICES LTD01 mar 199901 mar 1999
    R.J. BUDGE (PLANT) LIMITED10 dic 199110 dic 1991
    ELKINFIELD LIMITED27 set 199127 set 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di JUNIPER (NO. 7) LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2012
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2013
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per JUNIPER (NO. 7) LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al15 ago 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma29 ago 2016
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per JUNIPER (NO. 7) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per JUNIPER (NO. 7) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale - precedentemente in liquidazione volontaria dei creditori

    3 pagineREST-CVL

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    21 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 ott 2017

    20 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds LS11 5RU a C/O Bdo Llp Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL in data 19 apr 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 ott 2016

    14 pagine4.68

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:s/s cert. Release of liquidator
    1 pagineLIQ MISC

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:c/o replacement of liquidator
    9 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 ott 2015

    25 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 ott 2014

    21 pagine4.68

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 ott 2013

    11 pagine2.24B

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Risultato della riunione dei creditori

    3 pagine2.23B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    62 pagine2.17B

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed mining services LTD\certificate issued on 12/08/13
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name12 ago 2013

    Risoluzione di cambio di nome della società il 28 lug 2013

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    17 pagine2.16B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Indirizzo della sede legale modificato da , Harworth Park, Blythe Road, Harworth,Doncaster, South Yorkshire.DN11 8DB in data 17 lug 2013

    2 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    11 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di JUNIPER (NO. 7) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PURVIS, Martin Terence Alan
    Central Square
    LS1 4DL 29 Wellington Street
    C/O Bdo Llp
    Leeds
    Segretario
    Central Square
    LS1 4DL 29 Wellington Street
    C/O Bdo Llp
    Leeds
    177797550001
    PARKIN, Derek
    Central Square
    LS1 4DL 29 Wellington Street
    C/O Bdo Llp
    Leeds
    Amministratore
    Central Square
    LS1 4DL 29 Wellington Street
    C/O Bdo Llp
    Leeds
    EnglandBritish177788390001
    REED, Colin Frederick
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    England
    Amministratore
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritish174641750001
    COLE, Richard Andrew
    Lodge Farm
    Eakring Road, Wellow
    NG22 0EG Newark
    Nottinghamshire
    Segretario
    Lodge Farm
    Eakring Road, Wellow
    NG22 0EG Newark
    Nottinghamshire
    British58361870002
    GARNESS, Melvin
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    Segretario
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    British18761260001
    RHODES, Jeremy
    Harworth Park
    Blythe Road
    Harworth,Doncaster
    South Yorkshire.Dn11 8db
    Segretario
    Harworth Park
    Blythe Road
    Harworth,Doncaster
    South Yorkshire.Dn11 8db
    British169993380001
    HARWORTH SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione8223049
    172322000002
    BROCKSOM, David Graham
    7 York Road
    HG1 2QA Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    7 York Road
    HG1 2QA Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish96416100003
    BUDGE, Richard John
    Wiseton Hall
    Wiseton
    DN10 5AE Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Wiseton Hall
    Wiseton
    DN10 5AE Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritish27948060002
    COLE, Richard Andrew
    Eakring Road
    Wellow
    NG22 0EG Newark
    Lodge Farm
    Amministratore
    Eakring Road
    Wellow
    NG22 0EG Newark
    Lodge Farm
    EnglandBritish58361870002
    GARNESS, Melvin
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish18761260001
    JARRETT, George William
    Wenvoe 51 Woodhill Road
    Collingham
    NG23 7NR Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Wenvoe 51 Woodhill Road
    Collingham
    NG23 7NR Newark
    Nottinghamshire
    British30751750001
    JARRETT, Keith
    8 High Hoe Court
    S80 2PJ Worksop
    Nottinghamshire
    Amministratore
    8 High Hoe Court
    S80 2PJ Worksop
    Nottinghamshire
    British30858770001
    LLOYD, Jonathan Simon
    Orchard House
    Marton Cum Grafton
    YO51 9QY York
    Amministratore
    Orchard House
    Marton Cum Grafton
    YO51 9QY York
    United KingdomBritish95211330002
    MAWE, Christopher
    5 Back Lane
    Whixley
    YO26 8BG York
    North Yorkshire
    Amministratore
    5 Back Lane
    Whixley
    YO26 8BG York
    North Yorkshire
    British99084660001
    MCPHIE, Gordon Allister
    Wigley Green Farmhouse
    S42 7JJ Old Brampton
    Derbyshire
    Amministratore
    Wigley Green Farmhouse
    S42 7JJ Old Brampton
    Derbyshire
    British35904020001
    RHODES, Jeremy
    Harworth Park
    Blythe Road
    Harworth,Doncaster
    South Yorkshire.Dn11 8db
    Amministratore
    Harworth Park
    Blythe Road
    Harworth,Doncaster
    South Yorkshire.Dn11 8db
    United KingdomBritish170032420001
    SPINDLER, Garold Ralph
    Manor House
    Westhaugh Tumbling Hill Carleton
    WF8 2RP Pontefract
    Amministratore
    Manor House
    Westhaugh Tumbling Hill Carleton
    WF8 2RP Pontefract
    American101195530002
    TAYLOR, Simon Gareth
    Harworth Park
    Blythe Road
    Harworth,Doncaster
    South Yorkshire.Dn11 8db
    Amministratore
    Harworth Park
    Blythe Road
    Harworth,Doncaster
    South Yorkshire.Dn11 8db
    United KingdomBritish160685730001
    TINSLEY, William Joseph
    23 Maypole Gardens
    Cawood
    YO8 3TG Selby
    North Yorkshire
    Amministratore
    23 Maypole Gardens
    Cawood
    YO8 3TG Selby
    North Yorkshire
    EnglandEnglish114170770001
    WALTON, Colin Arthur
    Acre House Main Street
    Hougham
    Grantham
    Lincolnshire
    Amministratore
    Acre House Main Street
    Hougham
    Grantham
    Lincolnshire
    British30858780001

    JUNIPER (NO. 7) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 19 apr 2013
    Consegnato il 20 apr 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Harworth Estates Mines Property Limited
    Transazioni
    • 20 apr 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Deed of accession
    Creato il 26 apr 2012
    Consegnato il 03 mag 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the further company and the existing companies or any of them to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Its credit balances. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattel mortgage
    Creato il 09 lug 2009
    Consegnato il 10 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Caterpillar model 16H grader s/n 6ZJ00971. Caterpillar model 16H grader s/n 6ZJ00984. Caterpillar model 16H grader s/n 6ZJ00985 (for details of further chattels charged please refer to form 395) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Leasing (UK) LTD
    Transazioni
    • 10 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment and charge of sub-leasing agreements
    Creato il 30 ago 2006
    Consegnato il 02 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights title and interest in sub leases in respect of goods comprised in hp leasing or hire agreements made or to be made between the chargee and the company together with the benefit of all collateral agreements guarantees indemnities negotiable instruments securities and insurance policies in connection with the agreements.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 30 ago 2006
    Consegnato il 02 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £8,947,500.00 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    P0826 cat 789 dumptruck s/no 9ZC 118 date acquired 14.12.87 1987, P0827 cat 789 dumptruck s/no 9ZC 124 date acquired 14.12.87 1987, P0876 cat 789 dumptruck s/no 9ZC 160 date acquired 14.12.87 1987. for details of further goods charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 06 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 23/06/1999 and
    Creato il 01 mar 2006
    Consegnato il 14 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 09 mar 2004
    Consegnato il 25 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all moneys standing to the credit of any account of the company all benefits due or arising to the company in respect of any and all contracts and policies of insurance taken out by or on behalf of the company or in which the company has an interest all of the companys book trade and other debts the companys goodwill by way of floating charge all of the companys assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 25 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 mar 2004
    Consegnato il 17 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of any chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all moneysstanding to the credit of any account, all benefits in respect of the insurances, all of the chargors' book, trade and other debts, all of the chargors' stock and inventory their goodwill and the bene. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Udt Leasing Limited
    Transazioni
    • 17 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 ott 1999
    Consegnato il 19 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever to any finance party under each finance document to which that chargor is a party except for any obligation which if it were so included would result in this deed contravening section 151 of the companies act 1985 and to the ancillary bank under the ancillary facility in any capacity whatsoever
    Brevi particolari
    All moneys standing to the credit of any account all benefits in respect of the insurances all book trade and other debts all stocks and inventory the goodwill and the benefit of all authorisations.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of Nova Scotia (As Agent)
    Transazioni
    • 19 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 dic 1994
    Consegnato il 11 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the finance documents (as defined in the debenture) or any of them
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chemical Investment Bank Limited (The "Security Trustee")as Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 11 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 ago 1994
    Consegnato il 18 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 dic 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 dic 1993
    Consegnato il 05 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 dic 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 22 feb 1992
    Consegnato il 13 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the facilities agreement and/or the working capital facility letter and this deed
    Brevi particolari
    See doc ref M411C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland("the Overdraft Bank")
    Transazioni
    • 13 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 22 feb 1992
    Consegnato il 13 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the facilities agreement,the secured documents and this deed
    Brevi particolari
    See doc ref M420C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland(As Agent and Trustee for the Banks Under or Pursuant to the Facilities Agreement (as Defined)("the Agent")
    Transazioni
    • 13 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    JUNIPER (NO. 7) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 ott 2013Fine dell'amministrazione
    09 lug 2013Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Francis Graham Newton
    Bdo Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5RU Water Lane
    Leeds
    Praticante
    Bdo Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5RU Water Lane
    Leeds
    2
    DataTipo
    15 apr 2019Data di scioglimento
    22 ott 2013Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul Bates
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Francis Graham Newton
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Edward Terence Kerr
    Pannell House 159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Leicestershire
    Praticante
    Pannell House 159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Leicestershire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0