HARWORTH PLANT & EQUIPMENT LTD

HARWORTH PLANT & EQUIPMENT LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHARWORTH PLANT & EQUIPMENT LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02649344
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HARWORTH PLANT & EQUIPMENT LTD?

    • Estrazione a cielo aperto di carbone (05102) / Attività estrattive

    Dove si trova HARWORTH PLANT & EQUIPMENT LTD?

    Indirizzo della sede legale
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HARWORTH PLANT & EQUIPMENT LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    R.J. BUDGE (PLANT AND EQUIPMENT) LIMITED10 dic 199110 dic 1991
    ELKINDOWN LIMITED27 set 199127 set 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di HARWORTH PLANT & EQUIPMENT LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per HARWORTH PLANT & EQUIPMENT LTD?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per HARWORTH PLANT & EQUIPMENT LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    13 pagine4.72

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    7 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da * Harworth Park Blyth Road Harworth,Doncaster South Yorkshire.DN11 8DB* in data 18 lug 2013

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 27 in pieno

    4 pagineMR04

    Nomina di Derek Parkin come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Harworth Secretariat Services Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Martin Terence Alan Purvis come segretario

    1 pagineAP03

    Dettagli del segretario cambiati per Uk Coal Secretariat Services Limited il 17 apr 2013

    1 pagineCH04

    Cessazione della carica di Simon Taylor come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    3 pagineMG02

    Nomina di Colin Frederick Reed come amministratore

    3 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Simon Gareth Taylor il 12 dic 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Simon Gareth Taylor il 12 dic 2012

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di David Brocksom come amministratore

    2 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    28 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Nomina di Uk Coal Secretariat Services Limited come segretario

    2 pagineAP04

    Nomina di Simon Gareth Taylor come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jeremy Rhodes come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jeremy Rhodes come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 15 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 set 2012

    Stato del capitale al 24 set 2012

    • Capitale: GBP 100,002
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    29 pagineAA

    Nomina di Jeremy Rhodes come amministratore

    3 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di HARWORTH PLANT & EQUIPMENT LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PURVIS, Martin Terence Alan
    Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    1 Bridgewater Place
    Segretario
    Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    1 Bridgewater Place
    177796070001
    PARKIN, Derek
    Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    1 Bridgewater Place
    Amministratore
    Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    1 Bridgewater Place
    EnglandBritishDirector177788390001
    REED, Colin Frederick
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    England
    Amministratore
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritishNone174641750001
    COLE, Richard Andrew
    Lodge Farm
    Eakring Road, Wellow
    NG22 0EG Newark
    Nottinghamshire
    Segretario
    Lodge Farm
    Eakring Road, Wellow
    NG22 0EG Newark
    Nottinghamshire
    British58361870002
    GARNESS, Melvin
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    Segretario
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    British18761260001
    RHODES, Jeremy
    Harworth Park
    Blyth Road
    Harworth,Doncaster
    South Yorkshire.Dn11 8db
    Segretario
    Harworth Park
    Blyth Road
    Harworth,Doncaster
    South Yorkshire.Dn11 8db
    British169993470001
    HARWORTH SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione8223049
    172322000002
    BROCKSOM, David Graham
    7 York Road
    HG1 2QA Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    7 York Road
    HG1 2QA Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant96416100003
    BUDGE, Richard John
    Wiseton Hall
    Wiseton
    DN10 5AE Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Wiseton Hall
    Wiseton
    DN10 5AE Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director27948060002
    COLE, Richard Andrew
    Eakring Road
    Wellow
    NG22 0EG Newark
    Lodge Farm
    Amministratore
    Eakring Road
    Wellow
    NG22 0EG Newark
    Lodge Farm
    EnglandBritishCompany Secretary58361870002
    GARNESS, Melvin
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director18761260001
    JARRETT, George William
    Wenvoe 51 Woodhill Road
    Collingham
    NG23 7NR Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Wenvoe 51 Woodhill Road
    Collingham
    NG23 7NR Newark
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director30751750001
    LLOYD, Jonathan Simon
    Orchard House
    Marton Cum Grafton
    YO51 9QY York
    Amministratore
    Orchard House
    Marton Cum Grafton
    YO51 9QY York
    United KingdomBritishChartered Surveyor95211330002
    MAWE, Christopher
    5 Back Lane
    Whixley
    YO26 8BG York
    North Yorkshire
    Amministratore
    5 Back Lane
    Whixley
    YO26 8BG York
    North Yorkshire
    BritishFinance Director99084660001
    MCPHIE, Gordon Allister
    Wigley Green Farmhouse
    S42 7JJ Old Brampton
    Derbyshire
    Amministratore
    Wigley Green Farmhouse
    S42 7JJ Old Brampton
    Derbyshire
    BritishCompany Director35904020001
    RHODES, Jeremy
    Harworth Park
    Blyth Road
    Harworth,Doncaster
    South Yorkshire.Dn11 8db
    Amministratore
    Harworth Park
    Blyth Road
    Harworth,Doncaster
    South Yorkshire.Dn11 8db
    United KingdomBritishCompany Director170032420001
    SPINDLER, Garold Ralph
    Manor House
    Westhaugh Tumbling Hill Carleton
    WF8 2RP Pontefract
    Amministratore
    Manor House
    Westhaugh Tumbling Hill Carleton
    WF8 2RP Pontefract
    AmericanMining Engineer101195530002
    TAYLOR, Simon Gareth
    Harworth Park
    Blyth Road
    Harworth,Doncaster
    South Yorkshire.Dn11 8db
    Amministratore
    Harworth Park
    Blyth Road
    Harworth,Doncaster
    South Yorkshire.Dn11 8db
    United KingdomBritishDirector160685730001

    HARWORTH PLANT & EQUIPMENT LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of accession
    Creato il 26 apr 2012
    Consegnato il 03 mag 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the further company and the existing companies or any of them to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Its credit balances. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 23/06/1999 and
    Creato il 01 mar 2006
    Consegnato il 14 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 09 mar 2004
    Consegnato il 25 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all moneys standing to the credit of any account of the company all benefits due or arising to the company in respect of any and all contracts and policies of insurance taken out by or on behalf of the company or in which the company has an interest all of the companys book trade and other debts the companys goodwill by way of floating charge all of the companys assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 25 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 mar 2004
    Consegnato il 17 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of any chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all moneysstanding to the credit of any account, all benefits in respect of the insurances, all of the chargors' book, trade and other debts, all of the chargors' stock and inventory their goodwill and the bene. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Udt Leasing Limited
    Transazioni
    • 17 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 ott 1999
    Consegnato il 19 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever to any finance party under each finance document to which that chargor is a party except for any obligation which if it were so included would result in this deed contravening section 151 of the companies act 1985 and to the ancillary bank under the ancillary facility in any capacity whatsoever
    Brevi particolari
    All moneys standing to the credit of any account all benefits in respect of the insurances all book trade and other debts all stocks and inventory the goodwill and the benefit of all authorisations.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of Nova Scotia (As Agent)
    Transazioni
    • 19 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 dic 1994
    Consegnato il 11 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the finance documents (as defined in the debenture) or any of them
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chemical Investment Bank Limited (The "Security Trustee")as Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 11 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 ago 1994
    Consegnato il 18 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 dic 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 dic 1993
    Consegnato il 05 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 dic 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 05 feb 1993
    Consegnato il 10 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to each of the lease purchase agreements for full details see form 395.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Agent
    Transazioni
    • 10 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 21 ott 1992
    Consegnato il 28 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the banks under the facilites agreement dated 22/2/92
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to each of the hire purchase agreements.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 21 set 1992
    Consegnato il 30 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facilities agreement dated 22/2/92
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to each of the lease purchase agreementsfor full details see form 395.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 07 set 1992
    Consegnato il 10 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the banks under the terms of the facilitis agreement dated 22/2/92
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to each of the hire purchase agreements for full details see form 395.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment by way of security
    Creato il 10 ago 1992
    Consegnato il 18 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the banks under the terms of the facilities agreement and any of the hedging arrangements
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to each of the hire purchase agreements for full details see form 395.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 23 lug 1992
    Consegnato il 31 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of teh facilities agreement (as defined therein)
    Brevi particolari
    All right title and interest in the lease agreements.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Banks as Defined Therein
    Transazioni
    • 31 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 01 lug 1992
    Consegnato il 04 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and the facilities agreement on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to each of the hp agreements for full details see form 395.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 31 mar 1992
    Consegnato il 11 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the banks as defined therein under the terms of the charge,the facilities agreement and the hedging arrangements
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to each of the hp agreements for full details see form 395.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 feb 1992
    Consegnato il 13 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or R.J. budge (holdings) limited to the chargee under the counter indemnity as defined in and under the "deed"
    Brevi particolari
    See doc ref M90 for full details of the property. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • A.F. Budge Limited("the Guarantor")
    Transazioni
    • 13 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 22 feb 1992
    Consegnato il 13 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the facilities agreement and/or theworking capital facility letter and this deed
    Brevi particolari
    See doc ref M410C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland("the Overdraft Bank")
    Transazioni
    • 13 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 22 feb 1992
    Consegnato il 13 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the facilities agreement,the secured documents and this deed
    Brevi particolari
    See doc ref M422C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland(As Agent and Trustee for the Banks Under or Pursuant to the Facilities Agreement (as Defined)("the Agent")
    Transazioni
    • 13 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 22 feb 1992
    Consegnato il 06 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the banks under the terms of the facilities agreements on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to each of the hp agreements see form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandand the Banks
    Transazioni
    • 06 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 22 feb 1992
    Consegnato il 06 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the banks under the terms of the facilities agreements on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to each of the hp agreements for full details see form 395.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandand the Banks
    Transazioni
    • 06 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 22 feb 1992
    Consegnato il 06 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the banks under the terms of the facilities agreements on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to each of the hp agreements for full details see form 395.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandand the Banks
    Transazioni
    • 06 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 22 feb 1992
    Consegnato il 06 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the banks under the terms of the facilities agreements on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to each of the hp agreements for full details see form 395.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandand the Banks
    Transazioni
    • 06 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 22 feb 1992
    Consegnato il 06 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the banks under the terms of the facilities agreements on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to each of the hp agreements for full details see form 395.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandand the Banks
    Transazioni
    • 06 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 22 feb 1992
    Consegnato il 06 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the banks under the terms of the facilities agreements on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to each of the hp agreements for full details see form 395.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandand the Banks
    Transazioni
    • 06 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    HARWORTH PLANT & EQUIPMENT LTD ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    29 lug 2013Inizio della liquidazione
    28 mag 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul Bates
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Francis Graham Newton
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0