02650075 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società02650075 LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02650075
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 02650075 LIMITED?

    • altre attività di stampa n.c.a. (18129) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova 02650075 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Pearl Assurance House, 319 Ballards Lane
    N12 8LY London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di 02650075 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GEMINI PRESS LIMITED25 nov 199125 nov 1991
    LEGISTSHELFCO NO.109 LIMITED30 set 199130 set 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di 02650075 LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 gen 2015
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 ott 2015
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2014

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per 02650075 LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al30 apr 2017
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma14 mag 2017
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per 02650075 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per 02650075 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale - precedentemente in liquidazione volontaria dei creditori

    3 pagineREST-CVL

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed shelfco 1234\certificate issued on 14/11/23
    pagineCERTNM

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    14 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 14 nov 2019

    13 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 14 nov 2018

    11 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 nov 2017

    12 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 nov 2016

    18 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da 2/3 Pavilion Buildings Brighton BN1 1EE England a Pearl Assurance House, 319 Ballards Lane London N12 8LY in data 09 dic 2016

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 apr 2016

    18 pagine4.68

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    6 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 16 apr 2015

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da 1a Dolphin Way Shoreham by Sea West Sussex BN43 6NZ a 2/3 Pavilion Buildings Brighton BN1 1EE in data 28 apr 2015

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Owen Jones il 01 dic 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 gen 2014

    21 pagineAA

    Bilancio consolidato redatto al 31 lug 2013

    27 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 ago 2014

    Stato del capitale al 11 ago 2014

    • Capitale: GBP 61,763
    SH01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed gemini press LIMITED\certificate issued on 14/05/14
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name14 mag 2014

    Risoluzione di cambio di nome della società il 06 mag 2014

    RES15
    change-of-name14 mag 2014

    Cambio di nome" per delibera

    NM01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 lug 2014 al 31 gen 2014

    1 pagineAA01

    Chi sono gli amministratori di 02650075 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JONES, Owen
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    Segretario
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    164265960001
    BOYLE, John
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    Amministratore
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    ScotlandBritish13608470008
    CROPPER, Stephen Andrew
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    Amministratore
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    EnglandBritish38816830004
    GWYNNE, Nicholas
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    Amministratore
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    EnglandBritish68213350003
    JONES, Owen Rhys
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    Amministratore
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    EnglandBritish173156970002
    TULLEY, Mark Lee
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    Amministratore
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    EnglandBritish68213410002
    BLACKBURN, Alan Jim
    43 Arlington Avenue
    Goring By Sea
    BN12 4SU Worthing
    West Sussex
    Segretario
    43 Arlington Avenue
    Goring By Sea
    BN12 4SU Worthing
    West Sussex
    British15607910001
    HOLMES, Nigel David
    Flat 2
    11 The Martlet
    BN3 6NT Hove
    East Sussex
    Segretario
    Flat 2
    11 The Martlet
    BN3 6NT Hove
    East Sussex
    British24756150004
    LEGIST CORPORATE SERVICES LIMITED
    P O Box 613
    Epworth House 25 City Road
    EC1Y 1BY London
    Segretario
    P O Box 613
    Epworth House 25 City Road
    EC1Y 1BY London
    32823060001
    BLACKBURN, Alan Jim
    43 Arlington Avenue
    Goring By Sea
    BN12 4SU Worthing
    West Sussex
    Amministratore
    43 Arlington Avenue
    Goring By Sea
    BN12 4SU Worthing
    West Sussex
    British15607910001
    CURRAN, John Paul
    1a Dolphin Way
    Shoreham By Sea
    BN43 6NZ West Sussex
    Amministratore
    1a Dolphin Way
    Shoreham By Sea
    BN43 6NZ West Sussex
    ScotlandBritish44316690001
    HOLMES, Nigel David
    Flat 2
    11 The Martlet
    BN3 6NT Hove
    East Sussex
    Amministratore
    Flat 2
    11 The Martlet
    BN3 6NT Hove
    East Sussex
    EnglandBritish24756150004
    PATERSON, Ronald George
    3 Orlando Road
    SW4 0LE London
    Amministratore
    3 Orlando Road
    SW4 0LE London
    EnglandBritish27681590002
    THOMLINSON, Antony Howard
    7 Portland Road
    W11 4LH London
    Amministratore
    7 Portland Road
    W11 4LH London
    British33437790001
    WEIR, Derek James
    1a Dolphin Way
    Shoreham By Sea
    BN43 6NZ West Sussex
    Amministratore
    1a Dolphin Way
    Shoreham By Sea
    BN43 6NZ West Sussex
    ScotlandBritish83668830001

    02650075 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 16 ago 2013
    Consegnato il 21 ago 2013
    In corso
    Breve descrizione
    A. by way of first fixed charge:. (I) all real property;. (Ii) all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land; and. (Iii) the proceeds of sale of all real property;. B. by way of first fixed charge the intellectual property;. "Real property" means all estates and interests in freehold, leasehold and other immovable property (wherever situated) now or in future belonging to the obligor, or in which the obligor has an interest at any time, together with:. (A) all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed p&m at any time thereon;. (B) all easements, rights and agreements in respect thereof; and. (C) the benefit of all covenants given in respect thereof;. "Intellectual property rights" means:. (I) any patents, trade marks, service marks, designs, business names, copyrights, design rights, moral rights, inventions, confidential information, know-how and other intellectual property rights and interests whether registered or unregistered; and. (Ii) the benefit of all applications and rights to use such assets of the company.. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Centric SPV1 Limited
    Transazioni
    • 21 ago 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Chattel mortgage
    Creato il 13 nov 2012
    Consegnato il 29 nov 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Komori lithrone ls 529P (m) 5- colour press serial number 101 5 colour printing press.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 29 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Charge of deposit
    Creato il 19 ott 2012
    Consegnato il 26 ott 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit of £20,000 and all amounts in the future credited to account number 27091597 with national westminster bank PLC.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central Public Limited Company
    Transazioni
    • 26 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Composite guarantee and debentures
    Creato il 27 gen 2011
    Consegnato il 29 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Centric Spv 1 Limited
    Transazioni
    • 29 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 27 lug 2008
    Consegnato il 08 ago 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 08 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    All assets debenture
    Creato il 05 mar 2007
    Consegnato il 07 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 07 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 17 dic 1998
    Consegnato il 19 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • G E Capital Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 19 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 dic 1995
    Consegnato il 21 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Venture Factors PLC
    Transazioni
    • 21 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 24 apr 1995
    Consegnato il 25 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H-unit 1 stockwell lodge conway street and parking spaces 1 and 2 hove east sussex title no ESX147181 and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed equitable charge
    Creato il 21 mar 1994
    Consegnato il 22 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any agreement
    Brevi particolari
    All debts the subject of an agreement for the factoring or discounting of debts between the company and the security holder which fail to vest absolutely in the security holder. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Venture Factors PLC
    Transazioni
    • 22 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 dic 1992
    Consegnato il 30 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Venture Factors Limited
    Transazioni
    • 30 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    02650075 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 apr 2015Inizio della liquidazione
    07 apr 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David J Buchler
    6 Grosvenor Street
    Mayfair
    W1K 4PZ London
    Praticante
    6 Grosvenor Street
    Mayfair
    W1K 4PZ London
    David Rubin
    Pearl Assurance House 319 Ballards Lane
    Finchley
    N12 8LY London
    Praticante
    Pearl Assurance House 319 Ballards Lane
    Finchley
    N12 8LY London
    Jonathan James Beard
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    Praticante
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    John Walters
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    Praticante
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0