PANDION PUBLISHING LIMITED
Panoramica
Nome della società | PANDION PUBLISHING LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02650152 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PANDION PUBLISHING LIMITED?
- Edizione di libri (58110) / Informazione e comunicazione
Dove si trova PANDION PUBLISHING LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Albury Court Albury OX9 2LP Thame Oxfordshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PANDION PUBLISHING LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ALBURY BOOKS LIMITED | 26 lug 2012 | 26 lug 2012 |
DUNCAN BAIRD PUBLISHERS LIMITED | 01 set 1992 | 01 set 1992 |
TRESSIDER BAIRD EDITIONS LIMITED | 06 nov 1991 | 06 nov 1991 |
CAPELAND LIMITED | 01 ott 1991 | 01 ott 1991 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PANDION PUBLISHING LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2016 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2017 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per PANDION PUBLISHING LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di James Rodney Allpass come segretario in data 08 apr 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di James Rodney Allpass come amministratore in data 08 apr 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per James Rodney Allpass il 01 set 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 026501520009, creata il 20 mar 2015 | 47 pagine | MR01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ott 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per James Rodney Allpass il 01 ott 2014 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Varie Section 519 | 1 pagine | MISC | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ott 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed albury books LIMITED\certificate issued on 07/03/13 | 4 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 4 pagine | CONNOT | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 18 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ott 2012 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Roger Walton come amministratore | 3 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Robert Saxton come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Hayes come amministratore | 3 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PANDION PUBLISHING LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSENHEIM, Simon Alexei | Amministratore | Albury OX9 2LP Thame Albury Court Oxfordshire | England | British | Director | 162530440001 | ||||
ALLPASS, James Rodney | Segretario | Albury OX9 2LP Thame Albury Court Oxfordshire | British | 145997200001 | ||||||
BAIRD, Amanda Jane Caldecott | Segretario | 18 Nicosia Road SW18 3RN London | British | 31328930001 | ||||||
LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
ALLPASS, James Rodney | Amministratore | Albury OX9 2LP Thame Albury Court Oxfordshire | England | British | Chartered Accountant | 45889500005 | ||||
ATTWOOLL, David John | Amministratore | 90 Divinity Road OX4 1LN Oxford Oxfordshire | England | British | Publisher | 13650520001 | ||||
BAIRD, Amanda Jane Caldecott | Amministratore | 18 Nicosia Road SW18 3RN London | British | Manager | 31328930001 | |||||
BAIRD, Duncan Niall Caldecott | Amministratore | Althorp Road SW17 7ED London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | Publisher | 2347340002 | ||||
CORY, Adela Jane | Amministratore | 26 Zealand Road E3 5RB London | British | Production | 81181980002 | |||||
ELPHICK, Paul Dennis | Amministratore | Seven Kings Way KT2 5BJ Kingston Upon Thames 59 Dartmouth House Surrey | England | British | Accountant | 44947290002 | ||||
FOSTER, Nicholas James | Amministratore | 25 Chestnut Road SE27 9EZ London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 17992420002 | ||||
HAYES, Richard George | Amministratore | Cefn Coch SY21 0AB Welshpool Fronhaul Powys | United Kingdom | British | Publishing Consulant | 2213820004 | ||||
MIRKEN, Alan | Amministratore | 733 Park Avenue 22nd Floor 10021 New York New York Usa | Amerian | Publisher | 51194770001 | |||||
MITCHELL, Alexander William Jack | Amministratore | Three Acres Chapel Lane Easton SO21 1HQ Winchester Hampshire | United Kingdom | British | Sales Director | 40442050003 | ||||
MITCHELL, Janice Page | Amministratore | Leggatts Penton Mewsey SP11 0RQ Andover Hampshire | British | Publisher | 31547330003 | |||||
PULLEY, Victoria | Amministratore | Faithfull Close HP17 8PW Aylesbury 15 Bucks | United Kingdom | British | Finance Director | 156070260001 | ||||
SAXTON, Robert Michael | Amministratore | Flat 1 30 Stanhope Road N6 5NG London | United Kingdom | British | Publishing Editorial | 38429340001 | ||||
TRING, Ryan James | Amministratore | 8 Glyn Court Leigham Court Road SW16 2LH London | British | Finance Director | 82690390002 | |||||
WALTON, Roger John | Amministratore | 27 Hamilton Road AL1 4PZ St. Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | Art Director | 31328920002 | ||||
YOUNG, Angela Susan | Amministratore | Manor Road HP20 1JB Aylesbury 29 Buckinghamshire | England | English | Print Production Services | 72816590002 | ||||
LONDON LAW SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PANDION PUBLISHING LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imago Holdings Limited | 06 apr 2016 | Albury OX9 2LP Thame Albury Court England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
PANDION PUBLISHING LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 20 mar 2015 Consegnato il 30 mar 2015 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust debenture | Creato il 31 ago 2009 Consegnato il 19 set 2009 | In corso | Importo garantito £1,500,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 28 mag 2008 Consegnato il 31 mag 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed & floating charge | Creato il 16 apr 2008 Consegnato il 21 apr 2008 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Letter of offset | Creato il 04 giu 2003 Consegnato il 21 giu 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari All sums to the credit of any account or accounts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 21 mag 2003 Consegnato il 03 giu 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge | Creato il 22 ott 1998 Consegnato il 28 ott 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £275,000 due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date | |
Brevi particolari The whole of the undertaking property rights and assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over fluctuating deposit | Creato il 20 set 1995 Consegnato il 03 ott 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Legal charge over cash balances held at the bank from time to time. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 27 mag 1993 Consegnato il 10 giu 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0