EBS NOMINEES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | EBS NOMINEES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02651363 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EBS NOMINEES LIMITED?
- (7487) /
Dove si trova EBS NOMINEES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 2 Broadgate London EC2M 7UR |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di EBS NOMINEES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| TRUSHELFCO (NO.1746) LIMITED | 04 ott 1991 | 04 ott 1991 |
Quali sono gli ultimi bilanci di EBS NOMINEES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2009 |
Quali sono le ultime deposizioni per EBS NOMINEES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Nomina di Samantha Anne Wren come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Iain Torrens come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 ott 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 ott 2009 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Deborah Anne Abrehart il 13 ott 2009 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Iain William Torrens il 06 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Deborah Anne Abrehart il 06 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2009 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2008 | 12 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2007 | 10 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 5 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 6 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di EBS NOMINEES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABREHART, Deborah Anne | Segretario | Broadgate 2 Broadgate EC2M 7UR London 2 England | British | 3219400009 | ||||||
| ABREHART, Deborah Anne | Amministratore | Broadgate 2 Broadgate EC2M 7UR London 2 England | United Kingdom | British | 3219400009 | |||||
| WREN, Samantha Anne | Amministratore | Broadgate EC2M 7UR London 2 England | England | British | 155853230001 | |||||
| FORSTER, Jane | Segretario | 56 Wavertree Road SW2 3SS London | British | 44284390003 | ||||||
| FORSTER, Jane | Segretario | 56 Wavertree Road SW2 3SS London | British | 44284390003 | ||||||
| MANDRYKO, Erica Nadia | Segretario | 75 Silverthorne Road Battersea SW8 3HH London | British | 108502750001 | ||||||
| SCOULLAR, Kathryn Charlotte | Segretario | 104 Acacia Road E17 8BW London | British | 97716910002 | ||||||
| TRUSEC LIMITED | Segretario nominato | 35 Basinghall Street EC2V 5DB London | 900007200001 | |||||||
| BARTKO, Peter | Amministratore | 26 Burgess Hill Cricklewood NW2 2DA London | American | 25724130001 | ||||||
| CAPLEN, Stephen Gerard | Amministratore | 21 Saxon Road SO23 7DJ Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 97716670001 | |||||
| CASS, Trevor Norman | Amministratore | Mount Avenue SS0 8PT Westcliff On Sea 38 Essex | United Kingdom | British | 24679090001 | |||||
| CHANDLER, Christine Anne | Amministratore delegato nominato | 31 Chesnut Grove New Malden Surrey | British | 900007180001 | ||||||
| FROST-SMITH, Paul | Amministratore | Flat B 58 Arundel Square N7 8AP London | British | 13601240001 | ||||||
| JEFFERY, Jonathan Joseph | Amministratore | 10 The Quillot Burwood Park KT12 5BY Walton On Thames | England | British | 190841020001 | |||||
| KIDD, Timothy Charles | Amministratore | Wolmer Cottage Frieth Road SL7 2JQ Marlow Buckinghamshire | England | British | 117842820001 | |||||
| LEDSHAM, David Anthony | Amministratore | 145 Bradbourne Park Road TN13 3LB Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 22759190001 | |||||
| MANION, Kevin Patrick | Amministratore | 26 Mayflower Parkway IRISH Westport Ct 06880. 6014 Usa | American | 71401310002 | ||||||
| MORAN, William Loyola | Amministratore | 38 Braunview Way Orchard Park 14127 New York Usa | American | 68336410001 | ||||||
| REEVE, Robert Arthur | Amministratore delegato nominato | 6 Wellesford Close SM7 2HL Banstead Surrey | British | 900007190001 | ||||||
| SAUNDERS, Christopher John | Amministratore | 35 Basinghall Street EC2V 5DB London | British | 21044340001 | ||||||
| SINGH, Jasbir | Amministratore | 28 Fairholme Road West Kensington W14 9JX London | British | 50876200001 | ||||||
| TORRENS, Iain William | Amministratore | Broadgate 2 Broadgate EC2M 7UR London 2 England | England | British | 120015110001 | |||||
| YOSHIDA, Rodney Neal | Amministratore | 104 Arboresque Drive New Hope Pennsylvania 18938 Usa | American | 69659420002 |
EBS NOMINEES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement (governed by the laws of the state of new york) | Creato il 29 giu 1996 Consegnato il 16 lug 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the borrowers (as defined) to the chargee under the facilities agreement and all present and future obligations of the company to the chargee under the security agreement, the composite guarantee (as defined) and under each other agreement and instrument referred to in the facilities agreement to which the company is a party | |
Brevi particolari The pledged stock, the stock collateral, accounts, instruments, inventory, equipment etc. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement (intellectual property; japan) | Creato il 29 giu 1996 Consegnato il 16 lug 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Any and all obligations from time to time of the company to the chargee under the composite guarantee (as defined) and the security agreement | |
Brevi particolari All rights title and interest in the collateral. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite debenture (singapore) (as amended by an amending deed dated 15TH july 1996 and made between the original companies as defined) | Creato il 29 giu 1996 Consegnato il 16 lug 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite debenture (hong kong) (as amended by an amending deed dated 15TH july 1996 and made between the original companies as defined) | Creato il 29 giu 1996 Consegnato il 16 lug 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite debenture (as amended by an amending deed dated 15TH july 1996 and made between the original companies as defined) | Creato il 29 giu 1996 Consegnato il 16 lug 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0