EBS NOMINEES LIMITED

EBS NOMINEES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEBS NOMINEES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02651363
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EBS NOMINEES LIMITED?

    • (7487) /

    Dove si trova EBS NOMINEES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 Broadgate
    London
    EC2M 7UR
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EBS NOMINEES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TRUSHELFCO (NO.1746) LIMITED04 ott 199104 ott 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di EBS NOMINEES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per EBS NOMINEES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Samantha Anne Wren come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Iain Torrens come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 04 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 ott 2010

    Stato del capitale al 14 ott 2010

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 04 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Deborah Anne Abrehart il 13 ott 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Iain William Torrens il 06 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Deborah Anne Abrehart il 06 ott 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    11 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    12 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    10 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    6 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di EBS NOMINEES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ABREHART, Deborah Anne
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    Segretario
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    British3219400009
    ABREHART, Deborah Anne
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    Amministratore
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    United KingdomBritish3219400009
    WREN, Samantha Anne
    Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    Amministratore
    Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    EnglandBritish155853230001
    FORSTER, Jane
    56 Wavertree Road
    SW2 3SS London
    Segretario
    56 Wavertree Road
    SW2 3SS London
    British44284390003
    FORSTER, Jane
    56 Wavertree Road
    SW2 3SS London
    Segretario
    56 Wavertree Road
    SW2 3SS London
    British44284390003
    MANDRYKO, Erica Nadia
    75 Silverthorne Road
    Battersea
    SW8 3HH London
    Segretario
    75 Silverthorne Road
    Battersea
    SW8 3HH London
    British108502750001
    SCOULLAR, Kathryn Charlotte
    104 Acacia Road
    E17 8BW London
    Segretario
    104 Acacia Road
    E17 8BW London
    British97716910002
    TRUSEC LIMITED
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    Segretario nominato
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    900007200001
    BARTKO, Peter
    26 Burgess Hill
    Cricklewood
    NW2 2DA London
    Amministratore
    26 Burgess Hill
    Cricklewood
    NW2 2DA London
    American25724130001
    CAPLEN, Stephen Gerard
    21 Saxon Road
    SO23 7DJ Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    21 Saxon Road
    SO23 7DJ Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish97716670001
    CASS, Trevor Norman
    Mount Avenue
    SS0 8PT Westcliff On Sea
    38
    Essex
    Amministratore
    Mount Avenue
    SS0 8PT Westcliff On Sea
    38
    Essex
    United KingdomBritish24679090001
    CHANDLER, Christine Anne
    31 Chesnut Grove
    New Malden
    Surrey
    Amministratore delegato nominato
    31 Chesnut Grove
    New Malden
    Surrey
    British900007180001
    FROST-SMITH, Paul
    Flat B 58 Arundel Square
    N7 8AP London
    Amministratore
    Flat B 58 Arundel Square
    N7 8AP London
    British13601240001
    JEFFERY, Jonathan Joseph
    10 The Quillot
    Burwood Park
    KT12 5BY Walton On Thames
    Amministratore
    10 The Quillot
    Burwood Park
    KT12 5BY Walton On Thames
    EnglandBritish190841020001
    KIDD, Timothy Charles
    Wolmer Cottage
    Frieth Road
    SL7 2JQ Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Wolmer Cottage
    Frieth Road
    SL7 2JQ Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish117842820001
    LEDSHAM, David Anthony
    145 Bradbourne Park Road
    TN13 3LB Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    145 Bradbourne Park Road
    TN13 3LB Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish22759190001
    MANION, Kevin Patrick
    26 Mayflower Parkway
    IRISH Westport
    Ct 06880. 6014
    Usa
    Amministratore
    26 Mayflower Parkway
    IRISH Westport
    Ct 06880. 6014
    Usa
    American71401310002
    MORAN, William Loyola
    38 Braunview Way
    Orchard Park
    14127 New York
    Usa
    Amministratore
    38 Braunview Way
    Orchard Park
    14127 New York
    Usa
    American68336410001
    REEVE, Robert Arthur
    6 Wellesford Close
    SM7 2HL Banstead
    Surrey
    Amministratore delegato nominato
    6 Wellesford Close
    SM7 2HL Banstead
    Surrey
    British900007190001
    SAUNDERS, Christopher John
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    Amministratore
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    British21044340001
    SINGH, Jasbir
    28 Fairholme Road
    West Kensington
    W14 9JX London
    Amministratore
    28 Fairholme Road
    West Kensington
    W14 9JX London
    British50876200001
    TORRENS, Iain William
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    Amministratore
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    EnglandBritish120015110001
    YOSHIDA, Rodney Neal
    104 Arboresque Drive
    New Hope
    Pennsylvania 18938
    Usa
    Amministratore
    104 Arboresque Drive
    New Hope
    Pennsylvania 18938
    Usa
    American69659420002

    EBS NOMINEES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement (governed by the laws of the state of new york)
    Creato il 29 giu 1996
    Consegnato il 16 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers (as defined) to the chargee under the facilities agreement and all present and future obligations of the company to the chargee under the security agreement, the composite guarantee (as defined) and under each other agreement and instrument referred to in the facilities agreement to which the company is a party
    Brevi particolari
    The pledged stock, the stock collateral, accounts, instruments, inventory, equipment etc. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chemical Investment Bank Limited (As Trustee for the Beneficiaries)(Since Re-Named Chase Manhattan International Limited)
    Transazioni
    • 16 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement (intellectual property; japan)
    Creato il 29 giu 1996
    Consegnato il 16 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Any and all obligations from time to time of the company to the chargee under the composite guarantee (as defined) and the security agreement
    Brevi particolari
    All rights title and interest in the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chemical Investment Bank Limited (As Trustee for the Beneficiaries)(Since Re-Named Chase Manhattan International Limited)
    Transazioni
    • 16 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture (singapore) (as amended by an amending deed dated 15TH july 1996 and made between the original companies as defined)
    Creato il 29 giu 1996
    Consegnato il 16 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chemical Investment Bank Limited (As Trustee for the Beneficiaries)(Since Re-Named Chase Manhattan International Limited)
    Transazioni
    • 16 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture (hong kong) (as amended by an amending deed dated 15TH july 1996 and made between the original companies as defined)
    Creato il 29 giu 1996
    Consegnato il 16 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chemical Investment Bank Limited (As Trustee for the Beneficiaries)(Since Re-Named Chase Manhattan International Limited)
    Transazioni
    • 16 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture (as amended by an amending deed dated 15TH july 1996 and made between the original companies as defined)
    Creato il 29 giu 1996
    Consegnato il 16 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chemical Investment Bank Limited (As Trustee for the Beneficiaries)(Since Re-Named Chase Manhattan International Limited)
    Transazioni
    • 16 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0