FLEXIMEDIA LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFLEXIMEDIA LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02654520
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FLEXIMEDIA LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova FLEXIMEDIA LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Media House
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FLEXIMEDIA LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PRECIS (1128) LIMITED16 ott 199116 ott 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di FLEXIMEDIA LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per FLEXIMEDIA LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per FLEXIMEDIA LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 10 dic 2015

    • Capitale: GBP 0.10
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 ott 2015

    Stato del capitale al 05 ott 2015

    • Capitale: GBP 3,430,447.1
    SH01

    legacy

    94 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 ott 2014

    Stato del capitale al 01 ott 2014

    • Capitale: GBP 3,430,447.1
    SH01

    legacy

    92 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Cessazione della carica di Caroline Withers come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mine Ozkan Hifzi come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Robert Dominic Dunn come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robert Gale come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 ott 2013

    Stato del capitale al 09 ott 2013

    • Capitale: GBP 3,430,447.1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    4 pagineAA

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Dettagli del direttore cambiati per Caroline Bernadette Elizabeth Withers il 14 mar 2013

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Joanne Tillbrook come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Caroline Bernadette Elizabeth Withers come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di FLEXIMEDIA LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Segretario
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    151020850001
    DUNN, Robert Dominic
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish179134020002
    HIFZI, Mine Ozkan
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish182167230001
    BURNS, Clive
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    Segretario
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    British71073800001
    LUARD, Roger David Eckford
    Rookwoods Water Lane
    Oakridge
    GL6 7PN Stroud
    Gloucestershire
    Segretario
    Rookwoods Water Lane
    Oakridge
    GL6 7PN Stroud
    Gloucestershire
    British28242190001
    LUIZ, Mark Walter
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    Segretario
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    British37860010002
    TAYLOR, Richard George
    72 Hall Green Lane
    Hutton
    CM13 2QT Brentwood
    Essex
    Segretario
    72 Hall Green Lane
    Hutton
    CM13 2QT Brentwood
    Essex
    British47989960001
    OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    Segretario
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    2519400001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Segretario
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BRETT, Stephen Marc
    2092 Hardscrabble Drive
    Boulder
    Colorado
    880303
    Usa
    Amministratore
    2092 Hardscrabble Drive
    Boulder
    Colorado
    880303
    Usa
    American21673650001
    BURDICK, Charles James
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    Amministratore
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    British-American52311710004
    BYNG, Timothy Howard St George, Viscount
    Great Hunts Place
    Owslebury
    SO17 2WL Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Great Hunts Place
    Owslebury
    SO17 2WL Winchester
    Hampshire
    British28242300001
    COOK, Stephen Sands
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    Amministratore
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    British73000530008
    GALE, Robert Charles
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish96956740001
    HARMAN, Phillip Brent
    1 Cartwright Way
    Barnes
    SW13 8HD London
    Amministratore
    1 Cartwright Way
    Barnes
    SW13 8HD London
    New Zealander51102310001
    KOPPEL, Montague
    20 Chapel Street
    SW1X 7BY London
    Amministratore
    20 Chapel Street
    SW1X 7BY London
    British63610140001
    LUARD, Roger David Eckford
    Rookwoods Water Lane
    Oakridge
    GL6 7PN Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    Rookwoods Water Lane
    Oakridge
    GL6 7PN Stroud
    Gloucestershire
    British28242190001
    LUIZ, Mark Walter
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    Amministratore
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    British37860010002
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    OPIE, Lisa Moreen
    6 Millfield
    HP4 2PB Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    6 Millfield
    HP4 2PB Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish88563310001
    RAMPTON, Jack Leslie, Sir
    17 The Ridgeway
    TN10 4NQ Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    17 The Ridgeway
    TN10 4NQ Tonbridge
    Kent
    British13438080001
    SINGER, Adam Nicholas
    8 Oxhey Road
    Oxhey
    WD1 4QE Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    8 Oxhey Road
    Oxhey
    WD1 4QE Watford
    Hertfordshire
    British35783020005
    SINGER, Adam Nicholas
    10747 East Crestline Circle
    Englewood Arapahoe Colorado 80111
    Usa
    Amministratore
    10747 East Crestline Circle
    Englewood Arapahoe Colorado 80111
    Usa
    British35783020003
    SMITH, Neil Reynolds
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    British79956240002
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TINDALE, Lawrence Victor Dolman
    3 Amyand Park Gardens
    TW1 3HS Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    3 Amyand Park Gardens
    TW1 3HS Twickenham
    Middlesex
    British629850001
    WALL, Malcolm Robert
    The Close
    2 Longfield Drive East Sheen
    SW14 7AU London
    Amministratore
    The Close
    2 Longfield Drive East Sheen
    SW14 7AU London
    EnglandBritish178772080002
    WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish140137570002
    YASSUKOVICH, Stanislas Michael
    37 Eaton Place
    SW1X 8DF London
    Amministratore
    37 Eaton Place
    SW1X 8DF London
    American39995940002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Amministratore
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107430002
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Amministratore
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002

    FLEXIMEDIA LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite debenture
    Creato il 29 giu 2010
    Consegnato il 08 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 08 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Confirmation deed
    Creato il 15 apr 2010
    Consegnato il 04 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 04 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A composite debenture
    Creato il 19 gen 2010
    Consegnato il 22 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite debenture
    Creato il 19 gen 2010
    Consegnato il 22 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite debenture
    Creato il 10 dic 2009
    Consegnato il 17 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag
    Transazioni
    • 17 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 14 lug 2004
    Consegnato il 23 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights title benefit and interest in and to a) all indebtedness from s from telewest UK limited, flextech investments (jersey) LTD or any member of the tcn's group b) any interest and other amounts due. A floating charge over all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cibc World Markets PLC, in Its Capacity as New Security Trustee for the New Beneficiaries
    Transazioni
    • 23 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of subordination
    Creato il 14 lug 2004
    Consegnato il 23 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The collateral instruments being the finance documents, any guarantees and any other documents or instruments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cibc World Markets PLC, in Its Capacity as New Security Trustee for the New Beneficiaries
    Transazioni
    • 23 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 02 mar 2000
    Consegnato il 16 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the beneficiaries (as defined) (in this capacity the "security trustee") under or pursuant to the transaction documents (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All stocks shares and securities of any kind whatsoever whether marketable or otherwise. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Toronto-Dominion Bank
    Transazioni
    • 16 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite debenture
    Creato il 27 ago 1997
    Consegnato il 12 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the transaction documents (as defined in the debenture)
    Brevi particolari
    All the undertaking goodwill property assets and rights of such chargor as specified in the debenture (the "charged assets"). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Toronto-Dominion Bank(In It's Capacity as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 12 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0