THE MARKETING COMPANY (YORKSHIRE) LTD.

THE MARKETING COMPANY (YORKSHIRE) LTD.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE MARKETING COMPANY (YORKSHIRE) LTD.
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02655061
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE MARKETING COMPANY (YORKSHIRE) LTD.?

    • (7487) /

    Dove si trova THE MARKETING COMPANY (YORKSHIRE) LTD.?

    Indirizzo della sede legale
    c/o O'HARAS LIMITED
    Wesley House Chapel Lane
    Birstall
    WF17 9EJ Batley
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE MARKETING COMPANY (YORKSHIRE) LTD.?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TROW MARKETING LIMITED17 ott 199117 ott 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE MARKETING COMPANY (YORKSHIRE) LTD.?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per THE MARKETING COMPANY (YORKSHIRE) LTD.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    15 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 mag 2013

    19 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 mag 2012

    16 pagine4.68

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    18 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 25 mag 2011

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da Holmfield Industrial Estate Holmfield Halifax West Yorkshire HX2 9TN in data 10 mag 2011

    1 pagineAD01

    legacy

    pagineMG01

    legacy

    8 pagineMG01

    legacy

    8 pagineMG01

    Cessazione della carica di John Dixon come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per James Jonathan Dixon il 01 giu 2010

    2 pagineCH01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 17 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 ott 2009

    Stato del capitale al 29 ott 2009

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per James Jonathan Dixon il 02 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per John Dixon il 02 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr James Jonathan Dixon il 02 ott 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Paul Waddle il 02 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per John Dixon il 02 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per John Paul Earnshaw il 02 ott 2009

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Susan Dixon come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr James Jonathan Dixon come segretario

    1 pagineAP03

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2008

    8 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di THE MARKETING COMPANY (YORKSHIRE) LTD.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DIXON, James Jonathan
    c/o O'Haras Limited
    Chapel Lane
    Birstall
    WF17 9EJ Batley
    Wesley House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    c/o O'Haras Limited
    Chapel Lane
    Birstall
    WF17 9EJ Batley
    Wesley House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    145985610002
    DIXON, James Jonathan
    c/o O'Haras Limited
    Chapel Lane
    Birstall
    WF17 9EJ Batley
    Wesley House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o O'Haras Limited
    Chapel Lane
    Birstall
    WF17 9EJ Batley
    Wesley House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish25717110009
    EARNSHAW, John Paul
    c/o O'Haras Limited
    Chapel Lane
    Birstall
    WF17 9EJ Batley
    Wesley House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o O'Haras Limited
    Chapel Lane
    Birstall
    WF17 9EJ Batley
    Wesley House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish117532310001
    WADDLE, Paul
    c/o O'Haras Limited
    Chapel Lane
    Birstall
    WF17 9EJ Batley
    Wesley House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o O'Haras Limited
    Chapel Lane
    Birstall
    WF17 9EJ Batley
    Wesley House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish116192970001
    CRAWSHAW, Helen Elizabeth
    3 Summerdale
    Gomersal
    BD19 4AH Cleckheaton
    West Yorkshire
    Segretario
    3 Summerdale
    Gomersal
    BD19 4AH Cleckheaton
    West Yorkshire
    British100476120001
    DIXON, Susan Denise
    High Stones Road
    Cragg Vale, Mytholmroyd
    HX7 5TU Hebden Bridge
    High Stones
    West Yorkshire
    Segretario
    High Stones Road
    Cragg Vale, Mytholmroyd
    HX7 5TU Hebden Bridge
    High Stones
    West Yorkshire
    British136932000001
    DIXON, Susan Denise
    High Stones
    High Stones Road Cragg Vale
    HX7 5TU Hebden Bridge
    Yorkshire
    Segretario
    High Stones
    High Stones Road Cragg Vale
    HX7 5TU Hebden Bridge
    Yorkshire
    British25717090001
    SPENCER COMPANY FORMATIONS LIMITED
    Scorpio House 102 Sydney Street
    Chelsea
    SW3 6NJ London
    Segretario nominato
    Scorpio House 102 Sydney Street
    Chelsea
    SW3 6NJ London
    900003550001
    DIXON, John
    High Stones
    High Stones Road
    HX7 5TU Cragg Vale Hebden Bridge
    West Yorkshire
    Amministratore
    High Stones
    High Stones Road
    HX7 5TU Cragg Vale Hebden Bridge
    West Yorkshire
    British27864030001
    DIXON, John
    Holmfield Industrial Estate
    Holmfield
    HX2 9TN Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    Holmfield Industrial Estate
    Holmfield
    HX2 9TN Halifax
    West Yorkshire
    British27864030001
    WOOD, Michael
    2 Hazel Greave Hall
    Rishworth Road, Barkisland
    HX4 0DU Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 Hazel Greave Hall
    Rishworth Road, Barkisland
    HX4 0DU Halifax
    West Yorkshire
    British47713630003
    SPENCER COMPANY FORMATIONS (DELAWARE) INC
    25 Greystone Manor
    19958 Lewes
    Delaware
    United States Of America
    Amministratore delegato nominato
    25 Greystone Manor
    19958 Lewes
    Delaware
    United States Of America
    900003730001
    SPENCER COMPANY FORMATIONS LIMITED
    Scorpio House 102 Sydney Street
    Chelsea
    SW3 6NJ London
    Amministratore delegato nominato
    Scorpio House 102 Sydney Street
    Chelsea
    SW3 6NJ London
    900003550001

    THE MARKETING COMPANY (YORKSHIRE) LTD. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 05 apr 2011
    Consegnato il 06 apr 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aldermore Invoice Finance a Division of Aldermore Bank PLC
    Transazioni
    • 06 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 25 nov 2010
    Consegnato il 07 dic 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aldermore Invoice Finance, a Division of Aldermore Bank PLC
    Transazioni
    • 07 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Mortgage debenture
    Creato il 10 giu 1997
    Consegnato il 16 giu 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 10 giu 1997
    Consegnato il 16 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a moor end cottage steep lane sowerby bridge west yorkshire.t/nos.WYK465463 WYK433464 WYK295206 and WYK505623. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Single debenture
    Creato il 29 set 1993
    Consegnato il 19 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    THE MARKETING COMPANY (YORKSHIRE) LTD. ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    25 mag 2011Inizio della liquidazione
    07 gen 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Christopher Brooksbank
    Wesley House Huddersfield Road
    Birstall
    WF17 9EJ Batley
    West Yorkshire
    Praticante
    Wesley House Huddersfield Road
    Birstall
    WF17 9EJ Batley
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0