SOUTH LANCASHIRE TRANSPORT COMPANY LIMITED

SOUTH LANCASHIRE TRANSPORT COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOUTH LANCASHIRE TRANSPORT COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02658533
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SOUTH LANCASHIRE TRANSPORT COMPANY LIMITED?

    • Altri trasporti passeggeri urbani, suburbani o metropolitani via terra (non metropolitana o sistemi simili) (49319) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova SOUTH LANCASHIRE TRANSPORT COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SOUTH LANCASHIRE TRANSPORT COMPANY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SPEED 2091 LIMITED29 ott 199129 ott 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOUTH LANCASHIRE TRANSPORT COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per SOUTH LANCASHIRE TRANSPORT COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagine4.71
    A1ORYRYP

    Indirizzo della sede legale modificato da Admiral Way Doxford International Business Park, Sunderland Tyne and Wear SR3 3XP in data 14 set 2012

    2 pagineAD01
    A1H2BU4J

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70
    A1H2BU7V

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600
    A1H2BU7F

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 04 set 2012

    LRESSP

    Nomina di Mr Kenneth Mcintyre Carlaw come amministratore in data 28 ago 2012

    2 pagineAP01
    X1GBEV7D

    Cessazione della carica di Philip Martin Stone come amministratore in data 28 ago 2012

    1 pagineTM01
    X1GBEUMG

    Cessazione della carica di Richard Anthony Bowler come amministratore in data 28 ago 2012

    1 pagineTM01
    X1GBEUL4

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    12 pagineAA
    A1E2S72Z

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 26 mag 2012

    1 pagineCH03
    X19YB2BX

    Bilancio annuale redatto al 29 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 ott 2011

    Stato del capitale al 31 ott 2011

    • Capitale: GBP 100
    SH01
    X72KOYU6

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA
    AD19YXA2

    Bilancio annuale redatto al 29 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    XT221ON6

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA
    A4JTWNOX

    Bilancio annuale redatto al 29 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    XT8E4EIC

    Dettagli del direttore cambiati per Richard Anthony Bowler il 29 ott 2009

    2 pagineCH01
    XT8E2EIA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Philip Martin Stone il 29 ott 2009

    2 pagineCH01
    XT8E3EIB

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 29 ott 2009

    1 pagineCH03
    XT8E1EI9

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA
    A1WMOD60

    legacy

    3 pagine363a
    X1RGM4D8

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    6 pagineAA
    ALR3U0VE

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    6 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di SOUTH LANCASHIRE TRANSPORT COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAVIES, Elizabeth Anne
    Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne And Wear
    Segretario
    Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne And Wear
    British102907000002
    CARLAW, Kenneth Mcintyre
    Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11
    Amministratore
    Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11
    EnglandBritishCompany Director161250030001
    BOTT, Martin Lewis Ryder
    6 St Leonards Avenue
    Lostock
    BL6 4JE Bolton
    Lancs
    Segretario
    6 St Leonards Avenue
    Lostock
    BL6 4JE Bolton
    Lancs
    BritishTransport Manager45343650001
    STAUNTON, Hugh Christopher Thorpe
    38 Morland Avenue
    LE2 2PE Leicester
    Segretario
    38 Morland Avenue
    LE2 2PE Leicester
    British20906740002
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    MBC SECRETARIES LIMITED
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    Segretario nominato
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    900000700001
    BOTT, Martin Lewis Ryder
    6 St Leonards Avenue
    Lostock
    BL6 4JE Bolton
    Lancs
    Amministratore
    6 St Leonards Avenue
    Lostock
    BL6 4JE Bolton
    Lancs
    EnglandBritishTransport Manager45343650001
    BOWLER, Richard Anthony
    Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne And Wear
    Amministratore
    Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne And Wear
    United KingdomBritishCompany Director35116070001
    HIND, Robert Andrew
    18 Maplewell Road
    Woodhouse Eaves
    LE12 8QZ Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    18 Maplewell Road
    Woodhouse Eaves
    LE12 8QZ Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritishCompany Director21961900002
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Amministratore
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritishChartered Accountant4971910001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director6874440001
    PEDDLE, Julian Henry
    Orchard Cottage
    Stubwood
    ST14 5HX Uttoxeter
    Staffordshire
    Amministratore
    Orchard Cottage
    Stubwood
    ST14 5HX Uttoxeter
    Staffordshire
    BritishDirector6284620001
    RAY, John Alfred
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    Amministratore
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    BritishCompany Director58415290001
    STEWART, David Albert
    46 Sandersons Croft
    Leigh
    WN7 2BA Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    46 Sandersons Croft
    Leigh
    WN7 2BA Wigan
    Lancashire
    EnglandBritishTransport Manager44783680001
    STONE, Philip Martin
    Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne And Wear
    Amministratore
    Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne And Wear
    EnglandBritishDirector69200640003
    STONE, Philip Martin
    21 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    Amministratore
    21 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    EnglandBritishFinance Director69200640003
    MBC NOMINEES LIMITED
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    Amministratore delegato nominato
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    900000690001

    SOUTH LANCASHIRE TRANSPORT COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 27 feb 1996
    Consegnato il 05 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land & buildings lying on the east side of beaufort street st helens merseyside t/no MS297952 and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 28 mag 1994
    Consegnato il 14 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land adjacent to unit b beaufort street st helens merseyside t/n la 168668 and proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 14 ott 1993
    Consegnato il 20 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SOUTH LANCASHIRE TRANSPORT COMPANY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 apr 2013Data di scioglimento
    04 set 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Timothy Clay
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praticante
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Rob Sadler
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praticante
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0