PILLAR AUCHINLEA LIMITED

PILLAR AUCHINLEA LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPILLAR AUCHINLEA LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02661047
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PILLAR AUCHINLEA LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova PILLAR AUCHINLEA LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PILLAR AUCHINLEA LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PILLAR LEISURE LIMITED07 feb 199607 feb 1996
    PARDEV (IPSWICH) LIMITED12 gen 199612 gen 1996
    PILLAR (KIRKCALDY) LIMITED03 gen 199603 gen 1996
    PARDEV (IPSWICH) LIMITED05 dic 199105 dic 1991
    HACKREMCO (NO. 716) LIMITED07 nov 199107 nov 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di PILLAR AUCHINLEA LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per PILLAR AUCHINLEA LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 ott 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    4 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 ott 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Mr Bruce Michael James come amministratore in data 25 apr 2018

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 ott 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    4 pagineAA

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2016

    14 pagineAA

    legacy

    210 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Cessazione della carica di Philip John Martin come amministratore in data 31 ott 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Philip John Martin come segretario in data 31 ott 2016

    1 pagineTM02

    Nomina di British Land Company Secretarial Limited come segretario in data 31 ott 2016

    2 pagineAP04

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Mr Charles John Middleton come amministratore in data 13 lug 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Jonathan Charles Mcnuff come amministratore in data 13 lug 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 24 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 ott 2015

    Stato del capitale al 26 ott 2015

    • Capitale: GBP 8
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    4 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2014

    15 pagineAA

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Chi sono gli amministratori di PILLAR AUCHINLEA LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Segretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione8992198
    187856670001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    JAMES, Bruce Michael
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish226746900001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Amministratore
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish205624050001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Amministratore
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish79841030002
    MARTIN, Philip John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Segretario
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    British35118050001
    BERESFORD, Valentine Tristram
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    Amministratore
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    EnglandBritish40766290003
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Amministratore
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    MARTIN, Philip John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish35118050001
    MAXTED, Robert David
    Vanhurst
    Thorncombe Street
    GU5 0ND Bramley
    Surrey
    Amministratore
    Vanhurst
    Thorncombe Street
    GU5 0ND Bramley
    Surrey
    British37177990001
    MCGANN, Martin Francis
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    Amministratore
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    British109383240001
    MOULD, Harold Raymond
    40 Hasker Street
    SW3 2LQ London
    Amministratore
    40 Hasker Street
    SW3 2LQ London
    EnglandBritish35576350006
    MOULD, Harold Raymond
    Guiting Grange
    Guiting Power
    GL54 5UD Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Guiting Grange
    Guiting Power
    GL54 5UD Cheltenham
    Gloucestershire
    British35576350001
    PRICE, Humphrey James Montgomery
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    Amministratore
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    UkBritish14448630001
    SMITH, Andrew David
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish108214880002
    STIRLING, Mark Andrew
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    Amministratore
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    United KingdomBritish106882210001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PILLAR AUCHINLEA LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Pillar Property Group Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    24 ott 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione02570618
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    PILLAR AUCHINLEA LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 19 mar 2004
    Consegnato il 31 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eurohypo Ag London Branch,
    Transazioni
    • 31 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Jersey security agreement
    Creato il 31 gen 2003
    Consegnato il 14 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the chargee (the facility agent) as agent and trustee for the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares and the new rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eurohypo Ag, London Branch
    Transazioni
    • 14 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 31 gen 2003
    Consegnato il 14 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the chargee (the facility agent) as agent and trustee for the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eurohypo Ag, London Branch
    Transazioni
    • 14 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rental assignation
    Creato il 08 gen 2002
    Consegnato il 17 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the firm of the auchinlea partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All sums payable in respect of the leases in respect of the property at westerhouse road auchinlea glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Commercial mortgage deed
    Creato il 23 dic 1992
    Consegnato il 30 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Tower ramparts shopping centre tavern street,ipswich suffolk. Together with all buildings,structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time thereon. All moveable,plant,machinery,implements,utensils stock,furniture equipment vehicles and other chattels owned,hired,leased or rented by the company. The benefit of the goodwill of the company's business and all present and future licences held in connection with the company's business carried on upon any part of the property by way of floating charge all other undertakings and assets of the company.
    Persone aventi diritto
    • Bristol and West Building Society
    Transazioni
    • 30 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 dic 1992
    Consegnato il 30 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All future l/h and f/h property of the company together in all cases with all buildings structures and fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time theron and all the goodwill and uncalled capital of the company both present and future. All book debts and others,claims and chooses in action now and from time to time due,owing or belonging to the company and any proceeds of any such debts or claims collected;all copyrights,patents,trademarks,inventions,design rights,knowhow and other intellectual property rights and the benefit of any pending applicationsfor the same and all benefits deriving therefrom including but not limited to royalties fees,profit sharing agreements and income accruing therefrom to the company now or at any time in the future;.
    Persone aventi diritto
    • Bristol and West Building Society
    Transazioni
    • 30 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0