ASHCOURT ROWAN CORPORATE SOLUTIONS LIMITED

ASHCOURT ROWAN CORPORATE SOLUTIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàASHCOURT ROWAN CORPORATE SOLUTIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02661571
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ASHCOURT ROWAN CORPORATE SOLUTIONS LIMITED?

    • Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova ASHCOURT ROWAN CORPORATE SOLUTIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Observatory
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ASHCOURT ROWAN CORPORATE SOLUTIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    YIG CONSULTING LIMITED15 feb 200115 feb 2001
    HCS PENSIONS MANAGEMENT (HOLDINGS) LIMITED08 nov 199108 nov 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di ASHCOURT ROWAN CORPORATE SOLUTIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per ASHCOURT ROWAN CORPORATE SOLUTIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 nov 2019

    8 pagineLIQ03

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Rehana Hasan, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL England a The Observatory Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL in data 20 mar 2019

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 set 2018

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Christopher Woodhouse come amministratore in data 24 ago 2018

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    30 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 17 ago 2018

    • Capitale: GBP 1.008000
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account 16/08/2018
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Wadham St. John Downing come amministratore in data 03 ago 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Peter Lindop Hall come amministratore in data 30 dic 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 ott 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Mr Christopher Woodhouse come amministratore in data 03 ott 2017

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    13 pagineAA

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Towry, 17th Floor, 6 New Street Square London EC4A 3BF England a 6 Chesterfield Gardens London England W1J 5BQ

    1 pagineAD02

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    13 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL England a C/O Rehana Hasan, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL in data 02 nov 2016

    1 pagineAD01

    Nomina di Mrs Rehana Hasan come segretario in data 31 ott 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jacqueline Anne Gregory come segretario in data 31 ott 2016

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 ott 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di ASHCOURT ROWAN CORPORATE SOLUTIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HASAN, Rehana
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    The Observatory
    Berkshire
    Segretario
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    The Observatory
    Berkshire
    217653920001
    REID, Donald William Sherret
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    The Observatory
    Berkshire
    Amministratore
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    The Observatory
    Berkshire
    EnglandBritish212004930001
    BELLAMY, Martin William
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    Segretario
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    173989030001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Segretario
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    208598140001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    Strand
    WC2N 5HR London
    11
    England
    Segretario
    Strand
    WC2N 5HR London
    11
    England
    197466350001
    HARTLEY, Ian Marsden
    18a York Road
    HG1 2QL Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    18a York Road
    HG1 2QL Harrogate
    North Yorkshire
    British12479150002
    JOHNSTON, Carol Ann
    9i Calles Las Palmeras
    Urb Vista Laguna
    11312 Torreguadiaro
    Cadiz
    Spain
    Segretario
    9i Calles Las Palmeras
    Urb Vista Laguna
    11312 Torreguadiaro
    Cadiz
    Spain
    British52538020003
    JONES, Peter Francis
    15 Wigton Park Close
    LS17 8UH Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    15 Wigton Park Close
    LS17 8UH Leeds
    West Yorkshire
    British33965180002
    NASH, Ian
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    England
    Segretario
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    England
    202477250001
    NICHOLS, Sarah
    Lisbon Square
    LS1 4LY Leeds
    8
    West Yorkshire
    Segretario
    Lisbon Square
    LS1 4LY Leeds
    8
    West Yorkshire
    British157011890001
    PEACOCK, Natasha Valerie
    Pear Tree Drive
    SK15 2PY Stalybridge
    7
    Cheshire
    Segretario
    Pear Tree Drive
    SK15 2PY Stalybridge
    7
    Cheshire
    British129803720001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BATTING, John Paul
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    England
    Amministratore
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    England
    United KingdomBritish13097800004
    BRADSHAW, Phillip Gordon
    Springfield Farm
    Hardwick Road East Hardwick
    WF8 3DL Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    Springfield Farm
    Hardwick Road East Hardwick
    WF8 3DL Pontefract
    West Yorkshire
    United KingdomBritish26428400002
    BUSSEY, Mike Adrian
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    Amministratore
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    United KingdomBritish117090380001
    BUTLER, Steven Paul
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    England
    Amministratore
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    England
    EnglandBritish82946960003
    CHANNACK, Philip Gordon Michael
    Bracken Hill 13 Druid Stoke Avenue
    Stoke Bishop
    BS9 1DB Bristol
    Amministratore
    Bracken Hill 13 Druid Stoke Avenue
    Stoke Bishop
    BS9 1DB Bristol
    United KingdomEnglish4536350001
    CHAPMAN, Andrew
    Ask House 88 Leeds Road
    Bramhope
    LS16 9AN Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Ask House 88 Leeds Road
    Bramhope
    LS16 9AN Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish39777190002
    COLEMAN, Lynn Rose
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    Amministratore
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    United KingdomBritish149721950001
    CRESSWELL-TURNER, Miles Marius
    Ropergate House
    43 Ropergate
    WF8 1JY Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    Ropergate House
    43 Ropergate
    WF8 1JY Pontefract
    West Yorkshire
    EnglandBritish135272850001
    DEVEY, Robert Alan
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish146956760001
    DEVEY, Robert Alan
    Strand
    WC2N 5HR London
    11
    England
    Amministratore
    Strand
    WC2N 5HR London
    11
    England
    United KingdomBritish146956760001
    DOWNING, Wadham St. John
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish208598940001
    FEARNLEY, Giles Robin
    Tiplady Barn
    Blazefield
    HG3 5DN Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Tiplady Barn
    Blazefield
    HG3 5DN Harrogate
    North Yorkshire
    British8781780001
    FLOWER, Gordon Mark
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    Amministratore
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    EnglandBritish133025980001
    HAINES, Stephen Paul
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    Amministratore
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    EnglandBritish185462290001
    HALL, Peter Lindop
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish212005290001
    HARTLEY, Ian Marsden
    18a York Road
    HG1 2QL Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    18a York Road
    HG1 2QL Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish12479150002
    HATHERLEY, David Victor
    4 Edgerton Drive
    LS24 9QW Tadcaster
    North Yorkshire
    Amministratore
    4 Edgerton Drive
    LS24 9QW Tadcaster
    North Yorkshire
    British16783490001
    HERON, Hugh
    114 Carleton Road
    WF8 3NQ Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    114 Carleton Road
    WF8 3NQ Pontefract
    West Yorkshire
    EnglandBritish26428410003
    HOGG, Andrew
    6 Tranfield Gardens
    Guiseley
    LS20 8PZ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    6 Tranfield Gardens
    Guiseley
    LS20 8PZ Leeds
    West Yorkshire
    British63356910003
    JACOBS, Andrew Stephen
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    Amministratore
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    United KingdomBritish183659460001
    JOHNSTON, Carol Ann
    Brindley House Valley Road
    Killamarsh
    S21 1JB Sheffield
    Amministratore
    Brindley House Valley Road
    Killamarsh
    S21 1JB Sheffield
    British52538020002
    JOHNSTON, Paul James
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    England
    Amministratore
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    England
    United KingdomBritish91454550001
    JONES, Gaius Trefor Griffith
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    Amministratore
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    EnglandBritish57884740001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ASHCOURT ROWAN CORPORATE SOLUTIONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    England
    27 mag 2016
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione5721344
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ASHCOURT ROWAN CORPORATE SOLUTIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 18 nov 2015
    Consegnato il 24 nov 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Intermediate Capital Group PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 24 nov 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 mar 2016Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 23 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment of debts by way of security
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 19 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All present and future rights titles and interest in and benefits in the debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over cash deposit
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 16 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit and all the present and future rights titles and benefit of the company in the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment of debts by way of security
    Creato il 29 set 2004
    Consegnato il 15 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or yorkshire investment group limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First priority assignment all present and future rights,titles and interests in and benefits of the company in the debts, together with the benefit of any and all intermediary contracts or agency agreements.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 ott 2002
    Consegnato il 17 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture deed
    Creato il 28 feb 2001
    Consegnato il 06 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 21 feb 1992
    Consegnato il 27 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ASHCOURT ROWAN CORPORATE SOLUTIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 set 2018Inizio della liquidazione
    03 mar 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0