L & H DEVELOPMENTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | L & H DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02662561 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di L & H DEVELOPMENTS LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova L & H DEVELOPMENTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di L & H DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| LONDON AND HENLEY LIMITED | 17 mar 1993 | 17 mar 1993 |
| LONDON AND HENLEY INVESTMENTS LIMITED | 23 giu 1992 | 23 giu 1992 |
| TARGETRAISE LIMITED | 13 nov 1991 | 13 nov 1991 |
Quali sono gli ultimi bilanci di L & H DEVELOPMENTS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per L & H DEVELOPMENTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 nov 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Timothy Andrew Roberts come amministratore in data 25 apr 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Sarah Morrell Barzycki come amministratore in data 30 mar 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Nigel Mark Webb come amministratore in data 25 apr 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Charles John Middleton come amministratore in data 25 apr 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Bruce Michael James come amministratore in data 25 apr 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Jonathan Charles Mcnuff come amministratore in data 25 apr 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018 | 4 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Lucinda Margaret Bell come amministratore in data 19 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 nov 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Nigel Mark Webb il 25 mag 2017 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Lucinda Margaret Bell il 25 mag 2017 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Sarah Morrell Barzycki il 25 mag 2017 | 2 pagine | CH01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 3 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Christopher Michael John Forshaw come amministratore in data 05 apr 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Christopher Michael John Forshaw come amministratore in data 05 apr 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Christopher Michael John Forshaw come amministratore in data 05 apr 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Ndiana Ekpo come segretario in data 06 dic 2016 | 1 pagine | TM02 | ||
Nomina di British Land Company Secretarial Limited come segretario in data 06 dic 2016 | 2 pagine | AP04 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 4 pagine | AA | ||
Chi sono gli amministratori di L & H DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| JAMES, Bruce Michael | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 226746900001 | |||||||||
| MCNUFF, Jonathan Charles | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 205624050001 | |||||||||
| MIDDLETON, Charles John | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 79841030002 | |||||||||
| BRAINE, Anthony | Segretario | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | British | 32809000002 | ||||||||||
| BURGESS, Graeme | Segretario | Bali Hai Cudham Lane North TN14 7RB Sevenoaks Kent | British | 102349020001 | ||||||||||
| CADER, Tariq Azad | Segretario | 19 Brookview Road Streatham SW16 6UA London | British | 42841550001 | ||||||||||
| EKPO, Ndiana | Segretario | Chislehurst Road BR5 1NR Petts Wood 182 Kent United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
| KEARTON GEE, Frank Watts | Segretario | The Windrush Stoke Row Road RG9 5JD Peppard Common Oxfordshire | British | 16914130001 | ||||||||||
| SCUDAMORE, Rebecca Jane | Segretario | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| BARZYCKI, Sarah Morrell | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 58016770004 | |||||||||
| BELL, Lucinda Margaret | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | 32809050044 | |||||||||
| BOWDEN, Robert Edward | Amministratore | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | 152497530001 | |||||||||
| CADER, Tariq Azad | Amministratore | 19 Brookview Road Streatham SW16 6UA London | British | 42841550001 | ||||||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 170891060001 | |||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Amministratore | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | 78691990003 | |||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Amministratore | Langkawi 2 Ashlea Road SL9 8NY Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 78691990001 | ||||||||||
| COOK, Kevin William | Amministratore | Oakcroft Redlands Lane Ewshot GU10 5AS Farnham Surrey | British | 16914120001 | ||||||||||
| ECCLES, Christopher John | Amministratore | 7 Grovenor Road Chiswick W41 3EJ London | British | 61037210002 | ||||||||||
| ECCLES, Christopher John | Amministratore | Salcombe Regis House Salcombe Regis EX10 0JH Sidmouth Devon | Great Britain | British | 61037210003 | |||||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Amministratore | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | 1898090001 | |||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| GUNSTON, Michael Ian | Amministratore | Larchmont Hambledon Road, Denmead PO7 6HB Waterlooville Hampshire | United Kingdom | British | 3079890002 | |||||||||
| HAMILTON, Laura Louise | Amministratore | 5 Park Lodge Park Close SW1X 7PH London | American | 73545680001 | ||||||||||
| HESTER, Stephen Alan Michael | Amministratore | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | 51688320001 | ||||||||||
| JONES, Andrew Marc | Amministratore | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| KEARTON GEE, Frank Watts | Amministratore | The Windrush Stoke Row Road RG9 5JD Peppard Common Oxfordshire | England | British | 16914130001 | |||||||||
| METLISS, Cyril | Amministratore | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | 3079600001 | ||||||||||
| MOORE, Albert Richard Jr | Amministratore | 5 Relton Mews SW7 1ET London | Usa | 73545620001 | ||||||||||
| RITBLAT, John, Sir | Amministratore | The Doric Villa 20 York Terrace East Regents Park NW1 4PT London | England | British | 41694870001 | |||||||||
| RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan | Amministratore | 37 Queens Grove NW8 6HN London | United Kingdom | British | 35758050004 | |||||||||
| ROBERTS, Graham Charles | Amministratore | 6a Lower Belgrave Street SW1W 0LJ London | England | British | 79807180002 | |||||||||
| ROBERTS, Timothy Andrew | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | England | British | 63986410004 | |||||||||
| SMITH, Stephen Paul | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 148183670001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di L & H DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London And Henley Limited | 06 apr 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
L & H DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 21 dic 2000 Consegnato il 05 gen 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies and liabilities due or to become due from the borrower or the company to the beneficiaries under the finance documents or otherwise on any current or other account whatever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge debenture | Creato il 19 lug 2000 Consegnato il 27 lug 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and whether or not the chargee shall have been an original party to the relevant transaction | |
Brevi particolari By way of floating charge all the assets undertaking and property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 18 dic 1997 Consegnato il 24 dic 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Floating charge over the undertaking and all its property and assets present and future. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 27 giu 1997 Consegnato il 16 lug 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 26 lug 1995 Consegnato il 05 ago 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as defined in the deed | |
Brevi particolari Floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 26 lug 1995 Consegnato il 28 lug 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0