L & H DEVELOPMENTS LIMITED

L & H DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàL & H DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02662561
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di L & H DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova L & H DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di L & H DEVELOPMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LONDON AND HENLEY LIMITED17 mar 199317 mar 1993
    LONDON AND HENLEY INVESTMENTS LIMITED23 giu 199223 giu 1992
    TARGETRAISE LIMITED13 nov 199113 nov 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di L & H DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per L & H DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 nov 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Timothy Andrew Roberts come amministratore in data 25 apr 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Sarah Morrell Barzycki come amministratore in data 30 mar 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nigel Mark Webb come amministratore in data 25 apr 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Charles John Middleton come amministratore in data 25 apr 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Bruce Michael James come amministratore in data 25 apr 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Jonathan Charles Mcnuff come amministratore in data 25 apr 2018

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Lucinda Margaret Bell come amministratore in data 19 gen 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 nov 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nigel Mark Webb il 25 mag 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Lucinda Margaret Bell il 25 mag 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Sarah Morrell Barzycki il 25 mag 2017

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Christopher Michael John Forshaw come amministratore in data 05 apr 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christopher Michael John Forshaw come amministratore in data 05 apr 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christopher Michael John Forshaw come amministratore in data 05 apr 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ndiana Ekpo come segretario in data 06 dic 2016

    1 pagineTM02

    Nomina di British Land Company Secretarial Limited come segretario in data 06 dic 2016

    2 pagineAP04

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di L & H DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Segretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione8992198
    187856670001
    JAMES, Bruce Michael
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish226746900001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Amministratore
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish205624050001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Amministratore
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish79841030002
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Segretario
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    British32809000002
    BURGESS, Graeme
    Bali Hai
    Cudham Lane North
    TN14 7RB Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    Bali Hai
    Cudham Lane North
    TN14 7RB Sevenoaks
    Kent
    British102349020001
    CADER, Tariq Azad
    19 Brookview Road
    Streatham
    SW16 6UA London
    Segretario
    19 Brookview Road
    Streatham
    SW16 6UA London
    British42841550001
    EKPO, Ndiana
    Chislehurst Road
    BR5 1NR Petts Wood
    182
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Chislehurst Road
    BR5 1NR Petts Wood
    182
    Kent
    United Kingdom
    Other138446320001
    KEARTON GEE, Frank Watts
    The Windrush
    Stoke Row Road
    RG9 5JD Peppard Common
    Oxfordshire
    Segretario
    The Windrush
    Stoke Row Road
    RG9 5JD Peppard Common
    Oxfordshire
    British16914130001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritish58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritish32809050044
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Amministratore
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritish152497530001
    CADER, Tariq Azad
    19 Brookview Road
    Streatham
    SW16 6UA London
    Amministratore
    19 Brookview Road
    Streatham
    SW16 6UA London
    British42841550001
    CARTER, Simon Geoffrey
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritish170891060001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Amministratore
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritish78691990003
    CLARKE, Peter Courtenay
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78691990001
    COOK, Kevin William
    Oakcroft Redlands Lane
    Ewshot
    GU10 5AS Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Oakcroft Redlands Lane
    Ewshot
    GU10 5AS Farnham
    Surrey
    British16914120001
    ECCLES, Christopher John
    7 Grovenor Road
    Chiswick
    W41 3EJ London
    Amministratore
    7 Grovenor Road
    Chiswick
    W41 3EJ London
    British61037210002
    ECCLES, Christopher John
    Salcombe Regis House
    Salcombe Regis
    EX10 0JH Sidmouth
    Devon
    Amministratore
    Salcombe Regis House
    Salcombe Regis
    EX10 0JH Sidmouth
    Devon
    Great BritainBritish61037210003
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Amministratore
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritish1898090001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    GUNSTON, Michael Ian
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    Amministratore
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritish3079890002
    HAMILTON, Laura Louise
    5 Park Lodge
    Park Close
    SW1X 7PH London
    Amministratore
    5 Park Lodge
    Park Close
    SW1X 7PH London
    American73545680001
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Amministratore
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    British51688320001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Amministratore
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    KEARTON GEE, Frank Watts
    The Windrush
    Stoke Row Road
    RG9 5JD Peppard Common
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Windrush
    Stoke Row Road
    RG9 5JD Peppard Common
    Oxfordshire
    EnglandBritish16914130001
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Amministratore
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    British3079600001
    MOORE, Albert Richard Jr
    5 Relton Mews
    SW7 1ET London
    Amministratore
    5 Relton Mews
    SW7 1ET London
    Usa73545620001
    RITBLAT, John, Sir
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    Amministratore
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    EnglandBritish41694870001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    Amministratore
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritish35758050004
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Amministratore
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritish79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Amministratore
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    EnglandBritish63986410004
    SMITH, Stephen Paul
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish148183670001

    Chi sono le persone con controllo significativo di L & H DEVELOPMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    London And Henley Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 apr 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    L & H DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 21 dic 2000
    Consegnato il 05 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the borrower or the company to the beneficiaries under the finance documents or otherwise on any current or other account whatever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abbey National Treasury Services PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 05 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge debenture
    Creato il 19 lug 2000
    Consegnato il 27 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and whether or not the chargee shall have been an original party to the relevant transaction
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the assets undertaking and property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 18 dic 1997
    Consegnato il 24 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over the undertaking and all its property and assets present and future.
    Persone aventi diritto
    • Kleinwort Benson Development Capital Limitedas Security Trustee for the Security Beneficiaries (As Defined Therein)
    Transazioni
    • 24 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 27 giu 1997
    Consegnato il 16 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 26 lug 1995
    Consegnato il 05 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as defined in the deed
    Brevi particolari
    Floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kleinwort Benson Development Capital Limitedies as Defined Therein ("the Security Trustee")(As Security Trustee for the Security Beneficiar
    Transazioni
    • 05 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 05 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Floating charge
    Creato il 26 lug 1995
    Consegnato il 28 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0