QSR SPORTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | QSR SPORTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02663764 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di QSR SPORTS LIMITED?
- (7499) /
Dove si trova QSR SPORTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 440-450 Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton Northamptonshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di QSR SPORTS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| QUASERSPORT LIMITED | 13 gen 1992 | 13 gen 1992 |
| BRIGHT TASK LIMITED | 18 nov 1991 | 18 nov 1991 |
Quali sono gli ultimi bilanci di QSR SPORTS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 26 feb 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per QSR SPORTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Mark Derrick Beacham come segretario in data 03 feb 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Julia Reynolds come amministratore in data 03 feb 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Dominic Joseph Lavelle come amministratore in data 03 feb 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Mark Derrick Beacham come amministratore in data 03 feb 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Marcello Lombardo come amministratore in data 16 dic 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Dominic Joseph Lavelle come amministratore in data 21 nov 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 26 feb 2011 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Ms Julia Reynolds come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 giu 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Memorandum e Statuto | 39 pagine | MA | ||||||||||||||
Nomina di Mr Mark Derrick Beacham come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Richard Hitt come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Consolidamento delle azioni al 05 nov 2010 | 9 pagine | SH02 | ||||||||||||||
Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni | 2 pagine | SH08 | ||||||||||||||
Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni | 2 pagine | SH10 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 40 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 27 feb 2010 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 giu 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Mark Derrick Beacham il 01 ott 2009 | 3 pagine | CH03 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Marcello Lombardo il 01 ott 2009 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard John Hitt il 01 ott 2009 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di QSR SPORTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEACHAM, Mark Derrick | Segretario | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 Northamptonshire England | British | 135313320001 | ||||||
| BENNETT, Terry | Segretario | Randolph Avenue W9 1BG London 72d | British | 135196530001 | ||||||
| DAWSON, Mary Louise | Segretario | 57 Elms Road SW4 9EP London | British | 68983920002 | ||||||
| HOLDSWORTH, Cheryl Irene | Segretario | 26 Chelveston AL7 2PW Welwyn Garden City Hertfordshire | British | 48354260001 | ||||||
| MURRAY, Philip John | Segretario | 44 Hauxley Drive Waldridge Park DH2 3TE Chester Le Street County Durham | British | 79329620001 | ||||||
| O'KEEFFE, Mark John | Segretario | 5 Fowey Close NN8 5WW Wellingborough Northamptonshire | British | 57880430001 | ||||||
| PILLAY, Paul Vijayasingam | Segretario | 69 Lilleshall Avenue Monkston MK10 9HU Milton Keynes | Other | 79416150001 | ||||||
| PLANT, William Allan | Segretario | 10 The Parks Riverside DH3 3QX Chester Le Street County Durham | British | 87465680001 | ||||||
| WILKINSON, John Richard | Segretario | Abbey Cottage 1 Elm Lane Well End SL8 5PF Bourne End Buckinghamshire | British | 2545190001 | ||||||
| RUTLAND DIRECTORS LIMITED | Segretario nominato | Rutland House 148 Edmund Street B3 2JR Birmingham | 900005280001 | |||||||
| SECRETARIES BY DESIGN LIMITED | Segretario | Blackthorn House Mary Ann Street St Pauls Square B3 1RL Birmingham | 34964180001 | |||||||
| BEACHAM, Mark Derrick | Amministratore | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 Northamptonshire England | United Kingdom | British | 160095260001 | |||||
| BENNETT, Paul David | Amministratore | The Manor House Exelby DL8 2HB Bedale North Yorkshire | British | 49486180001 | ||||||
| BENNINGTON, Glenn Martin | Amministratore | 7 Hartburn Avenue Hartburn TS18 4ES Stockton On Tees Cleveland | British | 39700130001 | ||||||
| BENTLEY, Simon Anthony | Amministratore | Glen Wood House 5 Cedars Close NW4 1TR London | United Kingdom | British | 3007630001 | |||||
| CRAWFORD, Peter | Amministratore | 1 Tudhoe Hall Farm Court Tudhoe Village DL16 6LB Spennymoor County Durham | England | British | 95758680001 | |||||
| CROSLAND, Roy Nicholson | Amministratore | 35 Addison Avenue W11 4QS London | British | 30882970002 | ||||||
| EVANS, Graham Rees | Amministratore | 107 Rye Street CM23 2HD Bishops Stortford Hertfordshire | United Kingdom | British | 26190440001 | |||||
| FLEMING, Keith | Amministratore | Brookmead House The Warren, East Horsley KT24 5RH Leatherhead Surrey | England | British | 112723440002 | |||||
| GIDNEY, Simon Mark | Amministratore | The Old Castle B80 7AD Studley Warwickshire | British | 6775840002 | ||||||
| HALL, Andrew James | Amministratore | Tanglewood 3 Badingham Drive AL5 2DA Harpenden Hertfordshire | England | British | 30306840002 | |||||
| HARDY, Russell Stephen Mons | Amministratore | The Reddings Langley Road, Claverdon CV35 8P Warwick Warwickshire | England | British | 45844210003 | |||||
| HARTLEY, Peter Christopher | Amministratore | 17 Jacobean Lane Knowle B93 9LP Solihull | United Kingdom | British | 96458190001 | |||||
| HITT, Richard John | Amministratore | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 Northamptonshire England | United Kingdom | British | 127468180001 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Amministratore | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 Northamptonshire England | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| LOMBARDO, Marcello | Amministratore | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 Northamptonshire England | England | British | 135699240001 | |||||
| MALONE, Desmond Philip | Amministratore | 1 Morpeth B77 1JF Tamworth Staffordshire | England | British | 87170450001 | |||||
| PLANT, William Allan | Amministratore | 10 The Parks Riverside DH3 3QX Chester Le Street County Durham | British | 87465680001 | ||||||
| REYNOLDS, Julia | Amministratore | Cob Drive Swan Valley NN4 9BB Northampton 440-450 Northamptonshire England | England | British | 127468460001 | |||||
| RUSSELL, David Arthur George | Amministratore | 6 Fernhill Crescent Stacksteads OL13 8JU Bacup Lancashire | British | 54276750001 | ||||||
| SMITH, David Andrew Gordon | Amministratore | 5 Dann Place The Waterfront Wilford Village NG11 7FA Nottingham Nottinghamshire | England | British | 124619670001 | |||||
| SPURLING, Anthony James | Amministratore | Park Cottage 49 Park St Lane Park Street AL2 2JA St Albans Hertfordshire | British | 5224490001 | ||||||
| WILKINSON, John Richard | Amministratore | Abbey Cottage 1 Elm Lane Well End SL8 5PF Bourne End Buckinghamshire | United Kingdom | British | 2545190001 | |||||
| NOMINEES BY DESIGN LIMITED | Amministratore delegato nominato | Blackthorn House Mary Ann Street St Pauls Square Birmingham West Midlands | 900005710001 |
QSR SPORTS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Creato il 18 mar 1994 Consegnato il 25 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 10 mar 1992 Consegnato il 16 mar 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0