JACOBS SKM LIMITED
Panoramica
| Nome della società | JACOBS SKM LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02664685 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di JACOBS SKM LIMITED?
- Attività di architettura (71111) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova JACOBS SKM LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1180 Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham Berkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di JACOBS SKM LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MURDOCH GREEN LIMITED | 17 feb 1992 | 17 feb 1992 |
| SEARCHONLY LIMITED | 21 nov 1991 | 21 nov 1991 |
Quali sono gli ultimi bilanci di JACOBS SKM LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2015 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per JACOBS SKM LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per JACOBS SKM LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 13 giu 2016
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2015 | 10 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Michael Sean Udovic come segretario in data 01 set 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2014 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 ott 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed murdoch green LIMITED\certificate issued on 01/08/14 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2013 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 ott 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Leon Anthony Power il 18 nov 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Michael Timothy Norris il 18 nov 2013 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2012 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 ott 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2011 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 ott 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di William Clyde Markley come segretario in data 13 apr 2011 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di JACOBS SKM LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORRIS, Michael Timothy | Segretario | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | British | 52563600002 | ||||||
| POWER, Leon Anthony | Amministratore | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | Ireland | Irish | 126002790001 | |||||
| KINDER, Graham | Segretario | Winbourne 2a Cairndhu Avenue G84 8PW Helensburgh Dunbartonshire | British | 493480001 | ||||||
| MARKLEY, William Clyde | Segretario | 2105 Sunnybank Drive La Canada 91011 Flintridge California United States Of America | American | 57955380001 | ||||||
| UDOVIC, Michael Sean | Segretario | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | 164620450001 | |||||||
| BABTIE SHAW & MORTON | Segretario | 95 Bothwell Street G2 7HX Glasgow Lanarkshire | 35578630001 | |||||||
| JACOBS U.K. LIMITED | Segretario | 95 Bothwell Street G2 7HX Glasgow Strathclyde Scotland | 31551250002 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ALISTAIR MARK, Taylor | Amministratore | The Old Place Herrings Cottages The St Warninglid RH17 5TR Haywards Heath West Sussex | British | 43970390001 | ||||||
| BROADFOOT, William John Cameron | Amministratore | 43 Viewpark Drive, Burnside Rutherglen G73 3QE Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 118078890001 | |||||
| CUBITT, Mark | Amministratore | Duncraggan House 34 Airthrey Road FK9 5JS Stirling | Scotland | British | 64309900002 | |||||
| DUFF, Robert Shepherd | Amministratore | Graham Avenue G74 4JZ East Kilbride 10 Scotland | Scotland | British | 165632810001 | |||||
| GREEN, Royston Frederick | Amministratore | Hamsland Holt Lewes Road Horsted Keynes RH17 7DY Haywards Heath West Sussex | British | 31584210001 | ||||||
| KINDER, Graham | Amministratore | Winbourne 2a Cairndhu Avenue G84 8PW Helensburgh Dunbartonshire | Scotland | British | 493480001 | |||||
| MALONE, Clifford Neil | Amministratore | 11 Hereward Avenue CR8 2NN Purley Surrey | British | 43970360001 | ||||||
| MITCHELL, William Gilchrist | Amministratore | 1 Henderland Drive Henderland Gate G61 1JJ Glasgow | British | 6248520002 | ||||||
| MITCHELL, William Gilchrist | Amministratore | 1 Henderland Drive Henderland Gate G61 1JJ Glasgow | British | 6248520002 | ||||||
| MURDOCH, James | Amministratore | The Red Cottage Bone Ashe Lane TN15 8NW St Mary's Platt Kent | British | 20692630002 | ||||||
| PERFECT, Henry George | Amministratore | 15 Thorn Road Bearsden G61 4BS Glasgow | Scotland | British | 493500002 | |||||
| THOMAS, Allan William | Amministratore | 23 Westhall Park CR6 9HS Warlingham Surrey | United Kingdom | British | 24272180001 | |||||
| WALLACE, William Angus | Amministratore | 6 Williamwood Park West Netherlee G44 3TE Glasgow Lanarkshire | British | 999680001 | ||||||
| WOODWARD, Stephen Philip | Amministratore | 7 The Crescent SM2 6BP Belmont Surrey | British | 43970330002 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
JACOBS SKM LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 01 giu 1999 Consegnato il 05 giu 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0