FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED

FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02664824
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Alexander House 1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 18 ott 2019

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company ordinary shares cancelled 03/10/2019
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Notifica di Edf Energy Renewables Limited come persona con controllo significativo il 16 mar 2018

    2 paginePSC02

    Cessazione di Edf Energy Renewables Holdings Limited come persona con controllo significativo il 16 mar 2018

    1 paginePSC07

    Nomina di Mr Hassaan Majid come amministratore in data 01 feb 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Owen John Henry Forster come amministratore in data 01 feb 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Geraldine Marie Roseline Anceau come amministratore in data 01 feb 2018

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Modifica dei dettagli di Edf Energy Renewables Holdings Limited come persona con controllo significativo il 23 nov 2017

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da Alexander House 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park, Houghton Le Spring Sunderland England DH4 5RA England a Alexander House 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park Houghton Le Spring, Sunderland England DH4 5RA in data 24 nov 2017

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 40 Grosvenor Place London SW1X 7EN a Alexander House 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park, Houghton Le Spring Sunderland England DH4 5RA in data 24 nov 2017

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LIND, Susan Elizabeth
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    Segretario
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    195217100001
    HUE, Matthieu Thomas
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    Amministratore
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    EnglandFrench183883770001
    MAJID, Hassaan
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    Amministratore
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    EnglandBritish227170770002
    COLLINGWOOD, Martin Bernard
    727 Beverley High Road
    HU6 7ER Hull
    North Humberside
    Segretario
    727 Beverley High Road
    HU6 7ER Hull
    North Humberside
    British70996440001
    HARDIE III, George William
    6858 Carolyn Crest
    Dallas
    Texas 75214
    Usa
    Segretario
    6858 Carolyn Crest
    Dallas
    Texas 75214
    Usa
    American75914880001
    HENDERSON, Robert Raymond
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    Segretario
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    British65382610001
    JOHNSON, Andrew Robert
    5 Plough Farm Close
    HA4 7GH Ruislip
    Middlesex
    Segretario
    5 Plough Farm Close
    HA4 7GH Ruislip
    Middlesex
    British9845710001
    LARSEN, Bruno Kold
    Egernsundvej 1
    Silkeborg
    8600
    Denmark
    Segretario
    Egernsundvej 1
    Silkeborg
    8600
    Denmark
    Danish133554920001
    RAMSAY, Andrew Stephen James
    The Manse
    Langford
    GL7 3LW Lechlade
    Gloucestershire
    Segretario
    The Manse
    Langford
    GL7 3LW Lechlade
    Gloucestershire
    British76376410001
    SAMPSON, Jeremy Andrew
    10 Rowan Place
    HP6 6UR Amersham
    Buckinghamshire
    Segretario
    10 Rowan Place
    HP6 6UR Amersham
    Buckinghamshire
    British37740260002
    SHEPHERD, Clare Marie Ann
    18 Claremont Road
    Highgate
    N6 5BY London
    Segretario
    18 Claremont Road
    Highgate
    N6 5BY London
    British36244350001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANCEAU, Geraldine Marie Roseline
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    England
    England
    Amministratore
    Grosvenor Place
    Victoria
    SW1X 7EN London
    40
    England
    England
    FranceFrench220722130001
    ANDRE, Yvon Jean Marie
    9 Rue Des Dardanelles
    Paris 75017
    France
    Amministratore
    9 Rue Des Dardanelles
    Paris 75017
    France
    French109739740001
    BAKER, David Simon George
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    Amministratore
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United KingdomBritish197462530001
    CHESTER, Peter Francis, Dr
    Tanglewood
    Pyle Hill Mayford
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    Amministratore
    Tanglewood
    Pyle Hill Mayford
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    British21707600003
    CLINGENSMITH, Robert Lamont
    5 Morningside
    Plumbland, Aspatria
    CA7 2EY Wigton
    Cumbria
    Amministratore
    5 Morningside
    Plumbland, Aspatria
    CA7 2EY Wigton
    Cumbria
    American54465360002
    CROUZAT, Philippe
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    Amministratore
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    FranceFrench127904930002
    EGAL, Christian Dominique Yves Marie
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    Amministratore
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    FranceFrench199687190001
    EVANS, Thomas John
    Iona Strathallan Close
    Darley Dale
    DE4 2HJ Matlock
    Derbyshire
    Amministratore
    Iona Strathallan Close
    Darley Dale
    DE4 2HJ Matlock
    Derbyshire
    EnglandBritish38384630001
    FORSTER, Owen John Henry
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    Amministratore
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    EnglandBritish208859480001
    GACA, John Alexander
    19 Walden Lodge Close
    SN10 5BU Devires
    Wiltshire
    Amministratore
    19 Walden Lodge Close
    SN10 5BU Devires
    Wiltshire
    British34143350001
    GUYLER, Robert
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    Amministratore
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    ScotlandBritish183996210001
    HARDIE III, George William
    6858 Carolyn Crest
    Dallas
    Texas 75214
    Usa
    Amministratore
    6858 Carolyn Crest
    Dallas
    Texas 75214
    Usa
    American75914880001
    HARRIS, Vincent Richard
    Ashlea Whiteway View
    Stratton
    GL7 2HY Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    Ashlea Whiteway View
    Stratton
    GL7 2HY Cirencester
    Gloucestershire
    EnglandBritish22138120001
    JACKSON, Roderick James
    2 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    2 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British58381220001
    JOHNSON, Andrew Robert
    5 Plough Farm Close
    HA4 7GH Ruislip
    Middlesex
    Amministratore
    5 Plough Farm Close
    HA4 7GH Ruislip
    Middlesex
    United KingdomBritish9845710001
    JUIN, Laurence
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    Amministratore
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    FranceFrench153653210001
    KNIGHT, Gordon Malcolm
    Treetops
    38 Hale Road
    HP22 6NF Wendover
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Treetops
    38 Hale Road
    HP22 6NF Wendover
    Buckinghamshire
    British35969440001
    LARSEN, Bruno Kold
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    Amministratore
    Grosvenor Place
    SW1X 7EN London
    40
    United Kingdom
    DenmarkDanish133554920016
    LINDLEY, David
    Woodfield House
    Farm Lane, Jordans
    HP9 2UP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Woodfield House
    Farm Lane, Jordans
    HP9 2UP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British84553070001
    LOPEZ-CACICEDO, Carlos, Dr
    Chaucers
    Ogbourne Maizey
    SN8 1XB Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    Chaucers
    Ogbourne Maizey
    SN8 1XB Marlborough
    Wiltshire
    Spanish14105600003
    LORD, Richard
    31 Sweetcroft Lane
    UB10 9LE Hillingdon
    Middlesex
    Amministratore
    31 Sweetcroft Lane
    UB10 9LE Hillingdon
    Middlesex
    British32964470001
    MOURATOGLOU, Paris Paraskevas
    64 Boulevard D' Inkermann
    Neuilly Sur Seine
    92200
    France
    Amministratore
    64 Boulevard D' Inkermann
    Neuilly Sur Seine
    92200
    France
    FranceFrench88093180001
    OGLE, Roger Anthony
    Fewster Barn
    Fewster Road
    GL6 0DH Nailsworth
    Gloucestershire
    Amministratore
    Fewster Barn
    Fewster Road
    GL6 0DH Nailsworth
    Gloucestershire
    United KingdomBritish78166840001

    Chi sono le persone con controllo significativo di FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    16 mar 2018
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06456689
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    06 apr 2016
    1 Mandarin Road
    Rainton Bridge Business Park
    DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland
    Alexander House
    England
    England
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06658187
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 31 mar 2003
    Consegnato il 02 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The assets and undertakings. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Australia and New Zealand Banking Group Limited (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 02 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 gen 2014Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 14 feb 2014Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 22 dic 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental deed
    Creato il 21 ago 2002
    Consegnato il 05 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transazioni
    • 05 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture between westbury windfarms limited, cemmaes windfarm limited, cold northcott windfarm limited, llangwyryfon windfarm limited, tregulland windfarm limited, great orton windfarm ii limited, first windfarm holdings limited, (together the "group members") and fortis bank S.A./N.V.
    Creato il 31 ott 2001
    Consegnato il 08 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future moneys, obligations and liabilities from time to time due, (whether owed jointly or severally or in any capacity whatsoever of each group member to the chargee), owing or incurred by the company under or pursuant to: (a) the secured documents (b) the guarantees and indemnities given by the company under the debenture, which secure all the obligations under the secured documents and each of the company and the group members; and (c) all other provisions of the debenture (all terms as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank S.A./N.V. as the Lender and the Account Bank and Its Successorsin Title, Assignees and Transferees
    Transazioni
    • 08 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 23 gen 2001
    Consegnato il 24 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabbilities due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to a facility agreement dated 3RD december 1998 a composite guarantee and debenture dated 3RD december 1998 , as amended by the debenture
    Brevi particolari
    The l/h property being llangwyrfron windfarm cemmaes windfarm and great orton windfarm. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Orix Ireland Limited
    Transazioni
    • 24 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 03 dic 1998
    Consegnato il 17 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys, obligations and liabilities from time to time due, owing or incurred by the company to the chargee under or pursuant to: (a) a facility agreement dated 3RD december 1998 and made between westbury windfarms limited (the "borrower") and the lender, as that agreement may from time to time be amended, varied, novated, supplemented or replaced (the "facility agreement"); or (b) the debenture
    Brevi particolari
    First fixed charges over all of the present and future assets of the company of the following types: land, interests in land and fixtures, plant, machinery and equipment, goodwill and uncalled capital; it also creates a first floating charge over all other present and future assets of the company.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Orix Ireland Limited (The "Lender")on Behalf of Itself and the Banks from Time to Time Parties to the Facility Agreement
    Transazioni
    • 17 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 feb 1992
    Consegnato il 13 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from the company to any bank secured creditors (as defined in the deed) on any account whatsoever under the terms of any of the finance documents (as defined in the deed)
    Brevi particolari
    (For full details see form 395 tc ref: M44). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0