EQUANS ENERGY SERVICES UK LIMITED
Panoramica
| Nome della società | EQUANS ENERGY SERVICES UK LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02665215 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EQUANS ENERGY SERVICES UK LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova EQUANS ENERGY SERVICES UK LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Grant Thornton Uk Advisory & Tax Llp 11th Floor Landmark St Peters Square M1 4PB 1 Oxford Street Manchester |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di EQUANS ENERGY SERVICES UK LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ENGIE ENERGY SERVICES UK LIMITED | 29 feb 2016 | 29 feb 2016 |
| COFELY ENERGY SERVICES UK LIMITED | 04 lug 2012 | 04 lug 2012 |
| COFATHEC ENERGY SERVICES (UK) LIMITED | 05 gen 2006 | 05 gen 2006 |
| ENERGY SERVICES (UK) LIMITED | 09 lug 1999 | 09 lug 1999 |
| POWERLINE ENERGY SERVICES LIMITED | 03 ott 1996 | 03 ott 1996 |
| MIDLANDS ENERGY SERVICES LIMITED | 17 dic 1991 | 17 dic 1991 |
| FORAY 334 LIMITED | 22 nov 1991 | 22 nov 1991 |
Quali sono gli ultimi bilanci di EQUANS ENERGY SERVICES UK LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2022 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per EQUANS ENERGY SERVICES UK LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma | |
|---|---|
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 22 nov 2024 |
Quali sono le ultime deposizioni per EQUANS ENERGY SERVICES UK LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 9 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 30 Finsbury Square London EC2A 1AG a C/O Grant Thornton Uk Advisory & Tax Llp 11th Floor Landmark St Peters Square 1 Oxford Street Manchester M1 4PB in data 20 mag 2025 | 3 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da First Floor, Neon Q10 Quorum Business Park Benton Lane Newcastle upon Tyne NE12 8BU England a 30 Finsbury Square London EC2A 1AG in data 10 dic 2024 | 3 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 nov 2024 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Cofathec Energy Services Limited come persona con controllo significativo il 11 ott 2022 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 nov 2023 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 25 set 2023
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2022 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Bilal Hashim Lala come amministratore in data 30 apr 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Edward Michael Peeke come amministratore in data 01 mag 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 nov 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Shared Services Centre Q3 Office Quorum Business Park Benton Lane Newcastle upon Tyne NE12 8EX a First Floor, Neon Q10 Quorum Business Park Benton Lane Newcastle upon Tyne NE12 8BU in data 12 ott 2022 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2021 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Sarah Gregory come segretario in data 15 lug 2022 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Pieter Marie Gustaaf Moens come segretario in data 16 lug 2022 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed engie energy services uk LIMITED\certificate issued on 04/04/22 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Samuel Hockman come amministratore in data 28 feb 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di EQUANS ENERGY SERVICES UK LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOENS, Pieter Marie Gustaaf | Segretario | 11th Floor Landmark St Peters Square M1 4PB 1 Oxford Street C/O Grant Thornton Uk Advisory & Tax Llp Manchester | 298360980001 | |||||||
| PEEKE, Edward Michael | Amministratore | 11th Floor Landmark St Peters Square M1 4PB 1 Oxford Street C/O Grant Thornton Uk Advisory & Tax Llp Manchester | England | British | 305256320001 | |||||
| BOOTH, Michael Andrew | Segretario | Coronation Road Cressex Business Park HP12 3TA High Wycombe Stuart House Buckinghamshire United Kingdom | British | 140245930001 | ||||||
| BROWNE, Robert Harvey | Segretario | 41 Western Road West Hagley DY9 0JY Stourbridge West Midlands | British | 61805140001 | ||||||
| DART, Jonathan Embling | Segretario | Oaklands Ewell Road SM3 8AA Cheam Surrey | British | 184883560001 | ||||||
| ELCOCK, Ian | Segretario | The Lodge Blakeshall Wolverley DY11 5XW Kidderminster Worcestershire | British | 72862100001 | ||||||
| GREGORY, Sarah | Segretario | Q3 Office Quorum Business Park NE12 8EX Benton Lane Shared Services Centre Newcastle Upon Tyne England | 197291350001 | |||||||
| HAMILTON, Hugh Campbell, Mr. | Segretario | 3 St Augustines Close WR9 8QW Droitwich Worcestershire | British | 3512530001 | ||||||
| MOUNTFORT, Peter | Segretario | Lower Farm Barn Withybed Lane WR7 4JL Inkberrow Worcestershire | British | 65931750003 | ||||||
| TUDOR, Simone | Segretario | Coronation Road Cressex Business Park HP12 3TA High Wycombe Stuart House Buckinghamshire England | 186797030001 | |||||||
| BACON, Donald George | Amministratore | 544 King Edwards Wharf Sheepcote Street B16 8AB Birmingham | Canadian | 81930330002 | ||||||
| BLUMBERGER, Richard John | Amministratore | Q3 Office Quorum Business Park NE12 8EX Benton Lane Shared Services Centre Newcastle Upon Tyne England | England | British | 137120140004 | |||||
| BOOTH, Michael Andrew | Amministratore | Coronation Road Cressex Business Park HP12 3TA High Wycombe Stuart House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 140245930001 | |||||
| CUMMINS, David Frederick | Amministratore | Coronation Road Cressex Business Park HP12 3TA High Wycombe Stuart House Buckinghamshire England | United Kingdom | British | 168848160001 | |||||
| DART, Jonathan Embling | Amministratore | Oaklands Ewell Road SM3 8AA Cheam Surrey | England | British | 184883560001 | |||||
| DEGG, Garry William | Amministratore | 94 Finstall Road Finstall B60 3DB Bromsgrove Worcestershire | British | 3512550002 | ||||||
| DERRY, Richard Ironmonger | Amministratore | 119 Farndon Road Farndon NG24 4SP Newark Nottinghamshire | England | British | 14160530001 | |||||
| GAVIN, Nigel Laurence | Amministratore | Berry Bower Old London Road TN14 7JR Knockholt Kent | United Kingdom | British | 110134700002 | |||||
| HALE, Colin Stephen | Amministratore | Lower Howsell Road WR14 1UX Malvern Howsell Court Worcestershire England | United Kingdom | British | 45974890003 | |||||
| HARLING, Peter Frederick | Amministratore | The Malt House Main Road Curbridge OX29 7NT Witney Oxfordshire | England | British | 84294040001 | |||||
| HARRIS, Mark Trevor | Amministratore | Q3 Office Quorum Business Park NE12 8EX Benton Lane Shared Services Centre Newcastle Upon Tyne | England | British | 250989500001 | |||||
| HOCKMAN, Samuel | Amministratore | Q3 Office Quorum Business Park NE12 8EX Benton Lane Shared Services Centre Newcastle Upon Tyne | England | British | 244083050001 | |||||
| JAGO, John Michael | Amministratore | Q3 Office Quorum Business Park NE12 8EX Benton Lane Shared Services Centre Newcastle Upon Tyne | England | British | 242611530001 | |||||
| JONES, Edward Andrew Victor | Amministratore | 10 Morningside Tudor Hill B73 6BL Sutton Coldfield West Midlands | United Kingdom | British | 41565850001 | |||||
| JONES, Glyn John | Amministratore | 2 Marwood Croft Streetly B74 3JU Sutton Coldfield West Midlands | United Kingdom | British | 64988930001 | |||||
| KING, Stephen Anthony | Amministratore | Hawthorn House Main Street MK18 2HT Adstock Buckinghamshire | British | 75463860002 | ||||||
| LALA, Bilal Hashim | Amministratore | Q10 Quorum Business Park Benton Lane NE12 8BU Newcastle Upon Tyne First Floor, Neon England | United Kingdom | British | 108307370001 | |||||
| LOVETT, Nicola Elizabeth Anne | Amministratore | Q3 Office Quorum Business Park NE12 8EX Benton Lane Shared Services Centre Newcastle Upon Tyne | England | British | 189442450001 | |||||
| MOUNTFORT, Peter | Amministratore | Lower Farm Barn Withybed Lane WR7 4JL Inkberrow Worcestershire | British | 65931750003 | ||||||
| MURRAY, Roger David | Amministratore | 7 King Stephen's Mount Henwick Road WR2 5PL Worcester | England | British | 3512570001 | |||||
| NORRIS, Trevor | Amministratore | 7 Oakham Road Harborne B17 9DQ Birmingham West Midlands | England | British | 49631030001 | |||||
| OWEN, David Alan | Amministratore | 5 Grove Gardens Woodland Grange B61 0UG Bromsgrove Worcestershire | British | 84846010001 | ||||||
| PETRIE, Wilfrid John | Amministratore | Q3 Office Quorum Business Park NE12 8EX Benton Lane Shared Services Centre Newcastle Upon Tyne England | France | French | 183879670001 | |||||
| PINNELL, Simon David | Amministratore | Q3 Office Quorum Business Park NE12 8EX Benton Lane Shared Services Centre Newcastle Upon Tyne | England | British | 166336510001 | |||||
| POLLINS, Andrew Martin | Amministratore | Q3 Office Quorum Business Park NE12 8EX Benton Lane Shared Services Centre Newcastle Upon Tyne | England | British | 288049950001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di EQUANS ENERGY SERVICES UK LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofathec Energy Services Limited | 06 apr 2016 | Q10 Quorum Business Park Benton Lane NE12 8BU Newcastle Upon Tyne First Floor, Neon United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
EQUANS ENERGY SERVICES UK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0