P GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàP GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02666018
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di P GROUP LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova P GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di P GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PRONTAPRINT GROUP LIMITED07 dic 199207 dic 1992
    PRONTAPRINT (1992) PLC23 mar 199223 mar 1992
    JAYBYTE PLC26 nov 199126 nov 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di P GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per P GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    13 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 ago 2019

    10 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 ago 2018

    10 pagineLIQ03

    Cessazione della carica di Craig Parsons come amministratore in data 01 set 2017

    2 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Marrons Solicitors 1 Meridian South Meridian Business Park Leicester Leicestershire LE19 1WY a 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds LS11 5QR in data 11 set 2017

    2 pagineAD01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Park Mill Wakefield Road Clayton West Huddersfield HD8 9QQ England a Adair Sec Limited 1 Meridian South Meridian Business Park Leicester Leicestershire LE19 1WY

    2 pagineAD02

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 10 ago 2017

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Soddisfazione dell'onere 026660180009 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 026660180008 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 026660180007 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 ott 2016

    16 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 21 giu 2017

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduction of share premium account 20/06/2017
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 ott 2015

    12 pagineAA

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Park Mill Wakefield Road Clayton West Huddersfield HD8 9QQ

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Park Mill Wakefield Road Clayton West Huddersfield HD8 9QQ

    1 pagineAD02

    Iscrizione dell'ipoteca 026660180009, creata il 27 apr 2016

    54 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di P GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MARRONS CONSULTANCIES LIMITED
    Meridian South
    Meridian Business Park
    LE19 1WY Leicester
    1
    Leicestershire
    United Kingdom
    Segretario
    Meridian South
    Meridian Business Park
    LE19 1WY Leicester
    1
    Leicestershire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione01708508
    65475060002
    WHITESIDE, Robert
    23 Millbeck Green
    LS22 5AJ Collingham
    West Yorkshire
    Amministratore
    23 Millbeck Green
    LS22 5AJ Collingham
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director81547240001
    KINN, Jeffrey Martin
    9 Alderwood Way
    SS7 1QJ Hadleigh
    Essex
    Segretario
    9 Alderwood Way
    SS7 1QJ Hadleigh
    Essex
    British31000380002
    LYNCH, Peter Eugene
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    Segretario
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    IrishAccountant96288470001
    BOOKER, John Albert
    Ivy House 43 Church Street
    Buckden
    PE18 9TP Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Ivy House 43 Church Street
    Buckden
    PE18 9TP Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishDirector5944410001
    CARSON, Edward
    Wantz Road
    Wantz Road
    CM4 0EP Margaretting Essex
    Beech Lorne
    Amministratore
    Wantz Road
    Wantz Road
    CM4 0EP Margaretting Essex
    Beech Lorne
    United KingdomBritishCompany Director136498460001
    COLL, James Joseph
    7 Elkwood
    Rathfarmham
    16 Dublin
    Ireland
    Amministratore
    7 Elkwood
    Rathfarmham
    16 Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director51120160001
    CREAN, Patrick James
    The Beeches Enniskerry Demense
    Enniskerry
    County Wicklow Eire
    Amministratore
    The Beeches Enniskerry Demense
    Enniskerry
    County Wicklow Eire
    IrelandIrishAccountant54812330001
    EVERARD, Clinton Edwin
    Ballymoss
    Thursley Road Elstead
    GU8 6EB Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Ballymoss
    Thursley Road Elstead
    GU8 6EB Godalming
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director99667360001
    HERBERT, Kevin Arthur
    Southfield Close
    Rufforth
    YO23 3RE York
    28
    Amministratore
    Southfield Close
    Rufforth
    YO23 3RE York
    28
    EnglandBritishAccountant167011610001
    KINN, Jeffrey Martin
    Nine Oaks 5 Woodlands Park
    SS9 3TX Leigh On Sea
    Essex
    Amministratore
    Nine Oaks 5 Woodlands Park
    SS9 3TX Leigh On Sea
    Essex
    BritishCompany Director31000380004
    LOANE, Beaufort Nelson
    1 Rathdown Crescent
    IRISH Terenure
    Dublin 6
    Ireland
    Amministratore
    1 Rathdown Crescent
    IRISH Terenure
    Dublin 6
    Ireland
    IrishAccountant78428900001
    LYNCH, Peter Eugene
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    Amministratore
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    IrelandIrishAccountant96288470001
    MOTTERSHEAD, Derek Stuart
    The Cottage 1 Millgate
    Gilling West
    DL10 5JQ Richmond
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Cottage 1 Millgate
    Gilling West
    DL10 5JQ Richmond
    North Yorkshire
    BritishCompany Director36334680001
    O TIGHEARNAIGH, Cormac
    56 Hillside
    IRISH Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    Amministratore
    56 Hillside
    IRISH Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    IrishAccountant84690240001
    PARSONS, Craig
    Wakefield Road
    Clayton West
    HD8 9QQ Huddersfield
    Park Mill
    England
    Amministratore
    Wakefield Road
    Clayton West
    HD8 9QQ Huddersfield
    Park Mill
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer181017920001
    RAWORTH, Richard
    7 St Georges Road
    St Margarets
    TW1 1QS Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    7 St Georges Road
    St Margarets
    TW1 1QS Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director1506920001
    SMITH, David Richard Peart
    Ashford Cottage
    Steep
    GU32 1AB Petersfield
    Hants
    Amministratore
    Ashford Cottage
    Steep
    GU32 1AB Petersfield
    Hants
    BritishCompany Director32883530002
    SPENCE, Michael Allan
    Redlands
    Merrybent
    DL2 2LB Darlington
    County Durham
    Amministratore
    Redlands
    Merrybent
    DL2 2LB Darlington
    County Durham
    BritishCompany Director59228100001
    STREET, Geoffrey Graham
    9 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    9 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director70418720001

    Chi sono le persone con controllo significativo di P GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    1 Meridian South
    Meridian Business Park
    LE19 1WY Leicester
    Shakespeare Martineau
    England
    26 nov 2016
    1 Meridian South
    Meridian Business Park
    LE19 1WY Leicester
    Shakespeare Martineau
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02387953
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    P GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 27 apr 2016
    Consegnato il 27 apr 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Not applicable.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 27 apr 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 30 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 10 apr 2015
    Consegnato il 14 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Property detailed in schedule 3 of the instrument, including freehold land and buildings on the west side of falconer road, haverhill - title number SK141185. For more information please refer to schedule 3 of the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP
    Transazioni
    • 14 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 30 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 03 ott 2014
    Consegnato il 07 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 30 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 mar 2012
    Consegnato il 03 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 ott 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 24 mar 2006
    Consegnato il 12 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by the obligors to the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 12 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ott 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 14 july 2000
    Creato il 30 ago 2000
    Consegnato il 08 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities whatsoever due or to become due from each charging company (as defined) to the chargee and the security beneficiaries (as defined) under the banking documents, the mezzanine loan agreement and/or the senior note documents (all as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, as Security Trustee for the Securitybeneficiaries
    Transazioni
    • 08 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 giu 1997
    Consegnato il 27 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks Plcas Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 27 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 16 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 29 nov 1995
    Consegnato il 07 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 ago 1992
    Consegnato il 17 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    For full details see form 395 m/3/L. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co. Limitedas Agent and Trustee for Itself and for Each Other Finance Party (As Defined)
    Transazioni
    • 17 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    P GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 ago 2017Inizio della liquidazione
    24 gen 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Derek Hyslop
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Colin Peter Dempster
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0