CIVICA RESOURCE LIMITED

CIVICA RESOURCE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCIVICA RESOURCE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02666282
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CIVICA RESOURCE LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova CIVICA RESOURCE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Smith Cooper
    158 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CIVICA RESOURCE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CORERO BUSINESS SYSTEMS LIMITED27 giu 201127 giu 2011
    CORERO SYSTEMS LIMITED23 feb 200723 feb 2007
    MONDAS INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED27 nov 199127 nov 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di CIVICA RESOURCE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per CIVICA RESOURCE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    18 pagineLIQ13

    Modifica dei dettagli di Civica Uk Limited come persona con controllo significativo il 29 mar 2020

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da Southbank Central 30 Stamford Street London SE1 9LQ England a Smith Cooper 158 Edmund Street Birmingham B3 2HB in data 11 dic 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 27 nov 2019

    LRESSP

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 nov 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Wayne Andrew Story il 01 lug 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Phillip David Rowland il 01 lug 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Michael Stoddard il 01 lug 2018

    1 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017

    5 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 Burston Road London SW15 6AR a Southbank Central 30 Stamford Street London SE1 9LQ in data 01 lug 2018

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Simon Downing come amministratore in data 19 mar 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 nov 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 026662820008 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 026662820007 in pieno

    4 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016

    5 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 05 giu 2017

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Mr Wayne Story come amministratore in data 04 lug 2016

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di CIVICA RESOURCE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    STODDARD, Michael
    158 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Smith Cooper
    Segretario
    158 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Smith Cooper
    180404550001
    ROWLAND, Phillip David
    158 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Smith Cooper
    Amministratore
    158 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Smith Cooper
    EnglandBritish147804610007
    STORY, Wayne Andrew
    158 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Smith Cooper
    Amministratore
    158 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Smith Cooper
    EnglandBritish203683330002
    JOHNSON, Sally Anne
    2 Penk Ridge
    PO9 3LU Havant
    Hampshire
    Segretario
    2 Penk Ridge
    PO9 3LU Havant
    Hampshire
    British49480440002
    SELBY, Ian Robert
    9 Coppice Way
    Hedgerley
    SL2 3YL Slough
    Berkshire
    Segretario
    9 Coppice Way
    Hedgerley
    SL2 3YL Slough
    Berkshire
    British102101830001
    SIMON, Geraldine
    41 Ashley Road
    KT12 1HG Walton On Thames
    Surrey
    Segretario
    41 Ashley Road
    KT12 1HG Walton On Thames
    Surrey
    British104878660001
    SWALLOW, Duncan
    52 Coppice Farm Road
    HP10 8AH High Wycombe
    Buckinghamshire
    Segretario
    52 Coppice Farm Road
    HP10 8AH High Wycombe
    Buckinghamshire
    British125587580001
    CORPORATE NOMINEE SECRETARIES LIMITED
    Falcon House
    24 North John Street
    L2 9RP Liverpool
    Segretario nominato
    Falcon House
    24 North John Street
    L2 9RP Liverpool
    900001010001
    BURLEY, Lee
    Burston Road
    SW15 6AR London
    2
    England
    Amministratore
    Burston Road
    SW15 6AR London
    2
    England
    United KingdomBritish180404350001
    COLLINSON, Peter Martyn Graham
    Milford House Ommanney Road
    PO41 0QA Yarmouth
    Isle Of Wight
    Amministratore
    Milford House Ommanney Road
    PO41 0QA Yarmouth
    Isle Of Wight
    EnglandBritish37243530001
    CROOK, Matthew
    Teapot Cottage Shiplake Row
    Binfield Heath
    RG9 4DR Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Teapot Cottage Shiplake Row
    Binfield Heath
    RG9 4DR Henley On Thames
    Oxfordshire
    British66973970001
    DOWNING, Simon
    Burston Road
    SW15 6AR London
    2
    England
    Amministratore
    Burston Road
    SW15 6AR London
    2
    England
    EnglandBritish180403740001
    MCGEE, Jarlath
    Long Beech House
    Little Chesterton
    OX6 8PD Bicester
    Amministratore
    Long Beech House
    Little Chesterton
    OX6 8PD Bicester
    Irish75068410002
    MCLELLAND, Thomas Charles
    21 Brooklyn Drive
    RG4 8SR Emmer Green
    Berkshire
    Amministratore
    21 Brooklyn Drive
    RG4 8SR Emmer Green
    Berkshire
    British79973250001
    MILLER, Andrew Douglas
    High Street
    WD3 1AY Rickmansworth
    169
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    WD3 1AY Rickmansworth
    169
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish86026930001
    ROBERTSON, Mark
    15 Orchard Way
    CB23 5BN Lower Cambourne
    Cambridgeshire
    Amministratore
    15 Orchard Way
    CB23 5BN Lower Cambourne
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish152654090001
    ROSS, Graham David
    8 Cambus Close
    UB4 9SY Hayes
    Middlesex
    Amministratore
    8 Cambus Close
    UB4 9SY Hayes
    Middlesex
    United KingdomBritish80584730001
    SELBY, Ian Robert
    9 Coppice Way
    Hedgerley
    SL2 3YL Slough
    Berkshire
    Amministratore
    9 Coppice Way
    Hedgerley
    SL2 3YL Slough
    Berkshire
    EnglandBritish102101830001
    SIMON, David Timothy Andrew
    Five Oaks
    41 Ashley Road
    KT12 1HG Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    Five Oaks
    41 Ashley Road
    KT12 1HG Walton On Thames
    Surrey
    EnglandBritish14068670001
    SIMON, Geraldine
    41 Ashley Road
    KT12 1HG Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    41 Ashley Road
    KT12 1HG Walton On Thames
    Surrey
    British104878660001
    SNOWE, Bernard Patrick
    Apple Tree House
    Henley Road Hurley
    SL6 5LH Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Apple Tree House
    Henley Road Hurley
    SL6 5LH Maidenhead
    Berkshire
    EnglandEnglish119341970001
    WARD, Peter James
    106 Merrion Avenue
    HA7 4RX Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    106 Merrion Avenue
    HA7 4RX Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritish1850870001
    WHITEHOUSE, David Benton
    71 Dale Street
    W4 2BY London
    Amministratore
    71 Dale Street
    W4 2BY London
    EnglandBritish39074260002
    CORPORATE NOMINEE SERVICES LIMITED
    Falcon House
    24 North John Street
    L2 9RP Liverpool
    Amministratore delegato nominato
    Falcon House
    24 North John Street
    L2 9RP Liverpool
    900001020001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CIVICA RESOURCE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Stamford Street
    SE1 9LQ London
    Southbank Central
    England
    06 apr 2016
    Stamford Street
    SE1 9LQ London
    Southbank Central
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione01628868
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    CIVICA RESOURCE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 04 ago 2014
    Consegnato il 11 ago 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ge Corporate Finance Bank Sas, London Branch
    Transazioni
    • 11 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 27 ago 2013
    Consegnato il 28 ago 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ge Corporate Finance Bank Sas, London Branch as Security Agent
    Transazioni
    • 28 ago 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 05 apr 2013
    Consegnato il 11 apr 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the group (or any group member) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC (As Security Trustee for Each Group Member)
    Transazioni
    • 11 apr 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 29 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 19 set 2011
    Consegnato il 05 ott 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the group (or any group member) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 05 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 lug 2013Soddisfazione parziale di un'ipoteca (MR04)
    • 29 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creato il 08 ott 2009
    Consegnato il 21 ott 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb re corero systems limited and numbered 00778321 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 02 ago 2007
    Consegnato il 08 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £72,968 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    The deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • I G Communications Limited
    Transazioni
    • 08 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 28 nov 2002
    Consegnato il 07 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 07 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 16 mag 2002
    Consegnato il 18 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The initial deposit of £8,760 together with all interest due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Property k/a part third floor premises 17-29 (odd numbers) sun street and 1 and 3 clifton street london.
    Persone aventi diritto
    • Global Operations & Administration Limited
    Transazioni
    • 18 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    CIVICA RESOURCE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 nov 2019Inizio della liquidazione
    21 dic 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas Charles Osborn Lee
    138 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Praticante
    138 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Dean Anthony Nelson
    Smith Cooper Limited, 158 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Praticante
    Smith Cooper Limited, 158 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0