CIVICA RESOURCE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CIVICA RESOURCE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02666282 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CIVICA RESOURCE LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova CIVICA RESOURCE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Smith Cooper 158 Edmund Street B3 2HB Birmingham |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CIVICA RESOURCE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CORERO BUSINESS SYSTEMS LIMITED | 27 giu 2011 | 27 giu 2011 |
| CORERO SYSTEMS LIMITED | 23 feb 2007 | 23 feb 2007 |
| MONDAS INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | 27 nov 1991 | 27 nov 1991 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CIVICA RESOURCE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per CIVICA RESOURCE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 18 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Civica Uk Limited come persona con controllo significativo il 29 mar 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Southbank Central 30 Stamford Street London SE1 9LQ England a Smith Cooper 158 Edmund Street Birmingham B3 2HB in data 11 dic 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 nov 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 nov 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Wayne Andrew Story il 01 lug 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Phillip David Rowland il 01 lug 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Michael Stoddard il 01 lug 2018 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 2 Burston Road London SW15 6AR a Southbank Central 30 Stamford Street London SE1 9LQ in data 01 lug 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Downing come amministratore in data 19 mar 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 nov 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 026662820008 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 026662820007 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Wayne Story come amministratore in data 04 lug 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CIVICA RESOURCE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STODDARD, Michael | Segretario | 158 Edmund Street B3 2HB Birmingham Smith Cooper | 180404550001 | |||||||
| ROWLAND, Phillip David | Amministratore | 158 Edmund Street B3 2HB Birmingham Smith Cooper | England | British | 147804610007 | |||||
| STORY, Wayne Andrew | Amministratore | 158 Edmund Street B3 2HB Birmingham Smith Cooper | England | British | 203683330002 | |||||
| JOHNSON, Sally Anne | Segretario | 2 Penk Ridge PO9 3LU Havant Hampshire | British | 49480440002 | ||||||
| SELBY, Ian Robert | Segretario | 9 Coppice Way Hedgerley SL2 3YL Slough Berkshire | British | 102101830001 | ||||||
| SIMON, Geraldine | Segretario | 41 Ashley Road KT12 1HG Walton On Thames Surrey | British | 104878660001 | ||||||
| SWALLOW, Duncan | Segretario | 52 Coppice Farm Road HP10 8AH High Wycombe Buckinghamshire | British | 125587580001 | ||||||
| CORPORATE NOMINEE SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | Falcon House 24 North John Street L2 9RP Liverpool | 900001010001 | |||||||
| BURLEY, Lee | Amministratore | Burston Road SW15 6AR London 2 England | United Kingdom | British | 180404350001 | |||||
| COLLINSON, Peter Martyn Graham | Amministratore | Milford House Ommanney Road PO41 0QA Yarmouth Isle Of Wight | England | British | 37243530001 | |||||
| CROOK, Matthew | Amministratore | Teapot Cottage Shiplake Row Binfield Heath RG9 4DR Henley On Thames Oxfordshire | British | 66973970001 | ||||||
| DOWNING, Simon | Amministratore | Burston Road SW15 6AR London 2 England | England | British | 180403740001 | |||||
| MCGEE, Jarlath | Amministratore | Long Beech House Little Chesterton OX6 8PD Bicester | Irish | 75068410002 | ||||||
| MCLELLAND, Thomas Charles | Amministratore | 21 Brooklyn Drive RG4 8SR Emmer Green Berkshire | British | 79973250001 | ||||||
| MILLER, Andrew Douglas | Amministratore | High Street WD3 1AY Rickmansworth 169 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 86026930001 | |||||
| ROBERTSON, Mark | Amministratore | 15 Orchard Way CB23 5BN Lower Cambourne Cambridgeshire | United Kingdom | British | 152654090001 | |||||
| ROSS, Graham David | Amministratore | 8 Cambus Close UB4 9SY Hayes Middlesex | United Kingdom | British | 80584730001 | |||||
| SELBY, Ian Robert | Amministratore | 9 Coppice Way Hedgerley SL2 3YL Slough Berkshire | England | British | 102101830001 | |||||
| SIMON, David Timothy Andrew | Amministratore | Five Oaks 41 Ashley Road KT12 1HG Walton On Thames Surrey | England | British | 14068670001 | |||||
| SIMON, Geraldine | Amministratore | 41 Ashley Road KT12 1HG Walton On Thames Surrey | British | 104878660001 | ||||||
| SNOWE, Bernard Patrick | Amministratore | Apple Tree House Henley Road Hurley SL6 5LH Maidenhead Berkshire | England | English | 119341970001 | |||||
| WARD, Peter James | Amministratore | 106 Merrion Avenue HA7 4RX Stanmore Middlesex | England | British | 1850870001 | |||||
| WHITEHOUSE, David Benton | Amministratore | 71 Dale Street W4 2BY London | England | British | 39074260002 | |||||
| CORPORATE NOMINEE SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Falcon House 24 North John Street L2 9RP Liverpool | 900001020001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CIVICA RESOURCE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civica Uk Limited | 06 apr 2016 | Stamford Street SE1 9LQ London Southbank Central England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CIVICA RESOURCE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 04 ago 2014 Consegnato il 11 ago 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 27 ago 2013 Consegnato il 28 ago 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 05 apr 2013 Consegnato il 11 apr 2013 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the group (or any group member) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 19 set 2011 Consegnato il 05 ott 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the group (or any group member) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deposit agreement to secure own liabilities | Creato il 08 ott 2009 Consegnato il 21 ott 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb re corero systems limited and numbered 00778321 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 02 ago 2007 Consegnato il 08 ago 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £72,968 due or to become due from the company to | |
Brevi particolari The deposit account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 28 nov 2002 Consegnato il 07 dic 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 16 mag 2002 Consegnato il 18 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The initial deposit of £8,760 together with all interest due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Property k/a part third floor premises 17-29 (odd numbers) sun street and 1 and 3 clifton street london. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
CIVICA RESOURCE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0