AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED

AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02666866
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o CLB COPPERS
    Century House
    11 St. Peters Square
    M2 3DN Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NOVASIDE LIMITED24 set 199924 set 1999
    AVONSIDE GROUP LIMITED05 feb 199205 feb 1992
    CSI BUILDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY28 nov 199128 nov 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Churchill House Regent Road Stoke on Trent Staffordshire ST1 3RQ in data 13 gen 2010

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Denise Walker come amministratore

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 18 dic 2009

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 02 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 nov 2009

    Stato del capitale al 03 nov 2009

    • Capitale: GBP 10,175,447
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Denise Margaret Walker il 02 nov 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    14 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    17 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2006

    7 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2005

    7 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    16 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2003

    18 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    6 pagine363s

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine403a

    Chi sono gli amministratori di AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TALLO, John Lambie
    41 Gleneagles Drive
    Penwortham
    PR1 0JT Preston
    Segretario
    41 Gleneagles Drive
    Penwortham
    PR1 0JT Preston
    British634410003
    WALKER, Jonathan James
    Haberfield Old Moor Road
    Wennington
    LA2 8PD Lancaster
    Lancashire
    Amministratore
    Haberfield Old Moor Road
    Wennington
    LA2 8PD Lancaster
    Lancashire
    EnglandBritish39444010001
    O'BRIEN, Neil Christopher
    Alexandra House
    11 St Catherine Drive Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    Segretario
    Alexandra House
    11 St Catherine Drive Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    British58219210001
    RIMMER, David Norman
    Ridgefield
    23 Newport Road
    ST21 6BE Eccleshall
    Staffordshire
    Segretario
    Ridgefield
    23 Newport Road
    ST21 6BE Eccleshall
    Staffordshire
    British71617270002
    SLATER, Richard Craig Alan
    Timbers The Spinney
    Springfield Lane
    LL12 8TG Marford
    Clwyd
    Segretario
    Timbers The Spinney
    Springfield Lane
    LL12 8TG Marford
    Clwyd
    British37111560003
    STEWART, Alan James
    Hazliebrae 38 Dalziel Drive
    G41 4HY Glasgow
    Scotland
    Segretario
    Hazliebrae 38 Dalziel Drive
    G41 4HY Glasgow
    Scotland
    British49964620002
    WILD, Pamela Jayne
    4 Pendine Close
    Callands
    WA5 5RQ Warrington
    Cheshire
    Segretario
    4 Pendine Close
    Callands
    WA5 5RQ Warrington
    Cheshire
    British64167100001
    BALL, John Alexander
    8 Weaver Place
    East Kilbride
    G75 8SH Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    8 Weaver Place
    East Kilbride
    G75 8SH Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish1011280002
    BURKE, Anthony
    5 Stanney Close
    Milnrow
    OL16 4BF Rochdale
    Lancashire
    Amministratore
    5 Stanney Close
    Milnrow
    OL16 4BF Rochdale
    Lancashire
    British58500120001
    CARRUTH, Gordon William
    90 Southwold Road
    Ralston
    PA1 3AL Paisley
    Renfrewshire
    Amministratore
    90 Southwold Road
    Ralston
    PA1 3AL Paisley
    Renfrewshire
    British403770001
    DICKINSON, Ronald William
    57 Redland Drive
    HU10 7UX Kirkella
    North Humberside
    Amministratore
    57 Redland Drive
    HU10 7UX Kirkella
    North Humberside
    British25252540005
    GLYNN, Christopher
    Cliffordine House
    Selsley
    GL5 5LB Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    Cliffordine House
    Selsley
    GL5 5LB Stroud
    Gloucestershire
    British18296920001
    GRAY, Colin Francis
    29 Holmdene Avenue
    SE24 9LB London
    Amministratore
    29 Holmdene Avenue
    SE24 9LB London
    British17566780001
    HUMPHREY, David Trevor
    29 Cedar Grove
    LA9 5BL Kendal
    Cumbria
    Amministratore
    29 Cedar Grove
    LA9 5BL Kendal
    Cumbria
    British48367960002
    LEE, David
    1 Orchard Court
    Heath Lane
    WA3 7DH Croft
    Cheshire
    Amministratore
    1 Orchard Court
    Heath Lane
    WA3 7DH Croft
    Cheshire
    British77825310004
    MACK, Christopher Charles Robert
    18 Oakley Park
    BL1 5XL Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    18 Oakley Park
    BL1 5XL Bolton
    Lancashire
    British158640001
    MURRAY, Stephen
    Went View
    Great North Road
    WF8 3JP Wentbridge
    West Yorkshire
    Amministratore
    Went View
    Great North Road
    WF8 3JP Wentbridge
    West Yorkshire
    United KingdomBritish90170480001
    O'BRIEN, Neil Christopher
    Alexandra House
    11 St Catherine Drive Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    Alexandra House
    11 St Catherine Drive Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    British58219210001
    PALIN, Robert Hornby
    Parkholm Springfield Park
    Overton On Dee
    LL13 0EX Wrexham
    Clwyd
    Wales
    Amministratore
    Parkholm Springfield Park
    Overton On Dee
    LL13 0EX Wrexham
    Clwyd
    Wales
    British46962730001
    PHILLIPS, Ronald Luther Desmond
    Pembroke House
    71 B The Common
    WN8 7EA Parbold
    Lancashire
    Amministratore
    Pembroke House
    71 B The Common
    WN8 7EA Parbold
    Lancashire
    British10631600003
    SAYERS, Steven
    5 Courcelles Court
    KY13 8FT Kinross
    Fife
    Amministratore
    5 Courcelles Court
    KY13 8FT Kinross
    Fife
    United KingdomBritish91113050001
    SCOWCROFT, Brian
    1 Northwold Drive
    BL1 5BH Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    1 Northwold Drive
    BL1 5BH Bolton
    Lancashire
    British16196010001
    SLATER, Richard Craig Alan
    Timbers The Spinney
    Springfield Lane
    LL12 8TG Marford
    Clwyd
    Amministratore
    Timbers The Spinney
    Springfield Lane
    LL12 8TG Marford
    Clwyd
    British37111560003
    STEWART, Alan James
    Hazliebrae 38 Dalziel Drive
    G41 4HY Glasgow
    Scotland
    Amministratore
    Hazliebrae 38 Dalziel Drive
    G41 4HY Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish49964620002
    TALBOT RICE, Nicholas Charles
    Pigeon House
    Coln Rogers
    BL54 3LB Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Pigeon House
    Coln Rogers
    BL54 3LB Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish2830650001
    WALKER, Denise Margaret
    Haberfield
    Old Moor Road Wennington
    LA2 8PD Lancaster
    Lancashire
    Amministratore
    Haberfield
    Old Moor Road Wennington
    LA2 8PD Lancaster
    Lancashire
    EnglandBritish99687220001
    WALKER, Malcolm Charles
    2 Woodside Greenacres
    Greenstiles Lane Swanland
    HU14 3NH North Ferriby
    North Humberside
    Amministratore
    2 Woodside Greenacres
    Greenstiles Lane Swanland
    HU14 3NH North Ferriby
    North Humberside
    British25252520004

    AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture (in respect of units 1-5 holden road industrial estate,leigh,cheshire;title numbers GM565948 and GM831938)
    Creato il 07 apr 2003
    Consegnato il 15 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Including units 1-5 holden road industrial estate,leigh,cheshire; t/nos GM565948 and GM831983. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 25 ott 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 29 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed to a mortgage deed dated 4 august 1999
    Creato il 22 nov 2002
    Consegnato il 03 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land on the south east side of platt fold street leigh wigan greater manchester t/no: GM138559. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 04 ago 1999
    Consegnato il 11 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lombard Natwest Factors Limited
    Transazioni
    • 11 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 04 ago 1999
    Consegnato il 11 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 25 ott 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 29 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 04 ago 1999
    Consegnato il 11 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Lombard Natwest Discounting Limited
    Transazioni
    • 11 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    05 feb 2011Data di scioglimento
    18 dic 2009Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Terence Getliffe
    Century House 11 St Peters Square
    M2 3DN Manchester
    Praticante
    Century House 11 St Peters Square
    M2 3DN Manchester
    Diane Elizabeth Hill
    Clb Coopers
    Century House
    M2 3DN 11 St Peters Square
    Manchester
    Praticante
    Clb Coopers
    Century House
    M2 3DN 11 St Peters Square
    Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0