WHITLENGE ACQUISITION LIMITED

WHITLENGE ACQUISITION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWHITLENGE ACQUISITION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02669979
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WHITLENGE ACQUISITION LIMITED?

    • Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative
    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova WHITLENGE ACQUISITION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    St Ann'S Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WHITLENGE ACQUISITION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WILLOWBAY LIMITED10 dic 199110 dic 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di WHITLENGE ACQUISITION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per WHITLENGE ACQUISITION LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per WHITLENGE ACQUISITION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 23 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 nov 2014

    Stato del capitale al 25 nov 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Stato del capitale al 16 giu 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineSH20

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Consent to reduction res & variation of rights 04/06/2014
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Consent ot reduction res & variation of rights 04/06/2014
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Consent to reduction res & variation of rights 04/06/2014
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di autorità per acquistare un numero di azioni

    RES09
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Cessazione della carica di Michael James Kachmer come amministratore in data 03 apr 2013

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Michael James Kachmer il 23 nov 2010

    2 pagineCH01

    Nomina di Graham Philip Brisley Veal come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kevin Blades come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di WHITLENGE ACQUISITION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Segretario
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4363143
    94529700001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    Amministratore
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    United KingdomBritish146072380001
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    Amministratore
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmerican134328700001
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    Amministratore
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritish43215170003
    BURROWES, Rosemary Anne
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    Segretario
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    British49687740001
    COOK, Graham Frederick
    Graythorn Pinley
    Claverdon
    CV35 8NA Warwick
    Warwickshire
    Segretario
    Graythorn Pinley
    Claverdon
    CV35 8NA Warwick
    Warwickshire
    British56166410001
    DUNCOMBE, John Holles
    Little Beaumonts
    Broad Lane Tanworth In Arden
    B94 5DP Solihull
    West Midlands
    Segretario
    Little Beaumonts
    Broad Lane Tanworth In Arden
    B94 5DP Solihull
    West Midlands
    British15897810001
    JELLETT, Deborah Anne
    2 Southdean Gardens
    SW19 6NU London
    Segretario
    2 Southdean Gardens
    SW19 6NU London
    British26749710001
    SYMS, Rhonda Sneddon
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    Segretario
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    British16978550002
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    Amministratore
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritish79449700002
    COLLINS, Timothy Clark
    384 New Rochelle Road
    Bronzville
    FOREIGN New York 10708
    Usa
    Amministratore
    384 New Rochelle Road
    Bronzville
    FOREIGN New York 10708
    Usa
    Us Citizen146233460001
    COOK, Graham Frederick
    Graythorn Pinley
    Claverdon
    CV35 8NA Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    Graythorn Pinley
    Claverdon
    CV35 8NA Warwick
    Warwickshire
    British56166410001
    DE ST PAER, Michael John
    Highway Farm
    Great Staughton
    PE19 5BG St. Neots
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Highway Farm
    Great Staughton
    PE19 5BG St. Neots
    Cambridgeshire
    British77760720002
    DIGGS, Matthew Obrien
    1160 Lytle Lane
    FOREIGN Dayton
    Ohio 45409
    Usa
    Amministratore
    1160 Lytle Lane
    FOREIGN Dayton
    Ohio 45409
    Usa
    Us Citizen25031750001
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    Amministratore
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United States134081280001
    HOLMES, Donald Darrell
    106 Hunt Trail
    60010 Barrington
    Illinois
    Usa
    Amministratore
    106 Hunt Trail
    60010 Barrington
    Illinois
    Usa
    Us Citizen48648200002
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    JONES, Alan Michael
    37 King George Square
    TW10 6LF Richmond
    Surrey
    Amministratore
    37 King George Square
    TW10 6LF Richmond
    Surrey
    British74175140001
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    Amministratore
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    United StatesAmerican136570610001
    LEE, Richard John
    The Gables
    Ledbury Road, Eastnor
    HR8 1EL Ledbury
    Herefordshire
    Amministratore
    The Gables
    Ledbury Road, Eastnor
    HR8 1EL Ledbury
    Herefordshire
    British79012830002
    OSBORNE, Richard Cogswell
    465 Dundee Road
    60022 Glencoe
    Illinois
    Usa
    Amministratore
    465 Dundee Road
    60022 Glencoe
    Illinois
    Usa
    Us Citizen48648260001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Amministratore delegato nominato
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    RUSHTON, John
    Meadowcroft The Paddock
    Pedmore
    DY9 0RE Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    Meadowcroft The Paddock
    Pedmore
    DY9 0RE Stourbridge
    West Midlands
    British57521970001
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310650003
    S & W BERISFORD LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310610006

    WHITLENGE ACQUISITION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002
    Creato il 11 apr 2002
    Consegnato il 25 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of furtherproperties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 25 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent
    Creato il 20 feb 2002
    Consegnato il 08 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 08 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent)
    Creato il 20 nov 2001
    Consegnato il 30 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 apr 1992
    Consegnato il 09 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0