WHITLENGE ACQUISITION LIMITED
Panoramica
| Nome della società | WHITLENGE ACQUISITION LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02669979 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WHITLENGE ACQUISITION LIMITED?
- Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova WHITLENGE ACQUISITION LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | St Ann'S Wharf 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di WHITLENGE ACQUISITION LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| WILLOWBAY LIMITED | 10 dic 1991 | 10 dic 1991 |
Quali sono gli ultimi bilanci di WHITLENGE ACQUISITION LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per WHITLENGE ACQUISITION LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per WHITLENGE ACQUISITION LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stato del capitale al 16 giu 2014
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 4 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 4 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 4 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 4 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 nov 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Michael James Kachmer come amministratore in data 03 apr 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 nov 2012 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 nov 2011 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 nov 2010 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Michael James Kachmer il 23 nov 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Nomina di Graham Philip Brisley Veal come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Kevin Blades come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2009 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 nov 2009 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di WHITLENGE ACQUISITION LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMA SECRETARY LIMITED | Segretario | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf United Kingdom |
| 94529700001 | ||||||||||
| GRAY, Adrian David | Amministratore | Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf 112 | United Kingdom | British | 146072380001 | |||||||||
| JONES, Maurice Delon | Amministratore | 1650 Westbury Court Manitowoc Wisconsin 54220 Usa | Usa | American | 134328700001 | |||||||||
| VEAL, Graham Philip Brisley | Amministratore | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Anns Wharf United Kingdom | England | British | 43215170003 | |||||||||
| BURROWES, Rosemary Anne | Segretario | 108c Bramley Road Oakwood N14 4HT London | British | 49687740001 | ||||||||||
| COOK, Graham Frederick | Segretario | Graythorn Pinley Claverdon CV35 8NA Warwick Warwickshire | British | 56166410001 | ||||||||||
| DUNCOMBE, John Holles | Segretario | Little Beaumonts Broad Lane Tanworth In Arden B94 5DP Solihull West Midlands | British | 15897810001 | ||||||||||
| JELLETT, Deborah Anne | Segretario | 2 Southdean Gardens SW19 6NU London | British | 26749710001 | ||||||||||
| SYMS, Rhonda Sneddon | Segretario | 2 Swallow Rise Knaphill GU21 2LG Woking Surrey | British | 16978550002 | ||||||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||||||
| BLADES, Kevin Nicholas | Amministratore | Hatch Farm Bossingham Road CT4 6AQ Stelling Minnis Kent | England | British | 79449700002 | |||||||||
| COLLINS, Timothy Clark | Amministratore | 384 New Rochelle Road Bronzville FOREIGN New York 10708 Usa | Us Citizen | 146233460001 | ||||||||||
| COOK, Graham Frederick | Amministratore | Graythorn Pinley Claverdon CV35 8NA Warwick Warwickshire | British | 56166410001 | ||||||||||
| DE ST PAER, Michael John | Amministratore | Highway Farm Great Staughton PE19 5BG St. Neots Cambridgeshire | British | 77760720002 | ||||||||||
| DIGGS, Matthew Obrien | Amministratore | 1160 Lytle Lane FOREIGN Dayton Ohio 45409 Usa | Us Citizen | 25031750001 | ||||||||||
| DOERR, Thomas | Amministratore | Hillborow Road KT10 9UD Esher Newleigh House Surrey | United States | 134081280001 | ||||||||||
| HOLMES, Donald Darrell | Amministratore | 106 Hunt Trail 60010 Barrington Illinois Usa | Us Citizen | 48648200002 | ||||||||||
| HOOPER, David Ross | Amministratore | Mill Road SL7 1UA Marlow 6 Millbank Buckinghamshire | British | 17023730002 | ||||||||||
| JONES, Alan Michael | Amministratore | 37 King George Square TW10 6LF Richmond Surrey | British | 74175140001 | ||||||||||
| KACHMER, Michael James | Amministratore | Marywood Trail 60187 Wheaton 14 Illinois United States | United States | American | 136570610001 | |||||||||
| LEE, Richard John | Amministratore | The Gables Ledbury Road, Eastnor HR8 1EL Ledbury Herefordshire | British | 79012830002 | ||||||||||
| OSBORNE, Richard Cogswell | Amministratore | 465 Dundee Road 60022 Glencoe Illinois Usa | Us Citizen | 48648260001 | ||||||||||
| RICHARDS, Martin Edgar | Amministratore delegato nominato | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||||||
| RUSHTON, John | Amministratore | Meadowcroft The Paddock Pedmore DY9 0RE Stourbridge West Midlands | British | 57521970001 | ||||||||||
| BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED | Amministratore | The Place 175 High Holborn WC1V 7AA London | 75310650003 | |||||||||||
| S & W BERISFORD LIMITED | Amministratore | The Place 175 High Holborn WC1V 7AA London | 75310610006 |
WHITLENGE ACQUISITION LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002 | Creato il 11 apr 2002 Consegnato il 25 apr 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of furtherproperties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent | Creato il 20 feb 2002 Consegnato il 08 mar 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent) | Creato il 20 nov 2001 Consegnato il 30 nov 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 01 apr 1992 Consegnato il 09 apr 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0