PH DEVELOPMENTS LIMITED

PH DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPH DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02670384
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PH DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova PH DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Norcliffe House
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PH DEVELOPMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    QUALITY CARE DEVELOPMENTS LIMITED11 dic 199111 dic 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di PH DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per PH DEVELOPMENTS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per PH DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 24 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 dic 2015

    Stato del capitale al 24 dic 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    7 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Richard Smith il 19 feb 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Benjamin Robert Taberner il 18 feb 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 24 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 dic 2014

    Stato del capitale al 13 dic 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Cessazione della carica di Dominic Jude Kay come amministratore in data 31 ott 2014

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Dominic Kay come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Abigail Mattison come segretario

    2 pagineAP03

    Dettagli del direttore cambiati per Maureen Claire Royston il 22 mag 2014

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Emerson Court Alderley Road Wilmslow Cheshire SK9 1NX* in data 21 feb 2014

    1 pagineAD01

    Nomina di Maureen Claire Royston come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 24 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 dic 2013

    Stato del capitale al 05 dic 2013

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Cessazione della carica di Peter Calveley come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Ian Richard Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    8 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di PH DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MATTISON, Abigail
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    Segretario
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    188574840001
    ROYSTON, Maureen Claire, Dr
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    Amministratore
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    United KingdomBritish184190020002
    SMITH, Ian Richard
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritish181082310001
    TABERNER, Benjamin Robert
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritish150511890001
    BANNATYNE, Gail Mary
    Holly Tree House Darlington Road
    Long Newton
    TS21 1PE Stockton On Tees
    Cleveland
    Segretario
    Holly Tree House Darlington Road
    Long Newton
    TS21 1PE Stockton On Tees
    Cleveland
    British18727650001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    British38256680007
    DARK, Anthony Hedley
    57 Crescent Lane
    SW4 9PT Clapham
    London
    Segretario
    57 Crescent Lane
    SW4 9PT Clapham
    London
    British84286690001
    GOSLING, Mark David
    8 Dane Close
    Hartlip
    ME9 7TN Sittingbourne
    Kent
    Segretario
    8 Dane Close
    Hartlip
    ME9 7TN Sittingbourne
    Kent
    British66801660001
    JAP, Chee Miau
    33 Cheyne Place
    SW3 4HL London
    Segretario
    33 Cheyne Place
    SW3 4HL London
    Singaporean37858790001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Segretario
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    British145920530001
    PARK, Sonya C
    138 Dalston Lane
    E8 1NG London
    Segretario
    138 Dalston Lane
    E8 1NG London
    American75811580001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Segretario
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANSTEAD, Hamilton Douglas
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    British107751890001
    BAILEY JR, Essel William
    1 Hillside Court
    Ann Arbor
    Mi
    48104
    Usa
    Amministratore
    1 Hillside Court
    Ann Arbor
    Mi
    48104
    Usa
    American82601840001
    BANNATYNE, Duncan Walker
    55 Cleveland Avenue
    DL3 7HF Darlington
    County Durham
    Amministratore
    55 Cleveland Avenue
    DL3 7HF Darlington
    County Durham
    British53468760002
    BANNATYNE, Gail Mary
    Holly Tree House Darlington Road
    Long Newton
    TS21 1PE Stockton On Tees
    Cleveland
    Amministratore
    Holly Tree House Darlington Road
    Long Newton
    TS21 1PE Stockton On Tees
    Cleveland
    British18727650001
    CALVELEY, Peter, Dr
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    Amministratore
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    United KingdomBritish131468590001
    CLINTON, Leonard
    10 Brinkburn Fairfield
    Washington
    NE38 8SD Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    10 Brinkburn Fairfield
    Washington
    NE38 8SD Sunderland
    Tyne & Wear
    British44601650001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    British38256680007
    ELLIOTT, Graham Nicholas
    9 Bowmans Close
    BN44 3SR Steyning
    West Sussex
    Amministratore
    9 Bowmans Close
    BN44 3SR Steyning
    West Sussex
    EnglandBritish38064300002
    FALLON, Michael Cathel
    The Manor House Church Road
    Sundridge
    TN14 6EA Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    The Manor House Church Road
    Sundridge
    TN14 6EA Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish32022290002
    FLAHERTY, James Paul
    28 Harley House
    Marylebone Road
    NW1 5HF London
    Amministratore
    28 Harley House
    Marylebone Road
    NW1 5HF London
    American52843400002
    FRANKE, Thomas Frederick
    410 North Eagle Street
    49068 Marshall
    Michigan
    Usa
    Amministratore
    410 North Eagle Street
    49068 Marshall
    Michigan
    Usa
    United KingdomAmerican50747000001
    GOTTESMAN, Arthur Edward
    38 Chester Terrace
    Regents Park
    NW1 4ND London
    Amministratore
    38 Chester Terrace
    Regents Park
    NW1 4ND London
    American35293490001
    HEYWOOD, Anthony George
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    Amministratore
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    EnglandBritish131288260001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Amministratore
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish145920530001
    MAXWELL, Barbara Ann
    17 Crieff Road
    SW18 2EB London
    Amministratore
    17 Crieff Road
    SW18 2EB London
    Irish41693200001
    MITCHELL, Nicholas John
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Great BritainBritish145102120001
    MOWAT, Magnus
    New Park House
    Whitegate
    CW8 2AY Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    New Park House
    Whitegate
    CW8 2AY Northwich
    Cheshire
    British24768090001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Amministratore
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    STONEHOUSE, David Coulson
    44 Moor Crescent
    Gosforth
    NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    44 Moor Crescent
    Gosforth
    NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish44113920001
    WILLIS, Graeme
    4 Woodbank
    Lynton Lane
    SK9 7NP Alderley Edge
    Cheshire
    Amministratore
    4 Woodbank
    Lynton Lane
    SK9 7NP Alderley Edge
    Cheshire
    British71527500004
    WILLIS, Graeme
    3 Carrwood Road
    SK9 5DJ Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    3 Carrwood Road
    SK9 5DJ Wilmslow
    Cheshire
    British71527500002

    PH DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security accession deed
    Creato il 06 set 2002
    Consegnato il 14 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 14 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 giu 1993
    Consegnato il 05 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 05 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 mag 1992
    Consegnato il 27 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0