WORLDXCHANGE COMMUNICATIONS LIMITED

WORLDXCHANGE COMMUNICATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWORLDXCHANGE COMMUNICATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02671855
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WORLDXCHANGE COMMUNICATIONS LIMITED?

    • (6420) /

    Dove si trova WORLDXCHANGE COMMUNICATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WORLDXCHANGE COMMUNICATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ACC LONG DISTANCE UK LIMITED11 dic 199111 dic 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di WORLDXCHANGE COMMUNICATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al

    Quali sono le ultime deposizioni per WORLDXCHANGE COMMUNICATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Completamento della liquidazione

    1 pagineL64.07

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    8 pagine1.4

    Notifica di revoca dell'ordinanza di amministrazione

    3 pagine2.19

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore fino al 01 mag 2009

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 21 gen 2008

    6 pagine1.3

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 21 gen 2009

    6 pagine1.3

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore fino al 01 nov 2008

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore fino al 01 nov 2008

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 21 gen 2007

    7 pagine1.3

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    5 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 21 gen 2006

    2 pagine1.3

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 21 gen 2005

    2 pagine1.3

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 21 gen 2004

    2 pagine1.3

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Notifica di modifica di un'ordinanza di amministrazione

    9 pagine2.20

    Chi sono gli amministratori di WORLDXCHANGE COMMUNICATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ABBOTT, Roger Brian
    17698 Vista Rancho
    Rancho Sante Fe
    California 92067
    Usa
    Amministratore
    17698 Vista Rancho
    Rancho Sante Fe
    California 92067
    Usa
    American67561960001
    SOREN, Edward
    7051 Vista Rancho Court
    Rancho Santa Fe
    California 92067
    Usa
    Amministratore
    7051 Vista Rancho Court
    Rancho Santa Fe
    California 92067
    Usa
    American67545440001
    COLEMAN, Francis David Roughton
    7132 Gillis Road
    Victor
    FOREIGN New York 14564
    Usa
    Segretario
    7132 Gillis Road
    Victor
    FOREIGN New York 14564
    Usa
    American21508600001
    EVANS, Pamela Elizabeth
    123 City Road
    EC1V 1JB London
    Segretario
    123 City Road
    EC1V 1JB London
    British16769550001
    LANCASTER, Antonia Louise
    37 Ennismore Avenue
    W4 1SE London
    Segretario
    37 Ennismore Avenue
    W4 1SE London
    British60653700001
    PARRY, Paul Kenneth
    40 Culmington Road
    West Ealing
    W13 9NH London
    Segretario
    40 Culmington Road
    West Ealing
    W13 9NH London
    British104116790001
    SMALLEY, Stephanie
    1 Lancaster Close
    KT2 5NH Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    1 Lancaster Close
    KT2 5NH Kingston Upon Thames
    Surrey
    British57537170003
    TAYLOR, Michael John
    109 Hallowell Road
    HA6 1DY Northwood
    Middlesex
    Segretario
    109 Hallowell Road
    HA6 1DY Northwood
    Middlesex
    British75861690001
    AAB, Richard Thomas
    29 Woodstone Rise
    Pittsford Ny
    Monroe 14534
    Usa
    Amministratore
    29 Woodstone Rise
    Pittsford Ny
    Monroe 14534
    Usa
    Usa24491620001
    ANNUNZIATA, Robert
    17 Red Coach Lane
    Holmdel New Jersey
    FOREIGN 07733 Usa
    Amministratore
    17 Red Coach Lane
    Holmdel New Jersey
    FOREIGN 07733 Usa
    American67397090001
    ATKINSON, Robert
    79 Laurel Drive New Providence
    New Jersey 07974
    FOREIGN Usa
    Amministratore
    79 Laurel Drive New Providence
    New Jersey 07974
    FOREIGN Usa
    American59683820001
    BANTOFT, Christopher
    Titcheners Cotmandene
    RH4 2BN Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Titcheners Cotmandene
    RH4 2BN Dorking
    Surrey
    British8884090001
    BANTOFT, Christopher
    Titcheners Cotmandene
    RH4 2BN Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Titcheners Cotmandene
    RH4 2BN Dorking
    Surrey
    British8884090001
    BROWN, Kevin Thomas
    30 Harts Grove
    IG8 0BN Woodford Green
    Essex
    Amministratore delegato nominato
    30 Harts Grove
    IG8 0BN Woodford Green
    Essex
    EnglandBritish900008020001
    CHESONIS, Arunas Antanas
    18 Buckthorn Run
    Victor
    New York 14564
    Usa
    Amministratore
    18 Buckthorn Run
    Victor
    New York 14564
    Usa
    Usa24491630002
    COLEMAN, Francis David Roughton
    7132 Gillis Road
    Victor
    FOREIGN New York 14564
    Usa
    Amministratore
    7132 Gillis Road
    Victor
    FOREIGN New York 14564
    Usa
    American21508600001
    DALEY, Michael Robert
    388 Raspberry Patch Drive
    Rochester
    New York 14612
    Usa
    Amministratore
    388 Raspberry Patch Drive
    Rochester
    New York 14612
    Usa
    Usa24491640002
    DESOCIO, Walter Gerard
    27 Pembridge Crescent
    W11 3DS London
    Amministratore
    27 Pembridge Crescent
    W11 3DS London
    American53113210002
    HOYLE, Christopher Rowland Benn
    18 St Gabriels Lea
    Chineham
    RG24 8RE Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    18 St Gabriels Lea
    Chineham
    RG24 8RE Basingstoke
    Hampshire
    British21508610001
    JEPHCOTT, Richard John Michael
    69 Redditch Road
    B60 4JP Bromsgrove
    Worcestershire
    Amministratore
    69 Redditch Road
    B60 4JP Bromsgrove
    Worcestershire
    United KingdomBritish111983390001
    LANIAK, David Konstantyn
    10 Harvest Lane
    Rush
    New York 14543
    Usa
    Amministratore
    10 Harvest Lane
    Rush
    New York 14543
    Usa
    Usa46518740001
    MACFARLANE, James Allan Colquhoun
    2 Nobury Hill
    WR7 4HA Inkberrow
    Worcestershire
    Amministratore
    2 Nobury Hill
    WR7 4HA Inkberrow
    Worcestershire
    United KingdomBritish8615900001
    RENDELL, Simon
    56 Ailsa Avenue
    St Margarets
    TW1 1NG London
    Amministratore
    56 Ailsa Avenue
    St Margarets
    TW1 1NG London
    Welsh35550770001
    SAYERS, Richard Ervin
    108 Holiday Harbour
    FOREIGN Canandaigua Ny
    Ontario 14424
    Usa
    Amministratore
    108 Holiday Harbour
    FOREIGN Canandaigua Ny
    Ontario 14424
    Usa
    Usa25013020001
    SCARPATI, John
    26 Jefferson Court Freehold
    New Jersey 07728
    FOREIGN Usa
    Amministratore
    26 Jefferson Court Freehold
    New Jersey 07728
    FOREIGN Usa
    American59683690001
    WILLSHIRE, Raymond Gordon Gorie
    Four Oaks 38 Tilbury Road
    CO9 4JG Great Yeldham
    Essex
    Amministratore
    Four Oaks 38 Tilbury Road
    CO9 4JG Great Yeldham
    Essex
    British85912750001

    WORLDXCHANGE COMMUNICATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge
    Creato il 24 feb 2000
    Consegnato il 25 feb 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the interconnection agreement (as defined therein) and under the charge on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge all plant machinery vehicles computers office and other equipment and the benefit of all contracts licences and warranties relating to the same and all rights and interests of the company in and claims under all policies of insurance relating to the charged property and all proceeds thereof either now or in the future held by,or written in favour of,the company or in which the company is otherwise interested.
    Persone aventi diritto
    • British Telecommunications PLC
    Transazioni
    • 25 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Second amended and restated intercompany subordination agreement
    Creato il 19 dic 1997
    Consegnato il 07 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as the adminstrative agent for the lenders (as defined) or to any lender under the credit agreement or any other loan document (as defined in the credit agreement) and including each of the credit agreement and all other documents entered into pursuant thereto
    Brevi particolari
    The company has assigned and pledged all it's right title and interest in.to and under each such intercompany note and the proceeds thereof and all benefits and advantages to be derived therefrom relating to such intercompany note please refer to form 395 for full details of charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • First Union National Bank
    Transazioni
    • 07 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Pledge agreement
    Creato il 19 dic 1997
    Consegnato il 07 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to first union national bank acting as agent and trustee for itself and the lenders (as defined) on any account whatsoever under or in connection with the loan documents (as defined in the credit agreement)
    Brevi particolari
    The 250,000 performance shares of £1 each and 1,000 ordinary shares of 10P each of which 400 are clasified as 'a'shares and 600 are clasified as 'b' shares in united telecom limited together with all rights benefits and dividends accruing therefrom please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • First Union National Bank
    Transazioni
    • 07 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second amended and restated debenture
    Creato il 19 dic 1997
    Consegnato il 07 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to first union national bank acting as agent and trustee for itself and the lenders (as defined) on any account whatsoever under or in connection with the loan documents (as defined in the credit agreement)
    Brevi particolari
    All estates or interest in any f/h or l/h property,all securities,all plant machinery and other equipment,all of the insurances all rights under any documents and agreements,letters of credit,present and future licences all present and future uncalled capital for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • First Union National Bank
    Transazioni
    • 07 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 05 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Amended & restated intercompany subordination agreement made between acc corp., Acc long distance corp., Acc national telecom corp., Acc radio corp., Acc national long distance corp., Acc long distance of massachusetts corp., Acc global corp., Acc telenterprises LTD & the company
    Creato il 14 gen 1997
    Consegnato il 29 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations owed to first union national bank of north carolina as the administrative agent or any lender under the credit agreement or any other loan document (as defined in the credit agreement, and including each of the credit agreement and the agreement and all other documents entered into pursuant to the credit agreement) by any of the intercompany loan parties (the "senior indebtedness")
    Brevi particolari
    By clause 1.01 of the agreement the company for itself and its successors has agreed that to the extent it is from time to time entitled to receive payment in respect of any intercompany loan advance or other account from any other intercompany loan party (each an "intercompany note")including without limitation in respect of any intercompany obligation evidenced by the specific intercompany notes (as defined herein) (a "subordinanted obligation") the payment of the principal of premium if any interest on (including all interest accruing thereon subsequent to a bankruptcy event (as defined herein) ("post-peteition interest")) or other fees costs expenses and any other amounts accrued incurred or otherwise due in connection with all such subordinanted obligations from time to time will be subordinated in right of payment to the extent and in the manner provided herein to the payment in full of all senior indebtedness.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • First Union National Bank of North Carolina as Administrative Agent for the Lenders
    Transazioni
    • 29 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Amended and restated debenture
    Creato il 14 gen 1997
    Consegnato il 29 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the "loan documents" (as defined in the debenture)
    Brevi particolari
    Together with the "specific mortgaged property" (as defined in the deed). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • First Union National Bank of North Carolina(Acting as Agent and Trustee for Itself and Thelenders)
    Transazioni
    • 29 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 10 ott 1995
    Consegnato il 12 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The rent and other monies due from the company to the chargee contained in a lease of the ground floor,114A cromwell road,london SW7 of even date
    Brevi particolari
    £44,062.50.
    Persone aventi diritto
    • Cromwell Road Investments Limited
    Transazioni
    • 12 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 lug 1995
    Consegnato il 29 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due from the company to the chargees pursuant to the terms of the loan documents (as defined in the credit agreement ) together with all other documents entered into pursuant to the credit agreement
    Brevi particolari
    Lease dated 27/10/93 granted by cromwell investments limited in favour ofthe company relating to lower ground floor 114A cromwell road london. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • First Union National Bank of North Carolina as Agent and Trustee for Itself and the Lenders (Asdefined)
    Transazioni
    • 29 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 06 giu 1995
    Consegnato il 19 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the obligations of the company to the chargee contained in a lease dated 6TH june 1995
    Brevi particolari
    The sum of £51,964.00 deposited with national westminster bank PLC of 15 bishopsgate london EC2P in an account designated chiswick 1 and 2.
    Persone aventi diritto
    • Ibm United Kingdom Limited
    Transazioni
    • 19 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 03 giu 1994
    Consegnato il 14 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the obligations of the company to the chargee contained in a lease dated 3RD june 1994
    Brevi particolari
    The sum of £53,625 deposited with national westminster bank PLC.
    Persone aventi diritto
    • Ibm United Kingdom Limited
    Transazioni
    • 14 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    WORLDXCHANGE COMMUNICATIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    02 mag 2001Inizio dell'amministrazione
    23 dic 2009Amministrazione scaricata
    Ordine di amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Michael John Andrew Jervis
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Praticante
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Malcolm Brian Shierson
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Praticante
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    2
    DataTipo
    22 gen 2002Data della riunione per approvare il CVA
    19 gen 2010Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ipe Jacobs
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Praticante
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Michael John Andrew Jervis
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Praticante
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    3
    DataTipo
    28 lug 2010Data di scioglimento
    08 ott 2009Data della petizione
    15 apr 2010Conclusione della liquidazione
    10 dic 2009Inizio della liquidazione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praticante
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0