INTERCARE HOLDINGS LIMITED

INTERCARE HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàINTERCARE HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02672502
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di INTERCARE HOLDINGS LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova INTERCARE HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o EVERSHEDS LLP
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di INTERCARE HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NOTIONFINISH LIMITED02 gen 199202 gen 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di INTERCARE HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per INTERCARE HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    5 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 03 mar 2011

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Eversheds Llp Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES United Kingdom in data 10 gen 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 02 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 gen 2011

    Stato del capitale al 10 gen 2011

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Bampton Road Harold Hill Romford Essex RM3 8UG in data 10 gen 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 02 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di Andrew Oades come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Martin Sillitto come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Anthony Knight come segretario

    2 pagineTM02

    Nomina di Jorge Mario Gomez Agudelo come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 giu 2009

    11 pagineAA

    Bilancio redatto al 30 giu 2008

    11 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 giu 2007

    12 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 giu 2006

    11 pagineAA

    legacy

    8 pagine363s

    Chi sono gli amministratori di INTERCARE HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AGUDELO, Jorge Mario Gomez
    7000 Cardinal Place
    Dublin
    Cardinal Health
    Ohio 43017
    United States
    Amministratore
    7000 Cardinal Place
    Dublin
    Cardinal Health
    Ohio 43017
    United States
    UsaColombianNone119495610001
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    5 Thorntons Dale
    Newlaithes Road Horsforth
    LS18 4UW Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    5 Thorntons Dale
    Newlaithes Road Horsforth
    LS18 4UW Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director47388900001
    KNIGHT, Anthony
    122 Ongar Road
    Writtle
    CM1 3NX Chelmsford
    Essex
    Segretario
    122 Ongar Road
    Writtle
    CM1 3NX Chelmsford
    Essex
    British126965310001
    LOFTHOUSE, Stephen David
    Windsor House
    Cornwall Road
    HG1 2PW Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    Windsor House
    Cornwall Road
    HG1 2PW Harrogate
    North Yorkshire
    BritishChartered Accountant111617880001
    UTTLEY, Robert David
    Shaw Cottage
    Langfield
    OL14 6HP Todmorden
    Lancashire
    Segretario
    Shaw Cottage
    Langfield
    OL14 6HP Todmorden
    Lancashire
    BritishFinancial Consultant37892760001
    VICARY, Gary Kevin
    Desborough Manorial Road
    Parkgate
    CH64 6QN Neston
    Wirral
    Segretario
    Desborough Manorial Road
    Parkgate
    CH64 6QN Neston
    Wirral
    British18943850005
    WEST, David William
    10 Brindles
    RM11 2RU Hornchurch
    Essex
    Segretario
    10 Brindles
    RM11 2RU Hornchurch
    Essex
    EnglishFinance Director18533210002
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Segretario
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    COWAN, Peter Lawrence
    Flat 1 Hazelfields
    Delamere
    WA14 2NG Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Flat 1 Hazelfields
    Delamere
    WA14 2NG Altrincham
    Cheshire
    BritishCompany Director42077520001
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    5 Thorntons Dale
    Newlaithes Road Horsforth
    LS18 4UW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    5 Thorntons Dale
    Newlaithes Road Horsforth
    LS18 4UW Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director47388900001
    GARSTON, Clive Richard
    Sandy Ridge
    Bollinway Hale
    WA15 0NZ Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Sandy Ridge
    Bollinway Hale
    WA15 0NZ Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritishSolicitor12179600001
    KAY, Andrew George
    9 Back Lane
    Whixley Gate
    YO26 8BG Whixley
    Yorkshire
    Amministratore
    9 Back Lane
    Whixley Gate
    YO26 8BG Whixley
    Yorkshire
    BritishOperations Director41347920003
    LOFTHOUSE, Stephen David
    Windsor House
    Cornwall Road
    HG1 2PW Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Windsor House
    Cornwall Road
    HG1 2PW Harrogate
    North Yorkshire
    BritishChartered Accountant111617880001
    OADES, Andrew Giovanni
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Cardinal Health
    Essex
    Amministratore
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Cardinal Health
    Essex
    United KingdomBritishManaging Director108839700002
    PARKER, John Francis
    Beck House 10 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Beck House 10 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishDirector47002780001
    SHEPHERD, Robert Priestley
    Woodcliffe Horncliffe
    BB4 6JS Rossendale
    Lancashire
    Amministratore
    Woodcliffe Horncliffe
    BB4 6JS Rossendale
    Lancashire
    BritishCompany Director8802110001
    SILLITTO, Martin
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Cardinal Health
    Essex
    Amministratore
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Cardinal Health
    Essex
    United KingdomBritishPharmascist126965260002
    TAYLOR, Malcolm Archibald, Dr
    Windsor House
    Cornwall Road
    NG1 2PW Harrowgate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Windsor House
    Cornwall Road
    NG1 2PW Harrowgate
    North Yorkshire
    BritishManaging Director111617640001
    UTTLEY, Robert David
    Shaw Cottage
    Langfield
    OL14 6HP Todmorden
    Lancashire
    Amministratore
    Shaw Cottage
    Langfield
    OL14 6HP Todmorden
    Lancashire
    EnglandBritishFinancial Consultant37892760001
    VICARY, Gary Kevin
    481 Didsbury Road
    Heaton Mersey
    SK3 3AY Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    481 Didsbury Road
    Heaton Mersey
    SK3 3AY Stockport
    Cheshire
    BritishAccountant18943850001
    WEST, David William
    10 Brindles
    RM11 2RU Hornchurch
    Essex
    Amministratore
    10 Brindles
    RM11 2RU Hornchurch
    Essex
    EnglandEnglishFinance Director18533210002
    WITHERS, Rees
    The Shenfield
    Chelford Road
    WA16 8LU Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    The Shenfield
    Chelford Road
    WA16 8LU Knutsford
    Cheshire
    BritishCompany Director59651580001

    INTERCARE HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 09 ott 2002
    Consegnato il 24 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties)
    Transazioni
    • 24 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share pledge agreement
    Creato il 08 ott 2002
    Consegnato il 25 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the pledgors to the chargee in its capacity as agent, rbscs, and the lenders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The 3.321 shares inclusive that they currently hold in pharmapar sa/nv any cash return on the shares (whether in the form of dividends declared out of retained earnings or reserves repayment of capital scripts or otherwise) the shares resulting from the exercise of any subscription right to be treated as coming within the definition of the shares (together the pledged assets). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 ott 1999
    Consegnato il 27 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All and any obligations and liabilities (whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of the company to any of the secured parties (as defined) under or in connection with any of the financing documents (as defined) on the date therefor in the manner provided in the relevant financing documents
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC,as Security Trustee
    Transazioni
    • 27 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of pledge of shares
    Creato il 12 ott 1999
    Consegnato il 27 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys,obligations and liabilities due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee under or pursuant to any of the documents (as defined)
    Brevi particolari
    The original shares and voting rights and dividends thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC,as Security Trustee for and on Behalf of the Banks Pursuant Tothe Credit Agreement (As Defined) and Lombard Natwest Discounting Limited
    Transazioni
    • 27 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 12 ott 1999
    Consegnato il 27 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the discounting documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard Natwest Discounting Limited
    Transazioni
    • 27 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 10 nov 1998
    Consegnato il 17 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Postponement and assignment of claim
    Creato il 20 nov 1995
    Consegnato il 22 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All debts/liabilities ................and all dividends/other sums payable; all rights/claims.....etc.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Canada
    Transazioni
    • 22 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    INTERCARE HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 mar 2011Inizio della liquidazione
    19 apr 2012Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Laura May Waters
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0